FCC ENERGY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFCC ENERGY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC069253
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FCC ENERGY LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe FCC ENERGY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FCC ENERGY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TAWSE ELLON (HAULAGE) LIMITED31 août 197931 août 1979

    Quels sont les derniers comptes de FCC ENERGY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour FCC ENERGY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Greengairs Landfill Meikle Drumgray Greengairs Airdrie Lanarkshire ML6 7TD le 29 nov. 2012

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 20 nov. 2012

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 juil. 2012

    État du capital au 23 juil. 2012

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Mrs Victoria Bunton en tant que secrétaire le 26 oct. 2011

    1 pagesAP03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Caterina De Feo en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Certificat de changement de nom

    Company name changed tawse ellon (haulage) LIMITED\certificate issued on 06/09/10
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name06 sept. 2010

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Leslie Cassells en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Meredith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Taylor en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    7 pagesAA

    Statuts

    7 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    8 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de FCC ENERGY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BUNTON, Victoria
    Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    4
    Secrétaire
    Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    4
    164512140001
    FAVIER TILSTON, Claire
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British117647490002
    ORTS-LLOPIS, Vicente Federico
    900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West
    Administrateur
    900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West
    United KingdomSpanish147551840001
    TAYLOR, Paul
    Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    4
    Administrateur
    Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    4
    United KingdomBritish147757950001
    BOLTON, Jonathan Mark
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British15931960007
    CALDER, Samantha Jane
    Cowslip Cottage
    Roade Hill Ashton
    NN7 2JH Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Cowslip Cottage
    Roade Hill Ashton
    NN7 2JH Northampton
    Northamptonshire
    British75830790003
    CANNON, Sara Philipa
    15 Weathercock Lane
    MK17 8NP Woburn Sands
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    15 Weathercock Lane
    MK17 8NP Woburn Sands
    Buckinghamshire
    British223577480001
    DE FEO, Caterina
    Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West, 900
    United Kingdom
    Secrétaire
    Pavilion Drive
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West, 900
    United Kingdom
    Italian140556050001
    HARDMAN, Steven Neville
    The Wing Jaggards House
    Jaggards Lane Neston
    SN13 9SF Corsham
    Wiltshire
    Secrétaire
    The Wing Jaggards House
    Jaggards Lane Neston
    SN13 9SF Corsham
    Wiltshire
    British93743250001
    KING, Jane Leslie
    The Old Sty
    Alderton
    NN12 7LN Towcester
    Northamptonshire
    Secrétaire
    The Old Sty
    Alderton
    NN12 7LN Towcester
    Northamptonshire
    British66970590001
    TAWSE, Albert Massie
    2 Mackie Place
    AB1 1PF Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    2 Mackie Place
    AB1 1PF Aberdeen
    Aberdeenshire
    British207520003
    WATERHOUSE, Alan
    2a Norwood Grove
    Birkenshaw
    BD11 2NP Bradford
    West Yorkshire
    Secrétaire
    2a Norwood Grove
    Birkenshaw
    BD11 2NP Bradford
    West Yorkshire
    British24588340001
    AVERILL, Michael Charles Edward
    Fir Tree House 61 Chiltern Road
    Long Crendon
    HP18 9BZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Fir Tree House 61 Chiltern Road
    Long Crendon
    HP18 9BZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    British24913560001
    BURNS, Phillip Wesley
    Flat 15
    12 Bourchier Street
    W1D 4HZ London
    Administrateur
    Flat 15
    12 Bourchier Street
    W1D 4HZ London
    United KingdomBritish160550800001
    CASSELLS, Leslie James Davidson
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British95347040005
    CLARKE, Michael James
    Derwen House
    Kibblestone Road
    ST15 8UJ Stone
    Staffordshire
    Administrateur
    Derwen House
    Kibblestone Road
    ST15 8UJ Stone
    Staffordshire
    EnglandBritish154591790014
    DOWNES, David John
    Holden Brook
    New Barn Lane
    RH5 5PF Ockley
    Surrey
    Administrateur
    Holden Brook
    New Barn Lane
    RH5 5PF Ockley
    Surrey
    United KingdomBritish37289200002
    HARDMAN, Steven Neville
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Ground Floor West 900 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Northamptonshire
    British93743250006
    MEREDITH, James Robert
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    Administrateur
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    British29339860005
    MEREDITH, James Robert
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    Administrateur
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7RG Northampton
    Ground Floor West 900
    Northamptonshire
    British29339860005
    STEWART, Quentin Richard
    The Lodge
    106 Aberdeen Park Islington
    N5 2BA London
    Administrateur
    The Lodge
    106 Aberdeen Park Islington
    N5 2BA London
    British94880800001
    TAWSE, Colin Robert
    Kinharrachie House
    AB41 8PP Ellon
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Kinharrachie House
    AB41 8PP Ellon
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish207530001
    TAWSE, Isobel Mary
    Denebank
    AB4 9 Ellon
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Denebank
    AB4 9 Ellon
    Aberdeenshire
    British207540001

    FCC ENERGY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 26 août 2004
    Livré le 10 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 10 sept. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 26 août 2004
    Livré le 01 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 sept. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 janv. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 26 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 12 juil. 2004
    Livré le 16 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee
    Transactions
    • 16 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 05 juil. 2004
    Livré le 20 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over any property; various fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 20 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 24 déc. 1999
    Livré le 10 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Farms of wester hatton and blackdog and wester hatton farmhouse, balmedie, aberdeenshire.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 10 janv. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 18 nov. 1999
    Livré le 25 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 25 nov. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 15 déc. 1995
    Livré le 22 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Wester hatton farmhouse, balmedie, aberdeenshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 déc. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 mars 1993
    Livré le 05 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Wester hatton and blackdog farms, parish of belhelvie, county of aberdeen(see paper apart to document).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 mars 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 20 mai 1986
    Livré le 02 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 juin 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    FCC ENERGY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    15 juil. 2013Dissolved on
    20 nov. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    practitioner
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0