SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC069292 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 272 Bath Street G2 4JR Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 nov. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2019 | 4 pages | AA | ||||||||||
État du capital au 08 juil. 2020
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Michael Bedford en tant qu'administrateur le 06 janv. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Amanda Louise Larnder en tant que directeur le 06 janv. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Amanda Louise Larnder le 01 janv. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Claire Susan Stewart le 01 janv. 2020 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2018 | 4 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Eversheds Llp 3-5 Melville Street Edinburgh EH3 7PE à 272 Bath Street Glasgow G2 4JR le 02 mai 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Amanda Louise Larnder en tant qu'administrateur le 18 avr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Beswick en tant que directeur le 18 avr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Gerald Goodwin en tant que directeur le 18 avr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Claire Susan Stewart en tant que secrétaire le 04 mars 2019 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Beswick en tant que secrétaire le 04 mars 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Beswick en tant qu'administrateur le 30 nov. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Beswick en tant que secrétaire le 30 nov. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael James Stilwell en tant que directeur le 30 nov. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEWART, Claire Susan | Secrétaire | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | 255934220001 | |||||||
| BEDFORD, David Michael | Administrateur | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | England | British | 302295360001 | |||||
| BESWICK, Simon | Secrétaire | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | 253074600001 | |||||||
| BRIERLEY, Richard Paul | Secrétaire | c/o Eversheds Llp Melville Street EH3 7PE Edinburgh 3-5 | 209316370001 | |||||||
| GERAGHTY, Paul Kevin Ian | Secrétaire | Monkwood Cottage Whitakers Way IG10 1SQ Loughton Essex | British | 86029660001 | ||||||
| HISCOCK, Bruce Edward Heath | Secrétaire | 2 Webbs Cottages The Green RG29 1HF North Warnborough Hampshire | British | 74922870001 | ||||||
| POULTNEY, Nigel Charles | Secrétaire | 4 Holt Road B80 7NX Studley Warwickshire | British | 8488600002 | ||||||
| STILWELL, Michael James | Secrétaire | c/o Eversheds Llp Melville Street EH3 7PE Edinburgh 3-5 | 245078530001 | |||||||
| WESTCOTT, Angela | Secrétaire | 5 Woodfield Drive SL6 4NX Maidenhead Berkshire | British | 394110001 | ||||||
| BESWICK, Simon | Administrateur | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | Scotland | British | 133770010001 | |||||
| BRIERLEY, Richard Paul | Administrateur | c/o Eversheds Llp Melville Street EH3 7PE Edinburgh 3-5 | United Kingdom | British | 209175910001 | |||||
| CHITTENDEN, Keith Alan | Administrateur | Red Lion House Church End Stebbing CM6 3SW Dunmow Essex | British | 9117860001 | ||||||
| GERAGHTY, Paul Kevin Ian | Administrateur | Monkwood Cottage Whitakers Way IG10 1SQ Loughton Essex | United Kingdom | British | 86029660001 | |||||
| GOODWIN, Mark Gerald | Administrateur | c/o Eversheds Llp Melville Street EH3 7PE Edinburgh 3-5 | England | British | 233845210001 | |||||
| HISCOCK, Bruce Edward Heath | Administrateur | 2 Webbs Cottages The Green RG29 1HF North Warnborough Hampshire | United Kingdom | British | 74922870001 | |||||
| KIRTLAND, John Philip | Administrateur | 4 Kingfisher House Dedmere Road SL7 1PG Marlow Buckinghamshire | England | British | 86087080001 | |||||
| LARNDER, Amanda Louise | Administrateur | 3-4 Broadfield Close S8 0XN Sheffield Synectics House England | England | British | 257818550001 | |||||
| MOIR, William John Wallace | Administrateur | Shrublands Lockhampton Hill GL53 9QJ Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 394130001 | |||||
| POULTNEY, Nigel Charles | Administrateur | 4 Holt Road B80 7NX Studley Warwickshire | England | British | 8488600002 | |||||
| ROGERS, Victor Joseph | Administrateur | 3 The Green Letchmore Heath WD2 8ER Watford Hertfordshire | British | 394140001 | ||||||
| SHEPHERD, John, Mr. | Administrateur | 3-5 Melville Street EH3 7PE Edinburgh C/O Evershields Llp | United Kingdom | British | 151588320001 | |||||
| SINGLETON, Russell Craig | Administrateur | 417 Whirlowdale Road S11 9NG Sheffield South Yorkshire | England | British | 3492940001 | |||||
| SMITH, John Ernest | Administrateur | 10 Bearswood End HP9 2NR Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 1246220002 | |||||
| STILWELL, Michael James | Administrateur | c/o Eversheds Llp Melville Street EH3 7PE Edinburgh 3-5 Scotland | England | British | 194783340001 | |||||
| WESTCOTT, Angela | Administrateur | 5 Woodfield Drive SL6 4NX Maidenhead Berkshire | British | 394110001 | ||||||
| WESTCOTT, Robert William | Administrateur | 5 Woodfield Drive SL6 4NX Maidenhead Berkshire | British | 394120001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protec Plc | 06 avr. 2016 | 88 Birmingham Road B80 7AS Studley Studley Point England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Créé le 17 févr. 2003 Livré le 25 févr. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over cash deposit | Créé le 26 mars 2002 Livré le 03 avr. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due in terms of facility letter | |
Brèves mentions The account (denominated in whatever currency) of the company with the bank of scotland treasury services PLC at 155 bishopsgate, london designated managers obligations o/a security design associates (1979) limited as the same may be replaced, redesignated, renumbered or rearranged from time to time. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 12 mars 2001 Livré le 15 mars 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 12 mars 2001 Livré le 15 mars 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 10 déc. 1996 Livré le 27 déc. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti £7,875 | |
Brèves mentions The rent deposit account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 12 sept. 1990 Livré le 01 oct. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of charge | Créé le 06 janv. 1986 Livré le 13 janv. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All moneys standing at credit with the bank in name of the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0