SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED

SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC069292
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    272 Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2019

    4 pagesAA

    État du capital au 08 juil. 2020

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr David Michael Bedford en tant qu'administrateur le 06 janv. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Amanda Louise Larnder en tant que directeur le 06 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Amanda Louise Larnder le 01 janv. 2020

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Claire Susan Stewart le 01 janv. 2020

    1 pagesCH03

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 30 nov. 2018

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de C/O Eversheds Llp 3-5 Melville Street Edinburgh EH3 7PE à 272 Bath Street Glasgow G2 4JR le 02 mai 2019

    1 pagesAD01

    Nomination de Mrs Amanda Louise Larnder en tant qu'administrateur le 18 avr. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Simon Beswick en tant que directeur le 18 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Gerald Goodwin en tant que directeur le 18 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Claire Susan Stewart en tant que secrétaire le 04 mars 2019

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Simon Beswick en tant que secrétaire le 04 mars 2019

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Simon Beswick en tant qu'administrateur le 30 nov. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Simon Beswick en tant que secrétaire le 30 nov. 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Michael James Stilwell en tant que directeur le 30 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STEWART, Claire Susan
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    Secrétaire
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    255934220001
    BEDFORD, David Michael
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    Administrateur
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    EnglandBritish302295360001
    BESWICK, Simon
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    Secrétaire
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    253074600001
    BRIERLEY, Richard Paul
    c/o Eversheds Llp
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5
    Secrétaire
    c/o Eversheds Llp
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5
    209316370001
    GERAGHTY, Paul Kevin Ian
    Monkwood Cottage
    Whitakers Way
    IG10 1SQ Loughton
    Essex
    Secrétaire
    Monkwood Cottage
    Whitakers Way
    IG10 1SQ Loughton
    Essex
    British86029660001
    HISCOCK, Bruce Edward Heath
    2 Webbs Cottages
    The Green
    RG29 1HF North Warnborough
    Hampshire
    Secrétaire
    2 Webbs Cottages
    The Green
    RG29 1HF North Warnborough
    Hampshire
    British74922870001
    POULTNEY, Nigel Charles
    4 Holt Road
    B80 7NX Studley
    Warwickshire
    Secrétaire
    4 Holt Road
    B80 7NX Studley
    Warwickshire
    British8488600002
    STILWELL, Michael James
    c/o Eversheds Llp
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5
    Secrétaire
    c/o Eversheds Llp
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5
    245078530001
    WESTCOTT, Angela
    5 Woodfield Drive
    SL6 4NX Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    5 Woodfield Drive
    SL6 4NX Maidenhead
    Berkshire
    British394110001
    BESWICK, Simon
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    Administrateur
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    ScotlandBritish133770010001
    BRIERLEY, Richard Paul
    c/o Eversheds Llp
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5
    Administrateur
    c/o Eversheds Llp
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5
    United KingdomBritish209175910001
    CHITTENDEN, Keith Alan
    Red Lion House Church End
    Stebbing
    CM6 3SW Dunmow
    Essex
    Administrateur
    Red Lion House Church End
    Stebbing
    CM6 3SW Dunmow
    Essex
    British9117860001
    GERAGHTY, Paul Kevin Ian
    Monkwood Cottage
    Whitakers Way
    IG10 1SQ Loughton
    Essex
    Administrateur
    Monkwood Cottage
    Whitakers Way
    IG10 1SQ Loughton
    Essex
    United KingdomBritish86029660001
    GOODWIN, Mark Gerald
    c/o Eversheds Llp
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5
    Administrateur
    c/o Eversheds Llp
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5
    EnglandBritish233845210001
    HISCOCK, Bruce Edward Heath
    2 Webbs Cottages
    The Green
    RG29 1HF North Warnborough
    Hampshire
    Administrateur
    2 Webbs Cottages
    The Green
    RG29 1HF North Warnborough
    Hampshire
    United KingdomBritish74922870001
    KIRTLAND, John Philip
    4 Kingfisher House
    Dedmere Road
    SL7 1PG Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    4 Kingfisher House
    Dedmere Road
    SL7 1PG Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish86087080001
    LARNDER, Amanda Louise
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    Administrateur
    3-4 Broadfield Close
    S8 0XN Sheffield
    Synectics House
    England
    EnglandBritish257818550001
    MOIR, William John Wallace
    Shrublands
    Lockhampton Hill
    GL53 9QJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Shrublands
    Lockhampton Hill
    GL53 9QJ Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish394130001
    POULTNEY, Nigel Charles
    4 Holt Road
    B80 7NX Studley
    Warwickshire
    Administrateur
    4 Holt Road
    B80 7NX Studley
    Warwickshire
    EnglandBritish8488600002
    ROGERS, Victor Joseph
    3 The Green
    Letchmore Heath
    WD2 8ER Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    3 The Green
    Letchmore Heath
    WD2 8ER Watford
    Hertfordshire
    British394140001
    SHEPHERD, John, Mr.
    3-5 Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    C/O Evershields Llp
    Administrateur
    3-5 Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    C/O Evershields Llp
    United KingdomBritish151588320001
    SINGLETON, Russell Craig
    417 Whirlowdale Road
    S11 9NG Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    417 Whirlowdale Road
    S11 9NG Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish3492940001
    SMITH, John Ernest
    10 Bearswood End
    HP9 2NR Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    10 Bearswood End
    HP9 2NR Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish1246220002
    STILWELL, Michael James
    c/o Eversheds Llp
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5
    Scotland
    Administrateur
    c/o Eversheds Llp
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5
    Scotland
    EnglandBritish194783340001
    WESTCOTT, Angela
    5 Woodfield Drive
    SL6 4NX Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    5 Woodfield Drive
    SL6 4NX Maidenhead
    Berkshire
    British394110001
    WESTCOTT, Robert William
    5 Woodfield Drive
    SL6 4NX Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    5 Woodfield Drive
    SL6 4NX Maidenhead
    Berkshire
    British394120001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Protec Plc
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    England
    06 avr. 2016
    88 Birmingham Road
    B80 7AS Studley
    Studley Point
    England
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementEnglish Register Of Companies
    Numéro d'enregistrement2876304
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) ont le droit d'exercer, ou exercent effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    SECURITY DESIGN ASSOCIATES (1979) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 17 févr. 2003
    Livré le 25 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 25 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Charge over cash deposit
    Créé le 26 mars 2002
    Livré le 03 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of facility letter
    Brèves mentions
    The account (denominated in whatever currency) of the company with the bank of scotland treasury services PLC at 155 bishopsgate, london designated managers obligations o/a security design associates (1979) limited as the same may be replaced, redesignated, renumbered or rearranged from time to time.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 12 mars 2001
    Livré le 15 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 mars 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 12 mars 2001
    Livré le 15 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 mars 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Rent deposit deed
    Créé le 10 déc. 1996
    Livré le 27 déc. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £7,875
    Brèves mentions
    The rent deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Montgomery Property Investments Limited
    Transactions
    • 27 déc. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 oct. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 12 sept. 1990
    Livré le 01 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 24 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Letter of charge
    Créé le 06 janv. 1986
    Livré le 13 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All moneys standing at credit with the bank in name of the company.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    • 24 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0