BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED

BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC070250
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BDO LLP
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    legacy

    3 pagesMG03s

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    3 pagesMG03s

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2011

    10 pagesAA

    Nomination de Mr Barry John Head en tant qu'administrateur le 08 déc. 2011

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Warwick Lawrence en tant que directeur le 17 oct. 2011

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 mai 2011

    État du capital au 13 mai 2011

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de Jenna House, 6 Mollins Court Westfield Industrial Estate Cumbernauld Glasgow G68 9HP le 26 mars 2010

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    15 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    16 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2007

    8 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages225

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BATH, Kameljit
    111 Linceslade Grove
    MK5 8AD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    111 Linceslade Grove
    MK5 8AD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British93238530001
    HEAD, Barry John
    c/o Crown Products (Kent) Ltd
    Eddington Lane
    CT6 5TR Herne Bay
    Eddington Works
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Crown Products (Kent) Ltd
    Eddington Lane
    CT6 5TR Herne Bay
    Eddington Works
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish34360800002
    DONALDSON, Brian James
    4 Pattle Place
    Alloway
    KA7 4PS Ayr
    Ayrshire
    Secrétaire
    4 Pattle Place
    Alloway
    KA7 4PS Ayr
    Ayrshire
    British261950002
    HUTCHINSON, Timothy
    Heron House
    Ranby
    DN22 8HR Retford
    Secrétaire
    Heron House
    Ranby
    DN22 8HR Retford
    British88382490001
    STEEL, Steven John
    16 Thornton Close
    Crick
    NN6 7GE Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    16 Thornton Close
    Crick
    NN6 7GE Northampton
    Northamptonshire
    British109982220001
    CHRISTIE, George Henry
    Cheviot
    10 Little Carron Gardens
    KY16 8QL St. Andrews
    Fife
    Administrateur
    Cheviot
    10 Little Carron Gardens
    KY16 8QL St. Andrews
    Fife
    British64544730001
    DONALDSON, Brian James
    4 Pattle Place
    Alloway
    KA7 4PS Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    4 Pattle Place
    Alloway
    KA7 4PS Ayr
    Ayrshire
    British261950002
    DONALDSON, Rosemary
    4 Pattle Place
    Alloway
    KA7 4PS Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    4 Pattle Place
    Alloway
    KA7 4PS Ayr
    Ayrshire
    British261960002
    HUNTER, David Jeffrey
    7 Wolfe Avenue
    Crookfur
    G77 6TQ Newton Mearns
    Glasgow
    Administrateur
    7 Wolfe Avenue
    Crookfur
    G77 6TQ Newton Mearns
    Glasgow
    ScotlandBritish205080800001
    HUTCHINSON, Timothy
    Heron House
    Ranby
    DN22 8HR Retford
    Administrateur
    Heron House
    Ranby
    DN22 8HR Retford
    United KingdomBritish88382490001
    LAWRENCE, Michael Warwick
    Rectory Grange
    Petsoe End
    MK46 5JL Olney
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Rectory Grange
    Petsoe End
    MK46 5JL Olney
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish33280980005
    STEEL, Steven John
    16 Thornton Close
    Crick
    NN6 7GE Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    16 Thornton Close
    Crick
    NN6 7GE Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish109982220001
    WHITELAW, Alexander John
    Ardbeg
    Barnkittock, Comrie Road
    PH7 4BQ Crieff
    Perth & Kinross
    Administrateur
    Ardbeg
    Barnkittock, Comrie Road
    PH7 4BQ Crieff
    Perth & Kinross
    British88092080001

    BRIAN DONALDSON DISTRIBUTION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 02 mai 2000
    Livré le 10 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The whole monetary and other obligations as contained in the agreement
    Brèves mentions
    All or any debts owing or accruing to the company now or at any time hereafter (and all rights relative thereto) which are or are purported to be subject to the agreement but in respect of which title has not passed to and vested in rbif or to which rbif is not otherwise absolutely entitled and which are or may be from time to time while the charge is in force comprised in the company's property and undertaking.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 10 mai 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 06 sept. 1985
    Livré le 20 sept. 1985
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2 semi-detached factories known as 6 & 8 glenfield road.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 sept. 1985Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 21 août 1985
    Livré le 09 sept. 1985
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    6 & 8 glenfield road, east kilbride.
    Personnes ayant droit
    • East Kilbride Development Corporation
    Transactions
    • 09 sept. 1985Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 20 juin 1983
    Livré le 28 juin 1983
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    8 glenfield rd, east kilbride.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 juin 1983Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 11 sept. 1981
    Livré le 22 sept. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 sept. 1981Enregistrement d'une charge
    • 12 mars 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Letter of offset
    Créé le 19 mai 1980
    Livré le 23 mai 1980
    En cours
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due to the chargee by the company & B.J.D. kitchens & bathrooms LTD
    Brèves mentions
    Balances at credit of any account or accounts in name of brian donaldson distribution LTD. Held by the governor and company of the bank of scotland.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 mai 1980Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0