RHU MARINA UNLIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRHU MARINA UNLIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société SC070772
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RHU MARINA UNLIMITED ?

    • (7415) /
    • (9261) /
    • (9305) /

    Où se situe RHU MARINA UNLIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    Lothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RHU MARINA UNLIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RHU MARINA LIMITED06 mars 198406 mars 1984
    WASTINT LIMITED29 févr. 198029 févr. 1980

    Quels sont les derniers comptes de RHU MARINA UNLIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour RHU MARINA UNLIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 mars 2009

    LRESSP

    Statuts

    2 pagesMA

    legacy

    1 pages122

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Certificat de réimmatriculation de société à responsabilité limitée à société de personnes à responsabilité illimitée

    1 pagesCERT3

    Réenregistrement des statuts

    7 pagesMAR

    legacy

    2 pages49(8)(b)

    legacy

    1 pages49(8)(a)

    legacy

    3 pages49(1)

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de réimmatriculation

    RES02

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    3 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    Qui sont les dirigeants de RHU MARINA UNLIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RANKIN, Alasdair
    454 Lanark Road
    EH14 5BB Edinburgh
    Lothian
    Secrétaire
    454 Lanark Road
    EH14 5BB Edinburgh
    Lothian
    British114667810001
    EVANS, Roy
    11 Sheldon Road
    SS8 7NL Canvey Island
    Essex
    Administrateur
    11 Sheldon Road
    SS8 7NL Canvey Island
    Essex
    EnglandBritish113883890001
    RANKIN, Alasdair
    454 Lanark Road
    EH14 5BB Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    454 Lanark Road
    EH14 5BB Edinburgh
    Lothian
    British114667810001
    FAIRLEY, Peter Lyle
    Armadale
    Rhu
    G84 8NE Helensburgh
    Dunbartonshire
    Secrétaire
    Armadale
    Rhu
    G84 8NE Helensburgh
    Dunbartonshire
    British110890001
    ROBERTSON, James Kirkpatrick
    The Grange
    G84 Helensburgh
    Secrétaire
    The Grange
    G84 Helensburgh
    British110850001
    SCOTT, David James Galloway
    The Garth
    Gartness Road
    G63 9NT Killearn
    Glasgow
    Secrétaire
    The Garth
    Gartness Road
    G63 9NT Killearn
    Glasgow
    British154115310001
    LYCIDAS SECRETARIES LIMITED
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    900003290001
    BLAKE, Ian
    8 Hamilton Road
    EH39 4NA North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    8 Hamilton Road
    EH39 4NA North Berwick
    East Lothian
    British992850001
    DUNDAS, Alan Ralph
    10 Rowmore Quays
    Rhu
    G84 8TA Helensburgh
    Administrateur
    10 Rowmore Quays
    Rhu
    G84 8TA Helensburgh
    ScotlandBritish708940004
    FAIRLEY, Peter Lyle
    Tighcreag
    Armadale Road, Rhu
    G84 8LG Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Tighcreag
    Armadale Road, Rhu
    G84 8LG Helensburgh
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish110890002
    FITZGERALD, Brian J
    14 North Claremont Street
    G3 7LF Glasgow
    Administrateur
    14 North Claremont Street
    G3 7LF Glasgow
    British110900001
    HENDERSON, Timothy James
    Braidhurst Cottage
    Shandon
    G84 8NP Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Braidhurst Cottage
    Shandon
    G84 8NP Helensburgh
    Dunbartonshire
    British110870001
    MARTIN, Eric Harvey
    Midgavin
    Belltrees Road
    PA9 1DL Howwood
    Renfrewshire
    Administrateur
    Midgavin
    Belltrees Road
    PA9 1DL Howwood
    Renfrewshire
    United KingdomBritish321480002
    ROBERTSON, James Kirkpatrick
    The Grange
    G84 Helensburgh
    Administrateur
    The Grange
    G84 Helensburgh
    British110850001
    SCOTT, David James Galloway
    The Garth
    Gartness Road
    G63 9NT Killearn
    Glasgow
    Administrateur
    The Garth
    Gartness Road
    G63 9NT Killearn
    Glasgow
    ScotlandBritish154115310001
    TOURLAMAIN, Gordon Owen
    Ingleby Green
    Artarman Road
    G84 8LQ Rhu
    Dunbartonshire
    Scotland
    Administrateur
    Ingleby Green
    Artarman Road
    G84 8LQ Rhu
    Dunbartonshire
    Scotland
    British26176850001
    WALKER, David Lindsay
    Flat 14 The Limes
    9 Victoria Park Circus
    G12 Glasgow
    Administrateur
    Flat 14 The Limes
    9 Victoria Park Circus
    G12 Glasgow
    British49000002

    RHU MARINA UNLIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Ship mortgage
    Créé le 08 sept. 2003
    Livré le 10 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The vessel pinnocchio.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 10 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 juil. 1999
    Livré le 05 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    9.87 acres at ardenconnel, rhu, dumbarton, under exception... See ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunbartonshire Enterprise
    Transactions
    • 05 août 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mortgage
    Créé le 04 nov. 1998
    Livré le 20 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the vessel "pan drop".
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 janv. 1997
    Livré le 04 févr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land and foreshore of the lands of ardenconnel, rhu, dunbarton. (2) all and whole those subjects being sea bed at gareloch. (3) two pieces of sea bed in gare loch.
    Personnes ayant droit
    • David James Galloway Scott
    Transactions
    • 04 févr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 29 mars 1996
    Livré le 10 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • David James Galloway Scott
    Transactions
    • 10 avr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 16 déc. 1993
    Livré le 29 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 29 déc. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 mai 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 mars 1990
    Livré le 15 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1214 10/100 parts of hectare part of sea bed at rhu dumbartonshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 16 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 mars 1990
    Livré le 15 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    9.87 acres part of land of ardenconnel rhu dumbarton.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 16 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Trust deed
    Créé le 18 mai 1989
    Livré le 24 mai 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 mai 1989Enregistrement d'une charge
    • 29 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 oct. 1982
    Livré le 02 nov. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of land and foreshore extending to 9.87 acres together with the buildings and other erections thereon, to include the pier known as rhu pier in the parish of rhu and county of dumbarton.
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust LTD
    Transactions
    • 02 nov. 1982Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 18 oct. 1982
    Livré le 26 oct. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    9.87 acres of land and foreshore in rhu, dumbarton with all buildings and erections thereon.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 26 oct. 1982Enregistrement d'une charge
    Floating charge
    Créé le 13 oct. 1982
    Livré le 02 nov. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust LTD
    Transactions
    • 02 nov. 1982Enregistrement d'une charge
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 30 avr. 1982
    Livré le 10 mai 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 10 mai 1982Enregistrement d'une charge
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 23 juil. 1981
    Livré le 04 août 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    9.87 acres at rhu marina, rhu dunbartonshire.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 août 1981Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 06 mai 1980
    Livré le 07 mai 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 mai 1980Enregistrement d'une charge

    RHU MARINA UNLIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 févr. 2010Dissolved on
    30 mars 2009Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0