F.I.S. CHEMICALS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéF.I.S. CHEMICALS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC070834
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de F.I.S. CHEMICALS LIMITED ?

    • fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. (20590) / Industries manufacturières

    Où se situe F.I.S. CHEMICALS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Chapel Croft
    Bucksburn
    AB21 9TN Aberdeen
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de F.I.S. CHEMICALS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FRASER INGHAM SHAND CHEMICALS LIMITED07 mars 198007 mars 1980

    Quels sont les derniers comptes de F.I.S. CHEMICALS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le28 févr. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 nov. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 févr. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour F.I.S. CHEMICALS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au14 avr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation28 avr. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au14 avr. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour F.I.S. CHEMICALS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Satisfaction de la charge SC0708340010 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une petite entreprise établis au 29 févr. 2024

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 28 févr. 2023

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 28 févr. 2022

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 28 févr. 2021

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 avr. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Blackwood Partners Llp en tant que secrétaire le 21 janv. 2021

    2 pagesAP04

    Comptes pour une petite entreprise établis au 29 févr. 2020

    12 pagesAA

    Inscription de la charge SC0708340012, créée le 05 nov. 2020

    19 pagesMR01

    Inscription de la charge SC0708340011, créée le 05 nov. 2020

    19 pagesMR01

    Inscription de la charge SC0708340010, créée le 05 nov. 2020

    18 pagesMR01

    Modifications à la charge flottante SC0708340009

    32 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC0708340008

    31 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC0708340007

    31 pages466(Scot)

    Inscription de la charge SC0708340008, créée le 21 oct. 2020

    25 pagesMR01

    Inscription de la charge SC0708340009, créée le 21 oct. 2020

    24 pagesMR01

    Inscription de la charge SC0708340007, créée le 21 oct. 2020

    23 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Daniel Jonathan Halliday en tant que directeur le 26 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Statuts

    13 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Notification de F.I.S. Chemicals Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 oct. 2020

    2 pagesPSC02

    Cessation de la nomination de Thomas Henry Dawson Cummings en tant que directeur le 21 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de F.I.S. CHEMICALS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BLACKWOOD PARTNERS LLP
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    Scotland
    Secrétaire
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    Scotland
    Forme juridiqueLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Type d'identificationAutre personne morale ou société
    Autorité légaleLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    Numéro d'enregistrementSO303063
    278926240001
    DAVIDSON, Gordon
    Chapel Croft
    Bucksburn
    AB21 9TN Aberdeen
    Administrateur
    Chapel Croft
    Bucksburn
    AB21 9TN Aberdeen
    ScotlandBritishDirector275673240001
    WOODS, Kenneth Peter
    Chapel Croft
    Bucksburn
    AB21 9TN Aberdeen
    Administrateur
    Chapel Croft
    Bucksburn
    AB21 9TN Aberdeen
    ScotlandBritishDirector275673250001
    MITCHELL, Lesley
    Dunnydeer Park
    AB52 6GD Insch
    37a
    Aberdeenshire
    Scotland
    Secrétaire
    Dunnydeer Park
    AB52 6GD Insch
    37a
    Aberdeenshire
    Scotland
    British36696260002
    COHEN & CO SOLICITORS
    1 St Swithin Row
    AB10 6DL Aberdeen
    Secrétaire
    1 St Swithin Row
    AB10 6DL Aberdeen
    64783630001
    HM SECRETARIES LIMITED
    Queens Terrace
    AB10 1XL Aberdeen
    6 & 7
    Scotland
    Secrétaire
    Queens Terrace
    AB10 1XL Aberdeen
    6 & 7
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC416621
    166751410001
    CUMMINGS, Thomas Henry Dawson, Prof
    6 Woodcroft Gardens
    Bridge Of Don
    AB22 8DT Aberdeen
    Administrateur
    6 Woodcroft Gardens
    Bridge Of Don
    AB22 8DT Aberdeen
    ScotlandBritishManaging Director824760003
    HALLIDAY, Daniel Jonathan
    Chapel Croft
    Bucksburn
    AB21 9TN Aberdeen
    Administrateur
    Chapel Croft
    Bucksburn
    AB21 9TN Aberdeen
    ScotlandBritishDirector200050290002
    INGHAM, Martin
    3 Woodburn Place
    AB15 8JS Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    3 Woodburn Place
    AB15 8JS Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishSalesman739350001
    SHAND, John Edward
    6 Glenhome Crescent
    Dyce
    AB2 0FE Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    6 Glenhome Crescent
    Dyce
    AB2 0FE Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishSalesman824770001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur F.I.S. CHEMICALS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    F.I.S. Chemicals Holdings Limited
    London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Foresight Group Llp, The Shard, 32
    England
    21 oct. 2020
    London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Foresight Group Llp, The Shard, 32
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement12873071
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Prof Thomas Henry Dawson Cummings
    Woodcroft Gardens
    Bridge Of Don
    AB22 8DT Aberdeen
    6
    Scotland
    06 avr. 2016
    Woodcroft Gardens
    Bridge Of Don
    AB22 8DT Aberdeen
    6
    Scotland
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    F.I.S. CHEMICALS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 05 nov. 2020
    Livré le 12 nov. 2020
    En cours
    Brève description
    All and whole those two areas of ground which together include chapel croft and chapel cottage, part of the lands of craibstone and in the parish of newhills and county of aberdeen being the subjects (first) and (second) more particularly described in, disponed by and delineated and coloured pink on the plan annexed and signed as relative to the disposition by joseph penny to martin ingham dated 27 february and recorded in the division of the general register of sasines for the county of aberdeen on 4 march both months in 1981, being the two areas of ground shown coloured pink on the plan forming part three of the schedule to the instrument together with (one) the fixtures and fittings therein and thereon; (two) the parts, privileges and pertinents thereof and (three) the chargor's whole right title and interest present and future in and to the subjects hereinbefore described.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Maven Capital Partners UK LLP (As Security Trustee)
    Transactions
    • 12 nov. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 05 nov. 2020
    Livré le 12 nov. 2020
    En cours
    Brève description
    All and whole those two areas of ground which together include chapel croft and chapel cottage, part of the lands of craibstone and in the parish of newhills and county of aberdeen being the subjects (first) and (second) more particularly described in, disponed by and delineated and coloured pink on the plan annexed and signed as relative to the disposition by joseph penny to martin ingham dated 27 february and recorded in the division of the general register of sasines for the county of aberdeen on 4 march both months in 1981, being the two areas of ground shown coloured pink on the plan forming part three of the schedule to the instrument together with (one) the fixtures and fittings therein and thereon; (two) the parts, privileges and pertinents thereof and (three) the chargor's whole right title and interest present and future in and to the subjects hereinbefore described.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Foresight Group LLP (As Security Trustee)
    Transactions
    • 12 nov. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 05 nov. 2020
    Livré le 06 nov. 2020
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole those two areas of ground which together include chapel croft and chapel cottage, part of the lands of craibstone and in the parish of newhills and county of aberdeen being the subjects (first) and (second) more particularly described in, disponed by and delineated and coloured pink on the plan annexed and signed as relative to the disposition by joseph penny to martin ingham dated 27 february and recorded in the division of the general register of sasines for the county of aberdeen on 4 march both months in 1981 together with (one) [the fixtures and fittings therein and thereon; (two) the parts, privileges and pertinents thereof and (three) the chargor's whole right title and interest present and future in and to the subjects hereinbefore described.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Igf Business Credit Limited
    Transactions
    • 06 nov. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 janv. 2025Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 21 oct. 2020
    Livré le 29 oct. 2020
    En cours
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Maven Capital Partners UK LLP as Security Trustee
    Transactions
    • 29 oct. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 nov. 2020Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 21 oct. 2020
    Livré le 29 oct. 2020
    En cours
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Foresight Group LLP as Security Trustee
    Transactions
    • 29 oct. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 nov. 2020Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 21 oct. 2020
    Livré le 28 oct. 2020
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Igf Business Credit Limited
    Transactions
    • 28 oct. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 oct. 2020Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 20 sept. 2010
    Livré le 25 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The commercial premises and cottage known as chapel croft bucksburn aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 25 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 21 oct. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 12 juil. 2010
    Livré le 14 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 21 oct. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 13 juin 1991
    Livré le 27 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Chapel croft cottage bucksburn aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 27 août 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 24 janv. 1983
    Livré le 09 févr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Northmost warehouses (units 2, 3 and 4) with area of ground at chapel croft, bucksburn, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 févr. 1983Enregistrement d'une charge
    • 27 août 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 01 avr. 1982
    Livré le 16 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The office, laboratory and warehouse at chapel croft, bucksburn, aberdeenshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 27 août 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 01 juin 1981
    Livré le 03 juin 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 juin 1981Enregistrement d'une charge
    • 24 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0