IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC070875 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED ?
| Adresse du siège social | c/o WRIGHT, JOHNSTON & MACKENZIE LLP 302 St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 27 juil. 2020
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Matthew Bishop en tant que directeur le 01 janv. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David John Muir en tant qu'administrateur le 01 janv. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
legacy | 44 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
legacy | 49 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 juin 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
legacy | 51 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINCH, Mark | Secrétaire | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 175736800001 | |||||||
| FINCH, Mark Charles | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 175612870001 | |||||
| MUIR, David John | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | 254017640001 | |||||
| MACNAMARA, Richard James | Secrétaire | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | 149304900001 | |||||||
| MAHAFFEY, Matthew Ian | Secrétaire | 23 St Oswalds Road Fulford YO1 4PF York North Yorkshire | British | 507940001 | ||||||
| WARD, Andrew Ian | Secrétaire | 6 Coniston Way LS22 6TT Wetherby West Yorkshire | British | 360770001 | ||||||
| WATSON, Deirdre Mary Alison | Secrétaire | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | Uk | 74385360001 | ||||||
| MATHESON & CO LIMITED | Secrétaire | 3 Lombard Street EC3V 9AQ London | 1947590001 | |||||||
| ATKIN, John Richard | Administrateur | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | 20102900001 | ||||||
| ATKIN, John Richard | Administrateur | Baillie Gate Queens Drive LS29 9QW Ilkley West Yorkshire | British | 20102900001 | ||||||
| BEATTIE, Craig Alan | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 177627900001 | |||||
| BEYNON, Peter | Administrateur | Stonehurst Elm Lane Copdock IP8 3ET Ipswich Suffolk | England | British | 38504390006 | |||||
| BISHOP, Matthew | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 206755450002 | |||||
| CHAMBERS, Paul Jonathan | Administrateur | 24 Constable Road Ben Rhydding LS29 8RW Ilkley West Yorkshire | British | 1188140001 | ||||||
| HEALEY, Derek John | Administrateur | 5 Tudor Court Prince Of Wales Mansions HG1 1JB Harrogate North Yorkshire | British | 46399230001 | ||||||
| HERBERT, Mark Philip | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | England | British | 123285980005 | |||||
| HOPE, John Alexander | Administrateur | Riverside,5 School Brae EH4 6JN Edinburgh Midlothian | British | 71318590002 | ||||||
| HOUSTON, Samuel George | Administrateur | Flat 59 Medland House 11 Branch Road E14 7JT London | British | 75730290003 | ||||||
| JONES, Alun Morton | Administrateur | Fen Walk IP12 4BG Woodbridge Fen House Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 12785600004 | |||||
| MACNAMARA, Richard James | Administrateur | The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester 770 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 149294820002 | |||||
| O'DONNELL, Joseph Peter | Administrateur | 5 Brodie Park Avenue PA2 6JH Paisley Renfrewshire | British | 18421870001 | ||||||
| POTTS, Derek | Administrateur | 55 East Street Coggeshall CO6 1SJ Colchester Essex | United Kingdom | British | 52485510001 | |||||
| RITCHIE, John Muir | Administrateur | High House Snipe Farm Road IP13 6SL Clopton Suffolk | British | 22325820001 | ||||||
| STUART, John Morris | Administrateur | Cromdale 26 Foxglove Avenue LS8 2QR Leeds West Yorkshire | British | 507950001 | ||||||
| WATSON, Deirdre Mary Alison | Administrateur | 51 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | England | Uk | 74385360001 | |||||
| WILLIAMS, Steven Wyn | Administrateur | 199 Finchampstead Road RG40 3HE Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 54580940001 | |||||
| WILLIAMSON, Michael Granville | Administrateur | Church Green Old Church Lane Pateley Bridge HG3 5LZ Harrogate North Yorkshire | British | 57360160001 | ||||||
| WITT, John Raymond | Administrateur | 28 Westerfield Road IP4 2YJ Ipswich Suffolk | Canadian | 51303670001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Skelly Group Limited | 06 avr. 2016 | 302 St Vincent Street G2 5RZ Glasgow C/O Wright, Johnston & Mackenzie Llp Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
IAN SKELLY (WISHAW) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Assignation in security | Créé le 17 janv. 1991 Livré le 21 janv. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All refunds of monies by the company by way of deposit on acquisition of motor vehicles supplied by V.A.G. and man on a consignment basis. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of offset | Créé le 05 juin 1987 Livré le 16 juin 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due by the company and/or others | |
Brèves mentions The balances at credit of any accounts held by the bank in name of the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignation in security | Créé le 20 nov. 1985 Livré le 25 nov. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All monies due to the company by V.A.G. (united kingdom) LTD dated 1/6/83. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 04 nov. 1985 Livré le 15 nov. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All used vehicles. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 04 nov. 1985 Livré le 15 nov. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of offset | Créé le 07 août 1985 Livré le 13 août 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due by the company and others | |
Brèves mentions All sums due to the company by the governor and company of the bank of scotland on the several accounts held by the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 01 août 1985 Livré le 15 août 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 0.58 acres at the A73 lanarkshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Assignation in security | Créé le 30 mars 1984 Livré le 05 avr. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All monies which may from time to time be owing to the company by V.A.G. (UK) limited. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 08 déc. 1982 Livré le 13 déc. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Garage known as beacon garage, bogside and dwellinghouse known as vondercroft, lanark. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 27 juil. 1981 Livré le 11 août 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due but not exceeding £70,000 of principal | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 27 juil. 1981 Livré le 11 août 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All used motor vehicles forming or which may at any time or from time to time form part of the company's stock of used motor vehicles and proceeds of any insurance policies. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 27 juil. 1981 Livré le 11 août 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All monies which may from time to time be owing to the company by vag (united kingdom) limited. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 17 avr. 1981 Livré le 24 avr. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0