SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société SC071516
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Peregrine House Peregrine Road
    Westhill Business Park, Westhill
    AB32 6JL Aberdeenshire
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SPS-AFOS INTERNATIONAL LIMITED05 juin 200005 juin 2000
    AFOS INTERNATIONAL LIMITED15 oct. 199215 oct. 1992
    ABERDEEN FILTRATION AND OILFIELD SERVICES LIMITED21 mai 198021 mai 1980

    Quels sont les derniers comptes de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2018
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2019
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Divers

    Confirmation of transfer of assets and liabilities
    1 pagesMISC

    Divers

    Notification from overseas registry of completion of merger
    3 pagesMISC

    Divers

    Court order re completion of cross border merger
    3 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    105 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Approved draft terms of cross border merger 10/12/2018
    RES13

    Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Divers

    CB01 – cross border merger notice
    142 pagesMISC

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    9 pagesAA

    Cessation de la nomination de Ian Jack en tant que directeur le 10 août 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr David Marsh en tant qu'administrateur le 03 nov. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Simon Smoker en tant qu'administrateur le 03 nov. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ryan Alexander Kidd en tant que directeur le 03 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    16 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ryan Alexander Kidd le 01 mai 2015

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Simon Smoker en tant que secrétaire le 01 janv. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Pauline Droy Moore en tant que secrétaire le 31 déc. 2015

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 déc. 2015

    État du capital au 11 déc. 2015

    • Capital: GBP 250,000
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Pauline Droy Moore le 23 oct. 2015

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ian Jack le 23 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    13 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill Aberdeen, Aberdeenshire Scotland AB32 6TQ à Peregrine House Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill Aberdeenshire Scotland AB32 6JL le 01 mai 2015

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Ryan Alexander Kidd en tant qu'administrateur le 01 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jim Andrews en tant que directeur le 01 janv. 2015

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SMOKER, Simon
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    203967800001
    MARSH, David
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritish171331520001
    SMOKER, Simon
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    Buckingham Gate
    RH6 0NZ Gatwick Airport
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritish134158640002
    COWAN, Raymond Andrew William
    Hillcrest
    Kincairn, Blairs
    AB12 5YQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    Hillcrest
    Kincairn, Blairs
    AB12 5YQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    British65217400001
    DROY MOORE, Pauline
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    158497360002
    GORMLEY, Donald
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    British105532790001
    GRIFFIN, Thomas Eugene
    Menie House
    Balmedie
    AB23 8YE Aberdeen
    Secrétaire
    Menie House
    Balmedie
    AB23 8YE Aberdeen
    Lawyer14300020004
    LEDINGHAM CHALMERS
    1 Golden Square
    AB10 1HA Aberdeen
    Secrétaire
    1 Golden Square
    AB10 1HA Aberdeen
    73896680007
    ANDREWS, Jim
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritish163190540001
    ARNOLD-GRIFFIN, Sandra Gay
    Menie House
    Balmedie
    Aberdeen
    Administrateur
    Menie House
    Balmedie
    Aberdeen
    American14300010002
    COWAN, Raymond Andrew William
    Hillcrest
    Kincairn, Blairs
    AB12 5YQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Hillcrest
    Kincairn, Blairs
    AB12 5YQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish65217400001
    ELLIS, Richard John Muir
    Burnside
    Kingsford Mews
    AB33 8HN Alford
    Aberdeenshire
    Scotland
    Administrateur
    Burnside
    Kingsford Mews
    AB33 8HN Alford
    Aberdeenshire
    Scotland
    British82194530001
    EMSLIE, Peter Forbes
    Tantallon Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    Administrateur
    Tantallon Corsee Road
    AB31 3RS Banchory
    Kincardineshire
    British24490001
    GIBB, William Ian Alexander
    St Eunans Road
    AB34 5HH Aboyne
    Kinnaird
    Aberdeenshire
    Administrateur
    St Eunans Road
    AB34 5HH Aboyne
    Kinnaird
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish103544230002
    GORMLEY, Donald
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    ScotlandBritish105532790001
    GRIFFIN, Thomas Eugene
    Menie House
    Balmedie
    AB23 8YE Aberdeen
    Administrateur
    Menie House
    Balmedie
    AB23 8YE Aberdeen
    Lawyer14300020004
    HENDERSON, Jeremy Neil
    Tillyfour House
    Tough
    AB33 8DX Alford
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Tillyfour House
    Tough
    AB33 8DX Alford
    Aberdeenshire
    British73430001
    HOWLETT, Paul David
    234 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9PB Aberdeen
    Administrateur
    234 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9PB Aberdeen
    British55761030001
    JACK, Ian
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    Administrateur
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 0NZ West Sussex
    Schlumberger House
    United Kingdom
    ScotlandBritish103412640012
    KIDD, Ryan Alexander
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ Gatwick
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    Buckingham Gate
    Gatwick Airport
    RH6 ONZ Gatwick
    Schlumberger House
    West Sussex
    United Kingdom
    ScotlandBritish192568420001
    MACKENZIE, Peter
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    Administrateur
    Manor Royal
    RH10 9LU Crawley
    Victory House
    West Sussex
    United Kingdom
    British114652960002
    WILLIAMS, Glynn Richard
    The Old Post Office
    Easton
    SO21 1EF Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    The Old Post Office
    Easton
    SO21 1EF Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish36481970003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Peregrine Road
    Westhill Business Park, Westhill
    AB32 6JL Aberdeenshire
    Peregrine House
    Scotland
    Scotland
    06 avr. 2016
    Peregrine Road
    Westhill Business Park, Westhill
    AB32 6JL Aberdeenshire
    Peregrine House
    Scotland
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc204919
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 24 mai 2000
    Livré le 01 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee
    Transactions
    • 01 juin 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 24 mai 2000
    Livré le 01 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Qhe Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee
    Transactions
    • 01 juin 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 07 juil. 1999
    Livré le 14 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 juil. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 juil. 1997
    Livré le 07 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The farm and lands of leyton, belhelvie, aberdeen....... See ch microfiche for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 août 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 févr. 1994
    Livré le 28 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    (1ST) 2 areas of ground in belhelvie, aberdeenshire being enclosure numbers 0045, 0038, 0035, 3819, 6033, 8124, 8700, 8500, 8100, 7212 & 5719 (2ND) strip of ground 12FT wide along east most boundary of (1ST) (3RD) strip of woodland dividing areas formerly numbered 1233 and 1234. but always excluding from (1ST) the accesss road running along southwest boundary.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 févr. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 févr. 1994
    Livré le 28 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    29 acres at menie house, balmedie, aberdeenshire.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 28 févr. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 oct. 1993
    Livré le 19 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    58.31 acres comprising enclosures number 1234,1235, 1237, 1238, 1239 & 1241 part of the lands and farm of hill of menie in the parish of belhelvie aberdeenshire.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 oct. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 févr. 1994Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 08 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 déc. 1991
    Livré le 06 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    81
    Brèves mentions
    1.27 acres comprising the mansion house of mernie balmedie aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 08 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Letter of agreement
    Créé le 11 mars 1985
    Livré le 19 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All sums standing or that may stand to the credit of any of the company's accounts with the bank and all sums deposited or to be deposited by the company with the bank whether denominated in sterling or otherwise and irrespective of the term of such deposits.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 mars 1985Enregistrement d'une charge
    • 15 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 11 mars 1981
    Livré le 11 mars 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 mars 1981Enregistrement d'une charge
    • 09 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 10 févr. 1981
    Livré le 27 févr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 févr. 1981Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0