SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Converti / Fermé |
| Forme juridique | Converti ou fermé |
| Numéro de société | SC071516 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED ?
| Adresse du siège social | Peregrine House Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill AB32 6JL Aberdeenshire Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2018 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2019 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divers Confirmation of transfer of assets and liabilities | 1 pages | MISC | ||||||||||
Divers Notification from overseas registry of completion of merger | 3 pages | MISC | ||||||||||
Divers Court order re completion of cross border merger | 3 pages | MISC | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 105 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Divers CB01 – cross border merger notice | 142 pages | MISC | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 9 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Jack en tant que directeur le 10 août 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Marsh en tant qu'administrateur le 03 nov. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Smoker en tant qu'administrateur le 03 nov. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ryan Alexander Kidd en tant que directeur le 03 nov. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 16 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ryan Alexander Kidd le 01 mai 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Smoker en tant que secrétaire le 01 janv. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Pauline Droy Moore en tant que secrétaire le 31 déc. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Pauline Droy Moore le 23 oct. 2015 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ian Jack le 23 oct. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 13 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill Aberdeen, Aberdeenshire Scotland AB32 6TQ à Peregrine House Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill Aberdeenshire Scotland AB32 6JL le 01 mai 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Ryan Alexander Kidd en tant qu'administrateur le 01 janv. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jim Andrews en tant que directeur le 01 janv. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMOKER, Simon | Secrétaire | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 0NZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 203967800001 | |||||||
| MARSH, David | Administrateur | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 171331520001 | |||||
| SMOKER, Simon | Administrateur | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | England | British | 134158640002 | |||||
| COWAN, Raymond Andrew William | Secrétaire | Hillcrest Kincairn, Blairs AB12 5YQ Aberdeen Aberdeenshire | British | 65217400001 | ||||||
| DROY MOORE, Pauline | Secrétaire | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 158497360002 | |||||||
| GORMLEY, Donald | Secrétaire | Manor Royal RH10 9LU Crawley Victory House West Sussex United Kingdom | British | 105532790001 | ||||||
| GRIFFIN, Thomas Eugene | Secrétaire | Menie House Balmedie AB23 8YE Aberdeen | Lawyer | 14300020004 | ||||||
| LEDINGHAM CHALMERS | Secrétaire | 1 Golden Square AB10 1HA Aberdeen | 73896680007 | |||||||
| ANDREWS, Jim | Administrateur | Manor Royal RH10 9LU Crawley Victory House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 163190540001 | |||||
| ARNOLD-GRIFFIN, Sandra Gay | Administrateur | Menie House Balmedie Aberdeen | American | 14300010002 | ||||||
| COWAN, Raymond Andrew William | Administrateur | Hillcrest Kincairn, Blairs AB12 5YQ Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 65217400001 | |||||
| ELLIS, Richard John Muir | Administrateur | Burnside Kingsford Mews AB33 8HN Alford Aberdeenshire Scotland | British | 82194530001 | ||||||
| EMSLIE, Peter Forbes | Administrateur | Tantallon Corsee Road AB31 3RS Banchory Kincardineshire | British | 24490001 | ||||||
| GIBB, William Ian Alexander | Administrateur | St Eunans Road AB34 5HH Aboyne Kinnaird Aberdeenshire | United Kingdom | British | 103544230002 | |||||
| GORMLEY, Donald | Administrateur | Manor Royal RH10 9LU Crawley Victory House West Sussex United Kingdom | Scotland | British | 105532790001 | |||||
| GRIFFIN, Thomas Eugene | Administrateur | Menie House Balmedie AB23 8YE Aberdeen | Lawyer | 14300020004 | ||||||
| HENDERSON, Jeremy Neil | Administrateur | Tillyfour House Tough AB33 8DX Alford Aberdeenshire | British | 73430001 | ||||||
| HOWLETT, Paul David | Administrateur | 234 North Deeside Road Cults AB15 9PB Aberdeen | British | 55761030001 | ||||||
| JACK, Ian | Administrateur | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 0NZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | Scotland | British | 103412640012 | |||||
| KIDD, Ryan Alexander | Administrateur | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ Gatwick Schlumberger House West Sussex United Kingdom | Scotland | British | 192568420001 | |||||
| MACKENZIE, Peter | Administrateur | Manor Royal RH10 9LU Crawley Victory House West Sussex United Kingdom | British | 114652960002 | ||||||
| WILLIAMS, Glynn Richard | Administrateur | The Old Post Office Easton SO21 1EF Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 36481970003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialised Petroleum Services Group Limited | 06 avr. 2016 | Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill AB32 6JL Aberdeenshire Peregrine House Scotland Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
SPECIALISED PETROLEUM SERVICES INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Créé le 24 mai 2000 Livré le 01 juin 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 24 mai 2000 Livré le 01 juin 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 07 juil. 1999 Livré le 14 juil. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 28 juil. 1997 Livré le 07 août 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The farm and lands of leyton, belhelvie, aberdeen....... See ch microfiche for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 14 févr. 1994 Livré le 28 févr. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions (1ST) 2 areas of ground in belhelvie, aberdeenshire being enclosure numbers 0045, 0038, 0035, 3819, 6033, 8124, 8700, 8500, 8100, 7212 & 5719 (2ND) strip of ground 12FT wide along east most boundary of (1ST) (3RD) strip of woodland dividing areas formerly numbered 1233 and 1234. but always excluding from (1ST) the accesss road running along southwest boundary. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 14 févr. 1994 Livré le 28 févr. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 29 acres at menie house, balmedie, aberdeenshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 05 oct. 1993 Livré le 19 oct. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 58.31 acres comprising enclosures number 1234,1235, 1237, 1238, 1239 & 1241 part of the lands and farm of hill of menie in the parish of belhelvie aberdeenshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 16 déc. 1991 Livré le 06 janv. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti 81 | |
Brèves mentions 1.27 acres comprising the mansion house of mernie balmedie aberdeen. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Letter of agreement | Créé le 11 mars 1985 Livré le 19 mars 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All sums standing or that may stand to the credit of any of the company's accounts with the bank and all sums deposited or to be deposited by the company with the bank whether denominated in sterling or otherwise and irrespective of the term of such deposits. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 11 mars 1981 Livré le 11 mars 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 10 févr. 1981 Livré le 27 févr. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0