NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC071689
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    5 Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NOBLE GROUP LIMITED03 janv. 199103 janv. 1991
    NOBLE & COMPANY LIMITED02 juin 198002 juin 1980

    Quels sont les derniers comptes de NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 janv. 2013

    État du capital au 30 janv. 2013

    • Capital: GBP 733,929
    SH01

    Cessation de la nomination de Jennifer Anne Owens en tant que secrétaire le 08 oct. 2012

    1 pagesTM02

    Nomination de Samantha Guthrie en tant que secrétaire le 08 oct. 2012

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Nicholas Jeremy Bruce Paulson-Ellis en tant que directeur le 08 oct. 2012

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    23 pagesAA

    Cessation de la nomination de Angus Robert Macpherson en tant que directeur le 31 mai 2012

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 76 George Street Edinburgh EH2 3BU le 28 juin 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Jennifer Anne Owens le 01 janv. 2012

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    25 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    22 pagesAA

    Cessation de la nomination de Robert Chaplin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Période comptable précédente prolongée du 30 nov. 2009 au 31 déc. 2009

    2 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Annotations
    DateAnnotation
    01 févr. 2010Inconsistency At the time of filing, this document appeared to be inconsistent with other information filed against the company. A/R appears to show one less director than Companies House records. - jbs

    État du capital après une attribution d'actions au 04 juin 2009

    • Capital: GBP 733,929
    2 pagesSH01

    Divers

    Form 123 04/06/09
    1 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution d'augmentation du capital social autorisé

    RES04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Nicholas Jeremy Bruce Paulson-Ellis le 22 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Angus Macpherson le 22 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Edward John Llewellyn-Lloyd le 22 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Robert Henry Moffett Chaplin le 22 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GUTHRIE, Samantha
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    United Kingdom
    Secrétaire
    Paternoster Square
    EC4M 7AL London
    10
    United Kingdom
    172672750001
    ASHTON, Charles James
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    United KingdomBritish139012420002
    LLEWELLYN-LLOYD, Edward John
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    EnglandBritish8369250002
    CHURCHILL, Stephen
    13 (1f) Royal Terrace
    EH7 5AB Edinburgh
    Secrétaire
    13 (1f) Royal Terrace
    EH7 5AB Edinburgh
    British85739530002
    OWENS, Jennifer Anne
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    Secrétaire
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    Other135228910001
    PAGE, Louise
    2/2 Grosvenor Gardens
    EH5 5JU Edinburgh
    Secrétaire
    2/2 Grosvenor Gardens
    EH5 5JU Edinburgh
    British59177160003
    ROBERTSON, James
    Bruaich The Spinney
    EH17 7LD Edinburgh
    Secrétaire
    Bruaich The Spinney
    EH17 7LD Edinburgh
    British50502860001
    SMEATON, Robin Campbell
    10 Hillpark Avenue
    EH4 7AT Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    10 Hillpark Avenue
    EH4 7AT Edinburgh
    Midlothian
    Scottish2584040001
    NOBLE & COMPANY
    5 Darnaway Street
    EH3 6DW Edinburgh
    Secrétaire
    5 Darnaway Street
    EH3 6DW Edinburgh
    43975940001
    NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Secrétaire
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    94907480001
    CHAPLIN, Robert Henry Moffett
    76 George Street
    Edinburgh
    EH2 3BU
    Administrateur
    76 George Street
    Edinburgh
    EH2 3BU
    United KingdomBritish63131640001
    GRANT, Adam Douglas Mortimer
    27 Warwicks Bench
    GU1 3TF Guildford
    Surrey
    Administrateur
    27 Warwicks Bench
    GU1 3TF Guildford
    Surrey
    EnglandBritish147687150001
    KIMBER, Timothy Roy Henry
    Newton Hall
    Whittington
    LA6 2NZ Carnforth
    Lancashire
    Administrateur
    Newton Hall
    Whittington
    LA6 2NZ Carnforth
    Lancashire
    EnglandBritish173030002
    MACDONALD, Angus Francis
    Auchleeks
    Trinafour
    PH18 5UF Pitlochry
    Perthshire
    Administrateur
    Auchleeks
    Trinafour
    PH18 5UF Pitlochry
    Perthshire
    ScotlandBritish48114110001
    MACPHERSON, Angus Robert
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    ScotlandBritish117526370001
    NOBLE, Iain Andrew, Sir
    An Lamraig
    IV43 8QR Eilean Iarmain
    An T-Eilean Sgitheanach
    Administrateur
    An Lamraig
    IV43 8QR Eilean Iarmain
    An T-Eilean Sgitheanach
    ScotlandBritish36704530003
    NOBLE, Simon John
    Ardkinglas
    PA26 8BH Cairndow
    Argyll
    Administrateur
    Ardkinglas
    PA26 8BH Cairndow
    Argyll
    British842310001
    NOBLE, Timothy Peter, Sir
    Ardnahane
    Barnton Avenue
    EH4 6JJ Edinburgh
    Administrateur
    Ardnahane
    Barnton Avenue
    EH4 6JJ Edinburgh
    United KingdomBritish685750001
    PAULSON-ELLIS, Nicholas Jeremy Bruce
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    5
    Scotland
    EnglandBritish193021480002
    PHILIPSZ, Joseph Eugene
    3 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    3 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish,Irish83107910002
    POTTER, David Roger William
    6 Norland Square
    W11 4PX London
    Administrateur
    6 Norland Square
    W11 4PX London
    United KingdomBritish17680200002
    THOMSON, Benjamin John Paget
    10 Belford Terrace
    EH4 3DQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    10 Belford Terrace
    EH4 3DQ Edinburgh
    Midlothian
    British44243290003

    NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 24 oct. 1996
    Livré le 31 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    74/76 george street,edinburgh and car parking spaces,hill street lane north,edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 oct. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 17 févr. 1993
    Livré le 03 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5 darnaway street, edinburgh & 5 gloucester lane, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 mars 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 27 nov. 1985
    Livré le 05 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Southmost garage 5 gloucester lane edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    • 13 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 22 nov. 1983
    Livré le 29 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5 darnaway st edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 nov. 1983Enregistrement d'une charge
    • 13 août 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 16 nov. 1981
    Livré le 26 nov. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 nov. 1981Enregistrement d'une charge
    • 10 mars 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0