HAMILTONS PACKAGING SERVICES LIMITED

HAMILTONS PACKAGING SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHAMILTONS PACKAGING SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC073961
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HAMILTONS PACKAGING SERVICES LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe HAMILTONS PACKAGING SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de HAMILTONS PACKAGING SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour HAMILTONS PACKAGING SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 juin 2010

    État du capital au 21 juin 2010

    • Capital: GBP 2,730
    SH01

    Cessation de la nomination de Joseph Schoonbrood en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Herwig Stuerzenbecher en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    39 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Section 550 approved 05/02/2010
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    legacy

    3 pagesMG02s

    Modification des coordonnées du secrétaire Graham Peter Fenwick le 10 nov. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Joseph Hubertus Anna Raymundus Schoonbrood le 01 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Carol Anne Hunt le 20 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    6 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Qui sont les dirigeants de HAMILTONS PACKAGING SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FENWICK, Graham Peter
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Edinburgh Quay
    Secrétaire
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Edinburgh Quay
    British131239950001
    HUNT, Carol Anne
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Edinburgh Quay
    Administrateur
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Edinburgh Quay
    United KingdomBritish117672970002
    STUERZENBECHER, Herwig
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Edinburgh Quay
    Administrateur
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Edinburgh Quay
    AustriaAustrian151802760001
    ALLAN, Francis Thomas
    7 Courtney Way
    CB4 2EE Cambridge
    Secrétaire
    7 Courtney Way
    CB4 2EE Cambridge
    British43667810001
    ANDERSON, Don Mcminn
    28 Fraser Avenue
    Newton Mearns
    G77 6HP Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    28 Fraser Avenue
    Newton Mearns
    G77 6HP Glasgow
    Lanarkshire
    British367950001
    MCKENZIE, James
    Old Manse Cottage
    Station Road, Balfron
    G63 0SX Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    Old Manse Cottage
    Station Road, Balfron
    G63 0SX Glasgow
    Lanarkshire
    British99564570001
    ALLAN, Francis Thomas
    7 Courtney Way
    CB4 2EE Cambridge
    Administrateur
    7 Courtney Way
    CB4 2EE Cambridge
    British43667810001
    ANDERSON, Don Mcminn
    28 Fraser Avenue
    Newton Mearns
    G77 6HP Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    28 Fraser Avenue
    Newton Mearns
    G77 6HP Glasgow
    Lanarkshire
    British367950001
    BLACKFORD, Christopher Fitzgerald
    .
    Dovecote Church Road, Walpole St Peter
    PE14 7NS Wisbech
    Administrateur
    .
    Dovecote Church Road, Walpole St Peter
    PE14 7NS Wisbech
    British61034050002
    CHRISTIE, John Stark
    56 Abercromby Crescent
    G84 9DX Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    56 Abercromby Crescent
    G84 9DX Helensburgh
    Dunbartonshire
    British811670001
    CONNER, Gordon Alan
    1 Kingsford Court
    Newton Mearns
    G77 6TS Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    1 Kingsford Court
    Newton Mearns
    G77 6TS Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish367970001
    DICKIE, Robert Pittendreigh
    19 Hamilton Drive
    Cambuslang
    G72 8JG Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    19 Hamilton Drive
    Cambuslang
    G72 8JG Glasgow
    Lanarkshire
    British367960001
    KING, Gary Dennis, Dr
    The Warren
    Llanarmon Yn Lal
    CH7 4QW Mold
    Clwyd
    Administrateur
    The Warren
    Llanarmon Yn Lal
    CH7 4QW Mold
    Clwyd
    British63444430002
    LOGGIE, John Ian
    Plats Hall
    Bostock Road, Bostock
    CW10 9JN Middlewich
    Cheshire
    Administrateur
    Plats Hall
    Bostock Road, Bostock
    CW10 9JN Middlewich
    Cheshire
    British93949320003
    MCINTOSH, David
    115 Mossgiel Road
    G43 2BY Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    115 Mossgiel Road
    G43 2BY Glasgow
    Lanarkshire
    British1092330001
    PROKOPOWICZ, Zbigniew
    40 Derby Road
    Beeston
    NG9 2TG Nottingham
    Administrateur
    40 Derby Road
    Beeston
    NG9 2TG Nottingham
    French85888260002
    SCHOONBROOD, Joseph Hubertus Anna Raymundus
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Edinburgh Quay
    Administrateur
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Edinburgh Quay
    NetherlandsDutch108094620001
    USHER, Jacqueline
    3 Longbourn
    SL4 3TN Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    3 Longbourn
    SL4 3TN Windsor
    Berkshire
    British52101710007
    WILSON, Kenneth
    18 Stewarton Drive
    Cambuslang
    G72 8DF Glasgow
    Administrateur
    18 Stewarton Drive
    Cambuslang
    G72 8DF Glasgow
    British44353550001
    WRIGHT, Robert
    3 Woodland Way Kildrum
    Cumbernauld
    G67 2BE Glasgow
    Administrateur
    3 Woodland Way Kildrum
    Cumbernauld
    G67 2BE Glasgow
    British44353520001

    HAMILTONS PACKAGING SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 22 août 1994
    Livré le 31 août 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1 rutherford court,clydebank - DMB38332.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 août 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 01 juil. 1988
    Livré le 11 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 21 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 09 mai 1986
    Livré le 15 mai 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 15 mai 1986Enregistrement d'une charge
    • 10 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0