SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | SC074005 |
Juridiction | Écosse |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED ?
Adresse du siège social | 4 Atlantic Quay 70 York Street G2 8JX Glasgow |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire | 9 pages | 4.26(Scot) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL à 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX le 13 déc. 2016 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2015 | 14 pages | AA | ||||||||||
État du capital au 14 sept. 2016
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Elizabeth Ann Blease le 12 juil. 2010 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 19 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Christian Pursey en tant qu'administrateur le 30 juin 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Ann Octavia Peters en tant qu'administrateur le 30 juin 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Richard Proctor en tant que directeur le 30 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Laurence Yolande Giard en tant que directeur le 30 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Edinburgh Quay 133 Fountainbridge Edinburgh Midlothian EH3 9AG à 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL le 09 janv. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 19 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew John Pilsworth le 28 févr. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gareth John Osborn le 20 janv. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Richard Proctor le 20 janv. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gareth John Osborn le 15 nov. 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 22 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLEASE, Elizabeth Ann | Secrétaire | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House England | Other | 132060350001 | ||||||
HOLLAND, Alan Michael | Administrateur | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House England | United Kingdom | British | Director | 167815240001 | ||||
OSBORN, Gareth John | Administrateur | Bath Road SL1 4DX Slough 258 | England | British | Chartered Surveyor | 91257750004 | ||||
PETERS, Ann Octavia | Administrateur | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House England | England | British | Director | 199465250001 | ||||
PILSWORTH, Andrew John | Administrateur | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House England | United Kingdom | British | Director | 155293090003 | ||||
PURSEY, Simon Christian | Administrateur | Bath Road SL1 4DX Slough 258 | United Kingdom | British | Director | 190915460001 | ||||
BADCOCK, Peter Colin | Secrétaire | 53 Sandown Park TN2 4RH Tunbridge Wells Kent | British | 545530001 | ||||||
BANERJEE, Pradip | Secrétaire | 4 Seaton Stables AB2 1XS Aberdeen Aberdeenshire | British | 756560001 | ||||||
BLEASE, Elizaabeth Ann | Secrétaire | Central Buildings Matthew Parker Street SW1H 9NE London 3 United Kingdom | Other | 134283690001 | ||||||
KERSLAKE, Susan | Secrétaire | 8 The Common KT21 2ED Ashtead Surrey | British | 1320390001 | ||||||
LYNCH, Valerie Ann | Secrétaire | 6 Charvil House Road Charvil RG10 9RD Reading Berkshire | British | 68872030002 | ||||||
MAIR, Kenneth | Secrétaire | 3 Smithy Lane Lower Kingswood KT20 6TP Tadworth Surrey | British | 545490001 | ||||||
PROBERT, John Robert | Secrétaire | 2 Compton Way Taylors Farm Sherfield On Loddon RG27 0SQ Hook | British | 34786610008 | ||||||
RANKEN & REID SSC | Secrétaire | 7 Albyn Place EH2 4NG Edinburgh Midlothian | 36900001 | |||||||
TODS MURRAY LLP | Secrétaire | 66 Queen Street EH2 4NE Edinburgh | 1117600001 | |||||||
BADCOCK, Peter Colin | Administrateur | 53 Sandown Park TN2 4RH Tunbridge Wells Kent | British | Company Director | 545530001 | |||||
BRIDGES, David Crawford | Administrateur | Bath Road 234 Bath Road SL1 4EE Slough 234 Berkshire England | England | British | Director | 94982860001 | ||||
BURMAN, Barry William | Administrateur | Little Orchard 3 Winchelsey Rise CR2 7BP South Croydon Surrey | England | British | Company Director | 50817240001 | ||||
CAREY, Roger William | Administrateur | Instow Burtons Way HP8 4BP Chalfont St Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 6069370001 | ||||
CHISHOLM, Allan Donald | Administrateur | 49 Colcokes Road SM7 2EJ Banstead Surrey | England | British | Company Director | 545510001 | ||||
COOK, Alexander Kinnison | Administrateur | 10 Station Road East Peterculter AB1 0PT Aberdeen | British | Company Director | 545520001 | |||||
DRUMMOND, Graham | Administrateur | 17 St Ronans Circle AB14 0NE Peterculter Aberdeenshire | British | Engineer | 59086970001 | |||||
GIARD, Laurence Yolande | Administrateur | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House England | France | French | Director | 166569010001 | ||||
GULLIFORD, Andrew Stephen | Administrateur | White Gables Perks Lane Prestwood HP16 0JQ Great Missenden Buckinghamshire | England | British | Chartered Surveyor | 101612810001 | ||||
HEAWOOD, John Anthony Nicholas | Administrateur | South View Road HA5 3YB Pinner Gateway Middlesex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 133123780001 | ||||
HORLER, Elizabeth Anne | Administrateur | 9 Lionel Avenue HP22 6LL Wendover Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 118644450001 | |||||
KINGSTON, Richard David | Administrateur | 60 Clifton Road HP6 5PN Amersham Buckinghamshire | British | Accountant | 10789160002 | |||||
NEWBIGGING, Bruce Robert | Administrateur | Quiet Waters Upland IP7 6ES Kersey Suffolk | England | British | Banker | 151932690001 | ||||
NEWELL, Margaret Ida | Administrateur | White House WD3 4NG Rickmansworth Herts | British | Company Director | 612900001 | |||||
O'CONNOR, Kevin John | Administrateur | Salisbury Place KT14 6SW West Byfleet 5 Surrey United Kingdom | British | Director | 134211680002 | |||||
POSTLETHWAITE, Maureen Anne | Administrateur | 65 London Road South Merstham RH1 3AX Redhill Surrey | British | Banker | 612910001 | |||||
PROCTOR, David Richard | Administrateur | Bath Road SL1 4DX Slough 258 | England | British | Director | 172618490001 | ||||
REDDING, Philip Anthony | Administrateur | Bath Road 234 Bath Road SL1 4EE Slough 234 Berkshire England | England | British | Director | 152749640002 | ||||
SHANKAR, Siva | Administrateur | Roberts Way Englefield Green TW20 9SH Egham Queenswood Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director Uk Property | 132176500001 | ||||
SIMMS, Vanessa Kate | Administrateur | Turbary Road GU51 1GH Fleet 18 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 134181890002 |
SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Floating charge | Créé le 01 sept. 1993 Livré le 21 sept. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 21 juin 1989 Livré le 03 juil. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The lease relating to shops no's 30 and 34 schoolhill aberdeen 8 1/4 square metres part of the solum of loch street, aberdeen. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 28 mai 1987 Livré le 08 juin 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Bon accord centre aberdeen. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Bond & floating charge | Créé le 30 avr. 1987 Livré le 07 mai 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge | Créé le 21 mai 1986 Livré le 05 juin 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole interest of the company in and to (a) the development agreement entered into between the city of aberdeen district council ("the council") and bredero vast goed N.V. a company incorporated under the laws of the netherlands whose chief office is situated at kromme nieuwe gracht 66, utrecht (B.V.G.) dated 2ND may 1979, (b) the first supplemental agreement entered into between the council and B.V.G. dated 24TH september and 20TH november 1979, (c) the second supplemental agreement entered into between the council and B.V.G. dated 1ST august 1984 and 7TH august 1985, (d) the linking agreement entered into between the council, B.V.G. and the wordie property company limited incorporated under the companies acts and having its registered office at 202 west george street, glasgow (wordie) dates 1ST august 1984 and 8TH january and 7TH august 1985 and (e) the agreement entered into between B.V.G. and wordie dated 1ST august 1984 and 8TH january 1985, the said whole interest of B.V.G. in said development agreement, first and second supplemental agreements, linking agreement and agreement having been assigned by B.V.G. to the company by virtue of two assignations granted by B.V.G. in favour of the company dated 9TH may 1986. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0