SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED

SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC074005
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SLOUGH (WESSEX FIELDS) LIMITED09 nov. 199909 nov. 1999
    BREDERO ABERDEEN CENTRE LIMITED 07 févr. 198607 févr. 1986
    BREDERO (ABERDEEN CENTRE) LIMITED13 janv. 198613 janv. 1986
    ABERDEEN (AREA B. GEORGE STREET) DEVELOPMENT LIMITED02 mars 198102 mars 1981

    Quels sont les derniers comptes de SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    9 pages4.26(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL à 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX le 13 déc. 2016

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 08 déc. 2016

    LRESSP

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2015

    14 pagesAA

    État du capital au 14 sept. 2016

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 juil. 2016

    État du capital au 25 juil. 2016

    • Capital: GBP 18,000,000
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Elizabeth Ann Blease le 12 juil. 2010

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    19 pagesAA

    Nomination de Mr Simon Christian Pursey en tant qu'administrateur le 30 juin 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Ann Octavia Peters en tant qu'administrateur le 30 juin 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Richard Proctor en tant que directeur le 30 juin 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Laurence Yolande Giard en tant que directeur le 30 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 juil. 2015

    État du capital au 14 juil. 2015

    • Capital: GBP 18,000,000
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de Edinburgh Quay 133 Fountainbridge Edinburgh Midlothian EH3 9AG à 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL le 09 janv. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juil. 2014

    État du capital au 11 juil. 2014

    • Capital: GBP 18,000,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew John Pilsworth le 28 févr. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gareth John Osborn le 20 janv. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Richard Proctor le 20 janv. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gareth John Osborn le 15 nov. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    22 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BLEASE, Elizabeth Ann
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Secrétaire
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Other132060350001
    HOLLAND, Alan Michael
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Administrateur
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    United KingdomBritishDirector167815240001
    OSBORN, Gareth John
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    Administrateur
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    EnglandBritishChartered Surveyor91257750004
    PETERS, Ann Octavia
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Administrateur
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    EnglandBritishDirector199465250001
    PILSWORTH, Andrew John
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Administrateur
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    United KingdomBritishDirector155293090003
    PURSEY, Simon Christian
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    Administrateur
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    United KingdomBritishDirector190915460001
    BADCOCK, Peter Colin
    53 Sandown Park
    TN2 4RH Tunbridge Wells
    Kent
    Secrétaire
    53 Sandown Park
    TN2 4RH Tunbridge Wells
    Kent
    British545530001
    BANERJEE, Pradip
    4 Seaton Stables
    AB2 1XS Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    4 Seaton Stables
    AB2 1XS Aberdeen
    Aberdeenshire
    British756560001
    BLEASE, Elizaabeth Ann
    Central Buildings Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    3
    United Kingdom
    Secrétaire
    Central Buildings Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    3
    United Kingdom
    Other134283690001
    KERSLAKE, Susan
    8 The Common
    KT21 2ED Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    8 The Common
    KT21 2ED Ashtead
    Surrey
    British1320390001
    LYNCH, Valerie Ann
    6 Charvil House Road
    Charvil
    RG10 9RD Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    6 Charvil House Road
    Charvil
    RG10 9RD Reading
    Berkshire
    British68872030002
    MAIR, Kenneth
    3 Smithy Lane
    Lower Kingswood
    KT20 6TP Tadworth
    Surrey
    Secrétaire
    3 Smithy Lane
    Lower Kingswood
    KT20 6TP Tadworth
    Surrey
    British545490001
    PROBERT, John Robert
    2 Compton Way Taylors Farm
    Sherfield On Loddon
    RG27 0SQ Hook
    Secrétaire
    2 Compton Way Taylors Farm
    Sherfield On Loddon
    RG27 0SQ Hook
    British34786610008
    RANKEN & REID SSC
    7 Albyn Place
    EH2 4NG Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    7 Albyn Place
    EH2 4NG Edinburgh
    Midlothian
    36900001
    TODS MURRAY LLP
    66 Queen Street
    EH2 4NE Edinburgh
    Secrétaire
    66 Queen Street
    EH2 4NE Edinburgh
    1117600001
    BADCOCK, Peter Colin
    53 Sandown Park
    TN2 4RH Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    53 Sandown Park
    TN2 4RH Tunbridge Wells
    Kent
    BritishCompany Director545530001
    BRIDGES, David Crawford
    Bath Road
    234 Bath Road
    SL1 4EE Slough
    234
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Bath Road
    234 Bath Road
    SL1 4EE Slough
    234
    Berkshire
    England
    EnglandBritishDirector94982860001
    BURMAN, Barry William
    Little Orchard 3 Winchelsey Rise
    CR2 7BP South Croydon
    Surrey
    Administrateur
    Little Orchard 3 Winchelsey Rise
    CR2 7BP South Croydon
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director50817240001
    CAREY, Roger William
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Instow
    Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director6069370001
    CHISHOLM, Allan Donald
    49 Colcokes Road
    SM7 2EJ Banstead
    Surrey
    Administrateur
    49 Colcokes Road
    SM7 2EJ Banstead
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director545510001
    COOK, Alexander Kinnison
    10 Station Road East
    Peterculter
    AB1 0PT Aberdeen
    Administrateur
    10 Station Road East
    Peterculter
    AB1 0PT Aberdeen
    BritishCompany Director545520001
    DRUMMOND, Graham
    17 St Ronans Circle
    AB14 0NE Peterculter
    Aberdeenshire
    Administrateur
    17 St Ronans Circle
    AB14 0NE Peterculter
    Aberdeenshire
    BritishEngineer59086970001
    GIARD, Laurence Yolande
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    Administrateur
    15 Regent Street
    SW1Y 4LR London
    Cunard House
    England
    FranceFrenchDirector166569010001
    GULLIFORD, Andrew Stephen
    White Gables
    Perks Lane Prestwood
    HP16 0JQ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    White Gables
    Perks Lane Prestwood
    HP16 0JQ Great Missenden
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Surveyor101612810001
    HEAWOOD, John Anthony Nicholas
    South View Road
    HA5 3YB Pinner
    Gateway
    Middlesex
    Administrateur
    South View Road
    HA5 3YB Pinner
    Gateway
    Middlesex
    United KingdomBritishChartered Surveyor133123780001
    HORLER, Elizabeth Anne
    9 Lionel Avenue
    HP22 6LL Wendover
    Buckinghamshire
    Administrateur
    9 Lionel Avenue
    HP22 6LL Wendover
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant118644450001
    KINGSTON, Richard David
    60 Clifton Road
    HP6 5PN Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    60 Clifton Road
    HP6 5PN Amersham
    Buckinghamshire
    BritishAccountant10789160002
    NEWBIGGING, Bruce Robert
    Quiet Waters
    Upland
    IP7 6ES Kersey
    Suffolk
    Administrateur
    Quiet Waters
    Upland
    IP7 6ES Kersey
    Suffolk
    EnglandBritishBanker151932690001
    NEWELL, Margaret Ida
    White House
    WD3 4NG Rickmansworth
    Herts
    Administrateur
    White House
    WD3 4NG Rickmansworth
    Herts
    BritishCompany Director612900001
    O'CONNOR, Kevin John
    Salisbury Place
    KT14 6SW West Byfleet
    5
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Salisbury Place
    KT14 6SW West Byfleet
    5
    Surrey
    United Kingdom
    BritishDirector134211680002
    POSTLETHWAITE, Maureen Anne
    65 London Road South
    Merstham
    RH1 3AX Redhill
    Surrey
    Administrateur
    65 London Road South
    Merstham
    RH1 3AX Redhill
    Surrey
    BritishBanker612910001
    PROCTOR, David Richard
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    Administrateur
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    258
    EnglandBritishDirector172618490001
    REDDING, Philip Anthony
    Bath Road
    234 Bath Road
    SL1 4EE Slough
    234
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Bath Road
    234 Bath Road
    SL1 4EE Slough
    234
    Berkshire
    England
    EnglandBritishDirector152749640002
    SHANKAR, Siva
    Roberts Way
    Englefield Green
    TW20 9SH Egham
    Queenswood
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Roberts Way
    Englefield Green
    TW20 9SH Egham
    Queenswood
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director Uk Property132176500001
    SIMMS, Vanessa Kate
    Turbary Road
    GU51 1GH Fleet
    18
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Turbary Road
    GU51 1GH Fleet
    18
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector134181890002

    SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 01 sept. 1993
    Livré le 21 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 sept. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 oct. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 juin 1989
    Livré le 03 juil. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The lease relating to shops no's 30 and 34 schoolhill aberdeen 8 1/4 square metres part of the solum of loch street, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A.
    Transactions
    • 03 juil. 1989Enregistrement d'une charge
    • 29 juin 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 28 mai 1987
    Livré le 08 juin 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Bon accord centre aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A.
    Transactions
    • 08 juin 1987Enregistrement d'une charge
    • 29 juin 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 30 avr. 1987
    Livré le 07 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A.
    Transactions
    • 07 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 08 juil. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 21 mai 1986
    Livré le 05 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole interest of the company in and to (a) the development agreement entered into between the city of aberdeen district council ("the council") and bredero vast goed N.V. a company incorporated under the laws of the netherlands whose chief office is situated at kromme nieuwe gracht 66, utrecht (B.V.G.) dated 2ND may 1979, (b) the first supplemental agreement entered into between the council and B.V.G. dated 24TH september and 20TH november 1979, (c) the second supplemental agreement entered into between the council and B.V.G. dated 1ST august 1984 and 7TH august 1985, (d) the linking agreement entered into between the council, B.V.G. and the wordie property company limited incorporated under the companies acts and having its registered office at 202 west george street, glasgow (wordie) dates 1ST august 1984 and 8TH january and 7TH august 1985 and (e) the agreement entered into between B.V.G. and wordie dated 1ST august 1984 and 8TH january 1985, the said whole interest of B.V.G. in said development agreement, first and second supplemental agreements, linking agreement and agreement having been assigned by B.V.G. to the company by virtue of two assignations granted by B.V.G. in favour of the company dated 9TH may 1986.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 05 juin 1986Enregistrement d'une charge

    SEGRO (WESSEX FIELDS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 oct. 2017Dissolved on
    08 déc. 2016Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0