ROBERTSON MARKETING SERVICES GROUP LIMITED

ROBERTSON MARKETING SERVICES GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROBERTSON MARKETING SERVICES GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC075012
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROBERTSON MARKETING SERVICES GROUP LIMITED ?

    • (7415) /
    • (7499) /

    Où se situe ROBERTSON MARKETING SERVICES GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    24 Great King Street
    Edinburgh
    EH3 6QN
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ROBERTSON MARKETING SERVICES GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    J.S. ROBERTSON ADVERTISING LIMITED29 mai 198129 mai 1981

    Quels sont les derniers comptes de ROBERTSON MARKETING SERVICES GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ROBERTSON MARKETING SERVICES GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    22 pages4.26(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 avr. 2011

    LRESSP

    Comptes annuels établis au 31 mai 2010

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 oct. 2010

    État du capital au 27 oct. 2010

    • Capital: GBP 1,008,475
    SH01

    Nomination de Thomas Edward Timothy Homer en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de James Cheesewright en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Nicholas Brian Farrimond en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination d'un directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Misys Corporate Secretary Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Gurbinder Bains en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 mai 2009

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    17 pagesAR01

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 mai 2008

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 31 mai 2007

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de ROBERTSON MARKETING SERVICES GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Secrétaire
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement07036299
    149996510001
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    EnglandBritish75357260001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    Administrateur
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    Administrateur
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    82836510002
    ARMITAGE, Matthew
    63 Windsor Road
    WR11 4QF Evesham
    Secrétaire
    63 Windsor Road
    WR11 4QF Evesham
    British98110790002
    BAINS, Gurbinder
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Other138753780001
    BOLTON, Richard James
    Hillhead Farmhouse
    Carberry
    EH21 8QE Musselburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    Hillhead Farmhouse
    Carberry
    EH21 8QE Musselburgh
    Midlothian
    British42101940001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secrétaire
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secrétaire
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secrétaire
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Secrétaire
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secrétaire
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    BELL & SCOTT (SECRETARIAL SERVICES) LIMITED
    16 Hill Street
    EH2 3LD Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire désigné
    16 Hill Street
    EH2 3LD Edinburgh
    Midlothian
    900007090001
    HENDERSON BOYD JACKSON LIMITED
    19 Ainslie Place
    EH3 6AU Edinburgh
    Secrétaire désigné
    19 Ainslie Place
    EH3 6AU Edinburgh
    900006190001
    HENDERSON BOYD JACKSON LIMITED
    19 Ainslie Place
    EH3 6AU Edinburgh
    Secrétaire désigné
    19 Ainslie Place
    EH3 6AU Edinburgh
    900006190001
    CHEESEWRIGHT, James
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    Administrateur
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritish80646020001
    COPELAND, Philip Robert
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish44954570001
    DUCKETT, Roger Anthony
    Petroc 5 The Croft
    Somerford Keynes
    GL7 6EN Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Petroc 5 The Croft
    Somerford Keynes
    GL7 6EN Cirencester
    Gloucestershire
    British808800001
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    FLANAGAN, Andrew Henry
    75 Drymen Road
    Bearsden
    G61 2RH Glasgow
    Administrateur
    75 Drymen Road
    Bearsden
    G61 2RH Glasgow
    British42787120001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Administrateur
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    IRELAND, Susan Priscilla
    3 Lansdowne Crescent
    EH12 5EQ Edinburgh
    Administrateur
    3 Lansdowne Crescent
    EH12 5EQ Edinburgh
    United KingdomBritish44547530001
    OLDERSHAW, Peter Alan
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    British2546430001
    PATERSON, Stephen Liston Lindsay
    10 Baberton Mains Bank
    EH14 3ED Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    10 Baberton Mains Bank
    EH14 3ED Edinburgh
    Midlothian
    British770200001
    ROBERTSON, John Stewart
    28 Barnton Avenue West
    EH4 6EB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    28 Barnton Avenue West
    EH4 6EB Edinburgh
    Midlothian
    British294000001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WALKER, Andrew Wiseman Shearsby
    18 Downie Grove
    EH12 7AX Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    18 Downie Grove
    EH12 7AX Edinburgh
    Midlothian
    British294020001
    WHITTY, Brian Howard
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    Administrateur
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    British36622750002
    WILLIAMS, Juliet Susan Durrant
    Treeton Cottage
    Abbotskerswell
    TQ12 5PW Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    Treeton Cottage
    Abbotskerswell
    TQ12 5PW Newton Abbot
    Devon
    EnglandBritish808810001

    ROBERTSON MARKETING SERVICES GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 24 janv. 1985
    Livré le 30 janv. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 janv. 1985Enregistrement d'une charge
    • 01 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    ROBERTSON MARKETING SERVICES GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    15 févr. 2012Dissolved on
    27 avr. 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0