CLYDE INSULATION SUPPLIES LIMITED

CLYDE INSULATION SUPPLIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCLYDE INSULATION SUPPLIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC075638
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CLYDE INSULATION SUPPLIES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe CLYDE INSULATION SUPPLIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Sig Distribution Coddington Crescent
    Holytown
    ML1 4YF Motherwell
    North Lanarkshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CLYDE INSULATION SUPPLIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour CLYDE INSULATION SUPPLIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 30 juin 2023

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account reduced 16/06/2023
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Andrew Watkins en tant qu'administrateur le 31 mars 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kulbinder Kaur Dosanjh en tant que directeur le 31 mars 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kulbinder Kaur Dosanjh en tant que secrétaire le 31 mars 2021

    1 pagesTM02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Kulbinder Kaur Dosanjh le 22 déc. 2020

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 11 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Richard Charles Monro en tant que secrétaire le 18 oct. 2019

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Richard Charles Monro en tant que directeur le 18 oct. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Kulbinder Kaur Dosanjh en tant que secrétaire le 18 oct. 2019

    2 pagesAP03

    Nomination de Ms Kulbinder Kaur Dosanjh en tant qu'administrateur le 18 oct. 2019

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de 95 Westburn Drive Cambuslang Glasgow G72 7NA à Sig Distribution Coddington Crescent Holytown Motherwell North Lanarkshire ML1 4YF le 25 sept. 2019

    1 pagesAD01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de CLYDE INSULATION SUPPLIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JACKSON, Ian
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant186473820002
    WATKINS, Andrew
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup General Counsel & Company Secretary281612300001
    DOSANJH, Kulbinder Kaur
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    Secrétaire
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    264041940001
    MONRO, Richard Charles
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Secrétaire
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    British59480370001
    SMITH, Linda Helen
    23 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DX Stirling
    Secrétaire
    23 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DX Stirling
    British313940002
    DOSANJH, Kulbinder Kaur
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Eastbourne Terrace
    W2 6LG London
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary231199720003
    FOTHERINGHAM, Colin George Ewing
    Pond View Drain Lane
    Holme On Spalding Moor
    YO43 4DQ York
    East Yorkshire
    Administrateur
    Pond View Drain Lane
    Holme On Spalding Moor
    YO43 4DQ York
    East Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director82642480001
    FOTHERINGHAM, Colin George Ewing
    Pond View Drain Lane
    Holme On Spalding Moor
    YO43 4DQ York
    East Yorkshire
    Administrateur
    Pond View Drain Lane
    Holme On Spalding Moor
    YO43 4DQ York
    East Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director82642480001
    HUDSON, Jonathan Adrian
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Administrateur
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director27743810004
    LAIRD, John Perry
    14 Lyman Drive
    ML2 8ST Wishaw
    Lanarkshire
    Administrateur
    14 Lyman Drive
    ML2 8ST Wishaw
    Lanarkshire
    BritishSalesman313970001
    MONRO, Richard Charles
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Administrateur
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary59480370001
    ROE, Darren
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    Administrateur
    17 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Signet House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant106708580001
    SMITH, Linda Helen
    23 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DX Stirling
    Administrateur
    23 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DX Stirling
    ScotlandBritishDirector313940002
    SMITH, Ronnie Mckenzie
    23 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DX Stirling
    Administrateur
    23 Chalton Road
    Bridge Of Allan
    FK9 4DX Stirling
    ScotlandBritishDirector313950002
    WATSON, David Kidd
    29 Greenvale Drive
    Brightons
    FK2 0TQ Falkirk
    Stirlingshire
    Administrateur
    29 Greenvale Drive
    Brightons
    FK2 0TQ Falkirk
    Stirlingshire
    BritishSalesman313960001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CLYDE INSULATION SUPPLIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    16 Europa View
    Sheffield Business Park
    S9 1XH Sheffield
    Adsetts House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement01451007
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CLYDE INSULATION SUPPLIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 25 juin 2003
    Livré le 04 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot 11, broadleys business park, stirling.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 21 avr. 1998
    Livré le 27 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 avr. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Letter of offset
    Créé le 10 févr. 1987
    Livré le 18 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Balances at credit of any account.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 févr. 1987Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 28 nov. 1984
    Livré le 11 déc. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 déc. 1984Enregistrement d'une charge
    • 07 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 01 oct. 1981
    Livré le 19 oct. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 oct. 1981Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0