W.B.T. NOMINEES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéW.B.T. NOMINEES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC076833
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de W.B.T. NOMINEES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe W.B.T. NOMINEES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Park House
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de W.B.T. NOMINEES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MACRAE & DICK (PETERHEAD) LIMITED30 nov. 198130 nov. 1981

    Quels sont les derniers comptes de W.B.T. NOMINEES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour W.B.T. NOMINEES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Douglas Ireland Park le 06 avr. 2018

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2018

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Alasdair George Noble en tant qu'administrateur le 17 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gerard Donnachie en tant que directeur le 03 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017

    9 pagesAA

    Nomination de Mr Alasdair George Noble en tant que secrétaire le 06 oct. 2017

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Gerard Donnachie en tant que secrétaire le 06 oct. 2017

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 30 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Gerard Donnachie en tant que secrétaire le 31 juil. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Thomas William Maclean en tant que secrétaire le 31 juil. 2016

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Andrew Grzesinski en tant que directeur le 06 mai 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 avr. 2016

    État du capital au 25 avr. 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2015 au 31 mars 2016

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr Andrew Grzesinski en tant qu'administrateur le 19 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Alexander Stewart Bryce en tant qu'administrateur le 19 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Douglas Ireland Park en tant qu'administrateur le 19 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr William Cumming en tant qu'administrateur le 19 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de W.B.T. NOMINEES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NOBLE, Alasdair George
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    Secrétaire
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    238724410001
    BRYCE, Alexander Stewart
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    Administrateur
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    United KingdomBritishGroup Sales Manager150803460001
    CUMMING, William
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    Administrateur
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    ScotlandBritishAftersales Director112830750002
    MACKAY, Ian Barron
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    Administrateur
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    ScotlandBritishMotor Engineer406430001
    NOBLE, Alasdair George
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    Administrateur
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    ScotlandBritishChartered Accountant240301140001
    PARK, Douglas Ireland
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    Administrateur
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    United KingdomBritishCompany Director202387330002
    PARK, Graeme Thomas
    14 Bothwell Road
    Hamilton
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    Administrateur
    14 Bothwell Road
    Hamilton
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    ScotlandBritishGroup Manager172685990001
    PARK, Ross William
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    Administrateur
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    ScotlandBritishGeneral Manager93072080001
    CAMPBELL, Norman
    14 Blackpark Terrace
    IV3 8NE Inverness
    Inverness Shire
    Secrétaire
    14 Blackpark Terrace
    IV3 8NE Inverness
    Inverness Shire
    British75325670001
    DONNACHIE, Gerard
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    Secrétaire
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    212215570001
    MACLEAN, Thomas William
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    Secrétaire
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    British156095630001
    CAMPBELL, Norman
    14 Blackpark Terrace
    IV3 8NE Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    14 Blackpark Terrace
    IV3 8NE Inverness
    Inverness Shire
    BritishCompany Secretary75325670001
    CHALMERS, James
    2 Darnaway Road
    IV2 3LF Inverness
    Administrateur
    2 Darnaway Road
    IV2 3LF Inverness
    BritishGeneral Manager918250001
    CUNNINGHAM, Francis John
    119 Duncan Drive
    IV30 2NH Elgin
    Administrateur
    119 Duncan Drive
    IV30 2NH Elgin
    BritishManaging Director918230001
    DONNACHIE, Gerard
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    Administrateur
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    United KingdomBritishAccountant602380003
    GRZESINSKI, Andrew
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    Administrateur
    14 Bothwell Road
    ML3 0AY Lanarkshire
    Park House
    Scotland
    ScotlandBritishManaging Director76217270003
    HAMILTON, William Francis Forbes
    66 Harbour Road
    Inverness
    IV1 1JX
    Administrateur
    66 Harbour Road
    Inverness
    IV1 1JX
    ScotlandBritishChairman686730001
    HAMILTON, William
    Bruaichnain
    Inverness
    Administrateur
    Bruaichnain
    Inverness
    BritishCa918320001
    WARING, Philip John
    129 Meadowspot
    EH10 5UY Edinburgh
    Administrateur
    129 Meadowspot
    EH10 5UY Edinburgh
    BritishOperations Director43847950002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur W.B.T. NOMINEES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Macrae & Dick Limited
    Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    14
    Scotland
    06 avr. 2016
    Bothwell Road
    ML3 0AY Hamilton
    14
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUk Register Of Companies
    Numéro d'enregistrementSc173701
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    W.B.T. NOMINEES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignation
    Créé le 15 mai 1987
    Livré le 20 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All monies owing to company by V.A.G. (united kingdom) LTD in respect of monies paid by the company to bmw (GB) LTD.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker
    Transactions
    • 20 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 15 juin 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 09 févr. 1983
    Livré le 18 févr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 févr. 1983Enregistrement d'une charge
    • 21 mai 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Letter of offset
    Créé le 08 sept. 1982
    Livré le 24 sept. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by macrae & dick LTD and/or another
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in the name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 sept. 1982Enregistrement d'une charge
    • 16 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Letter of offset
    Créé le 08 sept. 1982
    Livré le 17 sept. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by macrae & dick LTD and/or another
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in the name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 sept. 1982Enregistrement d'une charge
    • 16 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0