RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE)
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE) |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC077737 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE) ?
| Adresse du siège social | 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire Scotland Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE) ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE) ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordonnance du tribunal Scheme of arrangement | 8 pages | OC | ||||||||||
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office Dissolution by c/order effective 21/12/23 manual gazette issued | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Ordonnance du tribunal Diss by c/order | 8 pages | OC | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Christopher Allan Walker en tant qu'administrateur le 18 août 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Giselle Evette Varn en tant que directeur le 04 août 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Colin David Beddall en tant qu'administrateur le 31 juil. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gary Park en tant que directeur le 31 juil. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des détails de Schlumberger Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 juil. 2022 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mikki Victoria Corcoran en tant que directeur le 04 févr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Roman Higgins en tant que directeur le 30 juil. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Roman Higgins en tant que secrétaire le 30 juil. 2021 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Mikki Victoria Corcoran le 15 mars 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Giselle Evette Varn le 15 mars 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Peregrine House Peregrine Road Westhill Business Park, Westhill Aberdeenshire Scotland AB32 6JL à 1 Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill Aberdeen, Aberdeenshire Scotland AB32 6TQ le 15 mars 2021 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mrs Giselle Evette Varn en tant qu'administrateur le 18 janv. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 juin 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Smoker en tant que secrétaire le 29 mai 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mark Roman Higgins en tant que secrétaire le 29 mai 2020 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Gary Park en tant qu'administrateur le 29 mai 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE) ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDDALL, Colin David, Mr. | Administrateur | Lauderdale Mansions Lauderdale Road W9 1LX London 29 United Kingdom | United Kingdom | British | 287316070001 | |||||
| WALKER, Christopher Allan | Administrateur | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | American | 299227560001 | |||||
| BRUCE, Gordon Alexander | Secrétaire | 18 Reidford Gardens Drumoak AB31 5AW Banchory Kincardineshire | British | 120448390001 | ||||||
| DROY MOORE, Pauline | Secrétaire | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 168150570002 | |||||||
| HENDRY, Eric George | Secrétaire | School Road Newmachar AB21 0WB Aberdeen 19 Aberdeenshire United Kingdom | British | 139588340001 | ||||||
| HIGGINS, Mark Roman | Secrétaire | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | 270743080001 | |||||||
| LEYS, Michael Cheyne | Secrétaire | 125 Hamilton Place AB2 4BD Aberdeen | British | 3742210004 | ||||||
| SMOKER, Simon | Secrétaire | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 0NZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | 203976100001 | |||||||
| BARR, Lawrence Robert | Administrateur | Findon AB12 4RL Aberdeen Blackhill Steading East Aberdeenshire Great Britain | United Kingdom | British | 96384280001 | |||||
| BERG, Jorgen | Administrateur | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | United Kingdom | Danish | 177176120001 | |||||
| BOYAULT, Gwenola Jacqueline Stephanie | Administrateur | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | French | 216352570001 | |||||
| BRUCE, Gordon Alexander | Administrateur | 18 Reidford Gardens Drumoak AB31 5AW Banchory Kincardineshire | British | 120448390001 | ||||||
| BRUCE, Ronald James | Administrateur | Badentoy Industrial Park Portlethen Industrial Estate AB12 4YB Portlethen, Aberdeen Badentoy Avenue Scotland Scotland | United Kingdom | British | 67939110001 | |||||
| CHANDLER, Richard | Administrateur | 7310 Foster Island Drive Richmond Texas 77469 Usa | Usa | American | 113233060001 | |||||
| CORCORAN, Mikki Victoria | Administrateur | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | British | 261075650001 | |||||
| DUDMAN, Bryan Leigh | Administrateur | Cr 444 Waelder 78959 Texas 5974 Us | Usa | American | 137079030001 | |||||
| HENDRY, Eric George | Administrateur | School Road Newmachar AB21 0WB Aberdeen 19 Aberdeenshire United Kingdom | United Kingdom | British | 139588340001 | |||||
| HIGGINS, Mark Roman | Administrateur | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | England | British | 256940520001 | |||||
| HOEING-COSENTINO, Karin Annette | Administrateur | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ West Sussex Schlumberger House United Kingdom | Scotland | German | 183326450001 | |||||
| JOHNSTON, Gregory | Administrateur | Badentoy Industrial Park Portlethen Industrial Estate AB12 4YB Portlethen, Aberdeen Badentoy Avenue Scotland Scotland | United Kingdom | Irish | 172272950001 | |||||
| KIDD, Ryan Alexander | Administrateur | Buckingham Gate Gatwick Airport RH6 ONZ Gatwick Schlumberger House West Sussex United Kingdom | Scotland | British | 192568420001 | |||||
| LAU, Werner | Administrateur | Grange Lodge South Avenue Cults AB1 9LP Aberdeen Aberdeenshire | West German | 3742290001 | ||||||
| LEYS, Michael Cheyne | Administrateur | 15 West Cults Road Cults AB15 9HQ Aberdeen | Scotland | British | 3742210006 | |||||
| MARSH, David | Administrateur | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 171331520001 | |||||
| MCGACHIE, John | Administrateur | Badentoy Industrial Park Portlethen Industrial Estate AB12 4YB Portlethen, Aberdeen Badentoy Avenue Scotland Scotland | United Kingdom | British | 187731560001 | |||||
| MCROBERTS, James Greer | Administrateur | Alford House One Alford Place AB1 1YB Aberdeen | British | 53510790001 | ||||||
| NICHOLSON, Peter Duncan | Administrateur | The Lilies 20 Bath Street AB39 2DH Stonehaven | Scotland | British | 48078570002 | |||||
| PAISLEY, Martin William | Administrateur | Cairndow PH33 6SD Onich West Highlands | British | 113228990001 | ||||||
| PARK, Gary | Administrateur | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 270424580001 | |||||
| SMOKER, Simon | Administrateur | Buckingham Gate RH6 0NZ Gatwick Airport Schlumberger House West Sussex United Kingdom | England | British | 134158640002 | |||||
| STEINKAMP, Manfred Theodor | Administrateur | Westwinds Cammachmore Stonehaven Aberdeen | West German | 3742280001 | ||||||
| SUTTON, Neal | Administrateur | County Road 242 Shiro 77876 Texas P O Box 10 Usa | American | 50209290001 | ||||||
| VARN, Giselle Evette | Administrateur | Enterprise Drive, Westhill Industrial Estate Westhill AB32 6TQ Aberdeen, Aberdeenshire 1 Scotland Scotland | Scotland | American | 273564740002 | |||||
| WERNER, Richard | Administrateur | 3507 Newcastle Drive 77027 Houston Texas Usa | American | 50209320002 | ||||||
| WILDE, Geraldine | Administrateur | 2819 Hazy Hillside Ct 77345 Kingwood Tx Usa | Usa | American | 56051310001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE) ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlumberger Uk Limited | 06 avr. 2016 | Manor Royal RH10 9BU Crawley Minerva United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
RED BARON (OIL TOOLS RENTAL) LIMITED(THE) a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Créé le 23 nov. 1988 Livré le 01 déc. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Lease of ground on the southside of blackness avenue, altens industrial estate, aberdeen. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 14 nov. 1988 Livré le 21 nov. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 19 janv. 1984 Livré le 31 janv. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions 0.9 acres situated on or towards the south side of blackness avenue, altens industrial estate, aberdeen. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 09 sept. 1983 Livré le 20 sept. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0