MACKINNON'S OF DYCE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMACKINNON'S OF DYCE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC078409
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MACKINNON'S OF DYCE LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe MACKINNON'S OF DYCE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    48 Queens Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Aberdeenshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MACKINNON'S OF DYCE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MACKINNON'S OF DYCE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour MACKINNON'S OF DYCE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de réunion finale des créanciers

    8 pages4.17(Scot)

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:form 4.6(scot) notice of liquidator's statement of receipts and payments
    3 pagesLIQ MISC

    Changement d'adresse du siège social de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh Midlothian EH3 9WJ le 08 avr. 2011

    2 pagesAD01

    Ordonnance du tribunal avis de liquidation

    1 pagesCO4.2(Scot)

    Avis de liquidation

    1 pages4.2(Scot)

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Cashman en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Andrew Hannan en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 sept. 2010

    État du capital au 29 sept. 2010

    • Capital: GBP 300
    SH01

    Nomination de Mr David Alexander Robertson Adams en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    5 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    5 pagesMG03s

    Cessation de la nomination de William Rollason en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Gray en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Cashman en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2009 au 31 déc. 2009

    1 pagesAA01

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 30 sept. 2008

    5 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2007

    20 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    6 pages363a

    legacy

    12 pages288a

    Qui sont les dirigeants de MACKINNON'S OF DYCE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MOLYNEUX, Nicholas John
    168 Kenrick Road
    Mapperley
    NG3 6EX Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    168 Kenrick Road
    Mapperley
    NG3 6EX Nottingham
    Nottinghamshire
    British93529300001
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Queens Road
    AB15 4YE Aberdeen
    48
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Queens Road
    AB15 4YE Aberdeen
    48
    Aberdeenshire
    EnglandBritish55757700003
    HANNAN, Andrew
    Queens Road
    AB15 4YE Aberdeen
    48
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Queens Road
    AB15 4YE Aberdeen
    48
    Aberdeenshire
    EnglandBritish153976980001
    MACKINNON, Ewan Alisdair Duncan
    72 Carnie Avenue
    AB32 6HT Elrick
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    72 Carnie Avenue
    AB32 6HT Elrick
    Aberdeenshire
    British41745360003
    MACKINNON, Sheonagh Elizabeth Macfarlane
    Bluebells
    Mill Of Eigie
    AB23 8XR Balmedie
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    Bluebells
    Mill Of Eigie
    AB23 8XR Balmedie
    Aberdeenshire
    British656780003
    CASHMAN, David Peter Charles
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Midlothian
    EnglandBritish151553190001
    FORBES, Robert Mackinnon
    221 Wellhead Crescent
    Dyca
    Aberdeen
    Administrateur
    221 Wellhead Crescent
    Dyca
    Aberdeen
    British656800001
    GIDDINGS, Michael John
    3 Nailsworth Road
    Dorridge
    B93 8NS Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    3 Nailsworth Road
    Dorridge
    B93 8NS Solihull
    West Midlands
    British105128310002
    GRAY, Richard Kevin
    Skegby Lane
    Mansfield
    NG19 6QR Nottingham
    54
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Skegby Lane
    Mansfield
    NG19 6QR Nottingham
    54
    Nottinghamshire
    EnglandBritish151698490001
    HARRIS, Ian Michael Brian
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    Administrateur
    Meadowsteep
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish116885790001
    MACKINNON, Ewan Alisdair Duncan
    72 Carnie Avenue
    AB32 6HT Elrick
    Aberdeenshire
    Administrateur
    72 Carnie Avenue
    AB32 6HT Elrick
    Aberdeenshire
    British41745360003
    MACKINNON, Murray George Armistead
    Bluebells
    Mill Of Eigie
    AB23 8XR Balmedie
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Bluebells
    Mill Of Eigie
    AB23 8XR Balmedie
    Aberdeenshire
    British656790002
    MACKINNON, Sheonagh Elizabeth Macfarlane
    Bluebells
    Mill Of Eigie
    AB23 8XR Balmedie
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Bluebells
    Mill Of Eigie
    AB23 8XR Balmedie
    Aberdeenshire
    British656780003
    REDPATH, James
    16 Bosworth Way
    NG10 1EA Long Eaton
    Nottinghamshire
    Administrateur
    16 Bosworth Way
    NG10 1EA Long Eaton
    Nottinghamshire
    EnglandBritish123915050001
    ROLLASON, William Peter
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    Administrateur
    Jessop House
    98 Scudamore Road
    LE3 1TZ Leicester
    United KingdomBritish67354680003
    WARK, Christopher Ronald
    4 Kent Road
    Bellmill Parl
    ML4 3PN Bellshill
    Administrateur
    4 Kent Road
    Bellmill Parl
    ML4 3PN Bellshill
    British50312410003

    MACKINNON'S OF DYCE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 30 août 2007
    Livré le 06 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 06 sept. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Créé le 30 août 2007
    Livré le 06 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 06 sept. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Créé le 07 juin 2007
    Livré le 22 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Créé le 11 avr. 2007
    Livré le 25 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 25 avr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 11 avr. 2007
    Livré le 25 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage, including fixed charges and floating charge over all assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 25 avr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 juin 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 04 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 23 déc. 1997
    Livré le 09 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop at 4 church street, inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 janv. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 05 juil. 1984
    Livré le 13 juil. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 juil. 1984Enregistrement d'une charge
    • 19 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 16 août 1982
    Livré le 27 août 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 août 1982Enregistrement d'une charge

    MACKINNON'S OF DYCE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 févr. 2011Petition date
    01 oct. 2014Conclusion of winding up
    22 févr. 2011Commencement of winding up
    09 janv. 2015Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Graeme Cameron Smith
    34 Melville Street
    Edinburgh
    practitioner
    34 Melville Street
    Edinburgh
    Claire L Middlebrook
    34 Melville Street
    EH3 7HA Edinburgh
    practitioner
    34 Melville Street
    EH3 7HA Edinburgh
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0