ONE OPTICAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéONE OPTICAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC079016
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ONE OPTICAL LIMITED ?

    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières

    Où se situe ONE OPTICAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Kpmg Llp
    319 St Vincent Street
    G2 5AS Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ONE OPTICAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CLYDE OPTICAL COMPANY LIMITED07 juin 198207 juin 1982

    Quels sont les derniers comptes de ONE OPTICAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour ONE OPTICAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans une liquidation par le tribunal

    21 pagesWU15(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de C/O Kpmg Llp 191 West George Street Glasgow G2 2LJ à C/O Kpmg Llp 319 st Vincent Street Glasgow G2 5AS le 07 août 2018

    2 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    6 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de * Optics House Seath Road Rutherglen Glasgow South Lanarkshire G73 1RN* le 07 mars 2013

    2 pagesAD01

    Ordonnance du tribunal avis de liquidation

    1 pagesCO4.2(Scot)

    Avis de liquidation

    1 pages4.2(Scot)

    Nomination d'un liquidateur provisoire

    2 pages4.9(Scot)

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 janv. 2013

    État du capital au 11 janv. 2013

    • Capital: GBP 4,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2011

    8 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2011 au 30 nov. 2011

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Rhona Elizabeth Thomson Mcdonald le 31 déc. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Andrew Robert Mcdonald le 31 déc. 2011

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Robert Mcdonald le 31 déc. 2011

    2 pagesCH01

    legacy

    5 pagesMG01s

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2010

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2009

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    5 pagesMG01s

    Nomination de Mrs Rhona Elizabeth Thomson Mcdonald en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2008

    10 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de ONE OPTICAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCDONALD, Andrew Robert
    Erskine Road
    Whitecraigs
    G46 6TQ Glasgow
    No. 8
    Scotland
    Secrétaire
    Erskine Road
    Whitecraigs
    G46 6TQ Glasgow
    No. 8
    Scotland
    British345000007
    MCDONALD, Andrew Robert
    Erskine Road
    Whitecraigs
    G46 6TQ Glasgow
    No. 8
    Scotland
    Administrateur
    Erskine Road
    Whitecraigs
    G46 6TQ Glasgow
    No. 8
    Scotland
    ScotlandBritishWholesale Optician345000008
    MCDONALD, Rhona Elizabeth Thomson
    Erskine Road
    Whitecraigs
    G46 6TQ Glasgow
    No. 8
    Scotland
    Administrateur
    Erskine Road
    Whitecraigs
    G46 6TQ Glasgow
    No. 8
    Scotland
    ScotlandBritishNone58272620005
    MARSH, James Andrew
    Waukmill Farm
    Stonehouse Road
    ML10 6PL Strathaven
    Lanarkshire
    Administrateur
    Waukmill Farm
    Stonehouse Road
    ML10 6PL Strathaven
    Lanarkshire
    ScotlandBritishRepresentative872180003
    MCDONALD, Rhona Elizabeth Thomson
    Homelands Osborne Crescent
    Thorntonhall
    G74 5AE Glasgow
    Administrateur
    Homelands Osborne Crescent
    Thorntonhall
    G74 5AE Glasgow
    ScotlandBritishCompany Director58272620004
    MCDONALD, Robert
    61 Kinnaird Crescent
    Bearsden
    G61 2BN Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    61 Kinnaird Crescent
    Bearsden
    G61 2BN Glasgow
    Lanarkshire
    BritishWholesale Optician34350001
    MCLEOD, Stephen
    23 Ness Avenue
    PA5 0PF Johnstone
    Renfrewshire
    Administrateur
    23 Ness Avenue
    PA5 0PF Johnstone
    Renfrewshire
    BritishOperations Director85538630001
    MIDDLETON, Anne Swan
    Arkellin 73 Cawder Road
    Cumbernauld
    G68 0BF Glasgow
    Administrateur
    Arkellin 73 Cawder Road
    Cumbernauld
    G68 0BF Glasgow
    BritishCompany Director57180620001
    SMITH, James
    5 Auchengreoch Avenue
    PA5 0RJ Johnstone
    Renfrewshire
    Administrateur
    5 Auchengreoch Avenue
    PA5 0RJ Johnstone
    Renfrewshire
    BritishCompany Director38360340001
    SMITH, James
    5 Auchengreoch Avenue
    PA5 0RJ Johnstone
    Renfrewshire
    Administrateur
    5 Auchengreoch Avenue
    PA5 0RJ Johnstone
    Renfrewshire
    BritishManufacturing Optician38360340001

    ONE OPTICAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 25 août 2011
    Livré le 02 sept. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • West of Scotland Loan Fund
    Transactions
    • 02 sept. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Floating charge
    Créé le 16 oct. 2009
    Livré le 29 oct. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Absolute Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 29 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Floating charge
    Créé le 21 janv. 2005
    Livré le 07 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Comercial Services Limited
    Transactions
    • 07 févr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 03 août 2004
    Livré le 05 août 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • UK Steel Enterprise Limited
    Transactions
    • 05 août 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 oct. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 01 juil. 2004
    Livré le 07 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The lower flat of the two storey building in john street, dunoon, argyll & bute and an area of ground lying generally to the north of the building.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 25 juin 2004
    Livré le 05 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Optics house, 3/5 seath road, rutherglen LAN55912.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 15 avr. 2004
    Livré le 20 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 20 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 oct. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 25 mai 2001
    Livré le 07 juin 2001
    En cours
    Montant garanti
    £30,000
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • South Lanarkshire Council
    Transactions
    • 07 juin 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 juin 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 oct. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 29 nov. 1998
    Livré le 04 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    37 john street,dunoon,argyll.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 déc. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 19 janv. 1993
    Livré le 01 févr. 1993
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Lower flat with ground pertaining thereto known as 33 john street, dunoon.
    Personnes ayant droit
    • W.M. Mann & Co. (Investments) LTD
    Transactions
    • 01 févr. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 26 juil. 1989
    Livré le 02 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    799.5 sq. Mtrs. At seath road, rutherglen with buildings and other erections known as 3 & 5 seath road, rutherglen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 23 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 29 avr. 1987
    Livré le 06 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 23 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Instrument of charge
    Créé le 20 déc. 1982
    Livré le 30 déc. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,000 and all sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Scottish Development Agency
    Transactions
    • 30 déc. 1982Enregistrement d'une charge

    ONE OPTICAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 févr. 2013Petition date
    11 févr. 2013Commencement of winding up
    27 févr. 2013Conclusion of winding up
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Blair Carnegie Nimmo
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LJ
    provisional liquidator
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LJ
    Gerard Anthony Friar
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LJ
    provisional liquidator
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LJ
    Notesscottish-insolvency-info
    2
    DateType
    27 févr. 2013Petition date
    27 févr. 2013Commencement of winding up
    21 juil. 2021Conclusion of winding up
    01 déc. 2021Dissolved on
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Blair Carnegie Nimmo
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LJ
    practitioner
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LJ
    Gerard Anthony Friar
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LJ
    practitioner
    191 West George Street
    Glasgow
    G2 2LJ
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0