THE ROYCE CONSULTANCY LIMITED

THE ROYCE CONSULTANCY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE ROYCE CONSULTANCY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC082001
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE ROYCE CONSULTANCY LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe THE ROYCE CONSULTANCY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Earlston House Almondvale Business Park,
    Almondvale Way
    EH54 6GA Livingston
    West Lothian
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE ROYCE CONSULTANCY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ROYCE RECRUITMENT AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED01 mars 198301 mars 1983

    Quels sont les derniers comptes de THE ROYCE CONSULTANCY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour THE ROYCE CONSULTANCY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Cessation de la nomination de John Goodacre en tant que directeur le 29 sept. 2011

    2 pagesTM01

    État du capital au 24 oct. 2011

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    6 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    4 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    5 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    Qui sont les dirigeants de THE ROYCE CONSULTANCY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILSON, Michael Norman
    8 High Mead
    HA1 2TX Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    8 High Mead
    HA1 2TX Harrow
    Middlesex
    British73384020002
    WILSON, Michael Norman
    8 High Mead
    HA1 2TX Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    8 High Mead
    HA1 2TX Harrow
    Middlesex
    EnglandBritish73384020002
    MCPHERSON, Malcolm Henry
    88 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    88 Murrayfield Gardens
    EH12 6DQ Edinburgh
    Midlothian
    British35518120001
    PATE, George Wallace
    2 Inch Crescent
    EH48 1EU Bathgate
    West Lothian
    Secrétaire
    2 Inch Crescent
    EH48 1EU Bathgate
    West Lothian
    British290150001
    PRICE, Phillip John
    Home Meadow
    Terrace Road South
    RG42 4DS Binfield
    Berkshire
    Secrétaire
    Home Meadow
    Terrace Road South
    RG42 4DS Binfield
    Berkshire
    British52534490001
    BUSHNELL, Keith Alan
    Flat C 213 Archway Road
    Highgate
    N6 5BN London
    Administrateur
    Flat C 213 Archway Road
    Highgate
    N6 5BN London
    British50994300003
    CLARK, Harold William
    4 Henderland Road
    EH12 6BB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    4 Henderland Road
    EH12 6BB Edinburgh
    Midlothian
    British605280002
    EVANS, Hywel
    40/41 Pall Mall
    Saint James's
    SW1Y 5JG London
    Administrateur
    40/41 Pall Mall
    Saint James's
    SW1Y 5JG London
    British78065400002
    GOODACRE, John
    400 Deming Road
    Chapel Hill
    North Carolina 27514
    Usa
    Administrateur
    400 Deming Road
    Chapel Hill
    North Carolina 27514
    Usa
    UsaBritish1874930004
    HOGAN, Ian Crawford
    61 Great King Street
    EH3 6RP Edinburgh
    Administrateur
    61 Great King Street
    EH3 6RP Edinburgh
    British48550030002
    KAY, James David
    28 Greenbank Drive
    EH10 5RE Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    28 Greenbank Drive
    EH10 5RE Edinburgh
    Midlothian
    British605290002
    MCFARLANE, Graeme
    Grange House
    Slade Hill Gardens
    RG20 9FX Woolton Hill Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Grange House
    Slade Hill Gardens
    RG20 9FX Woolton Hill Newbury
    Berkshire
    British68393790002
    MCPHERSON, Malcolm Henry
    19 Ainslie Place
    EH3 6AU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    19 Ainslie Place
    EH3 6AU Edinburgh
    Midlothian
    British35518120002
    MEEK, Jerry
    4 Henderland Road
    EH12 6BB Edinburgh
    Administrateur
    4 Henderland Road
    EH12 6BB Edinburgh
    British55294200001
    MEIKLE, Judy
    Holly Lodge Bristol Gardens
    Portsmouth Road Putney Heath
    SW25 3TD London
    Administrateur
    Holly Lodge Bristol Gardens
    Portsmouth Road Putney Heath
    SW25 3TD London
    British605300001
    MORLEY, Christopher
    9 Cherry Tree Close
    HP14 4LP Hughenden Valley
    Buckinghamshire
    Administrateur
    9 Cherry Tree Close
    HP14 4LP Hughenden Valley
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish158681490001
    MORRIS, Donald William
    14 Henerdland Road
    EH12 6BB Edinburgh
    Administrateur
    14 Henerdland Road
    EH12 6BB Edinburgh
    ScotlandBritish92006530001
    PAGE, Robert Scott
    44 Barnes Green
    EH54 8PP Livingston
    West Lothian
    Administrateur
    44 Barnes Green
    EH54 8PP Livingston
    West Lothian
    British47726240002
    PATE, George Wallace
    2 Inch Crescent
    EH48 1EU Bathgate
    West Lothian
    Administrateur
    2 Inch Crescent
    EH48 1EU Bathgate
    West Lothian
    British290150001
    PHILLIPS, Christopher Richard
    16 Netherby Road
    Trinity
    EH5 3NA Edinburgh
    Administrateur
    16 Netherby Road
    Trinity
    EH5 3NA Edinburgh
    British56135120001
    WHITE, David Findlay
    Little Barlows
    Frieth
    RG9 6PR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Little Barlows
    Frieth
    RG9 6PR Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish62316810001

    THE ROYCE CONSULTANCY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 17 mars 1992
    Livré le 25 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop 36 great junction street, leith edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 mars 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 17 mars 1992
    Livré le 25 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop 185 morningside road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 mars 1992Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 nov. 1991
    Livré le 14 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Basement premises at 259 stafford streetedinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 nov. 1991Enregistrement d'une charge
    • 20 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 17 oct. 1991
    Livré le 23 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground and basement shop at 36 haymarketterrace, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 20 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 17 oct. 1991
    Livré le 23 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop premises at 2 haymarket terrace, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 20 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 19 août 1991
    Livré le 02 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 28 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 sept. 1990
    Livré le 09 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    25 stafford street edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 08 janv. 1990
    Livré le 15 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Shop 2 haymarket terrace edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 27 nov. 1989
    Livré le 12 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 09 oct. 1989
    Livré le 17 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    36 haymarket terrace edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 oct. 1989Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0