CAMERON PARK LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CAMERON PARK LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC082142 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CAMERON PARK LIMITED ?
| Adresse du siège social | 3-4 Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CAMERON PARK LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour CAMERON PARK LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Forde en tant que directeur le 31 juil. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 15 janv. 2020
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pages | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 79 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 juil. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Sean Michael Paterson en tant qu'administrateur le 24 avr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David James Tannahill en tant que directeur le 24 avr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 24 août 2018 au 31 déc. 2018 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 12 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 19 août 2017 | 3 pages | AA | ||||||||||
Notification de Punch Taverns (Dc) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 1 pages | PSC02 | ||||||||||
Modification des détails d'une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Tlt Scotland Limited 140 West George Street Glasgow G2 2HG à 3-4 Broadway Park South Gyle Broadway Edinburgh EH12 9JZ le 08 sept. 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Francesca Appleby en tant que secrétaire le 29 août 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Peter Dando en tant que directeur le 29 août 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Edward Michael Bashforth en tant que directeur le 29 août 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Forde en tant qu'administrateur le 29 août 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CAMERON PARK LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOORE, Christopher John | Administrateur | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 136853310001 | |||||
| MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge | Administrateur | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 112375050001 | |||||
| PATERSON, Sean Michael | Administrateur | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 United Kingdom | Scotland | British | 257892140001 | |||||
| APPLEBY, Francesca | Secrétaire | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191627670001 | |||||||
| BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Secrétaire | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
| HARRIS, Claire Louise | Secrétaire | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175482750001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Secrétaire | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| SKEATES, Alan John | Secrétaire | Rhelonie Jerusalem EH34 4BQ Pencaitland East Lothian Scotland | British | 649690003 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
| TYRRELL, Helen | Secrétaire | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161623690001 | |||||||
| AITKEN, Robert | Administrateur | Medway 7 The Dean EH40 3ED East Linton East Lothian Scotland | British | 16212230001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Administrateur | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
| CAMPBELL, Kenneth | Administrateur | Rosemount 9 Swansacre KY13 7TE Kinross Fife | British | 649700001 | ||||||
| DANDO, Stephen Peter | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| FORDE, David | Administrateur | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | Irish | 180590780001 | |||||
| HARDIE, James Allan | Administrateur | Bourtri 5 Glen Road Bridge Of Allan FK9 4PN Stirling Stirlingshire Scotland | Scotland | British | 649720001 | |||||
| JONES, Bruce Abbott | Administrateur | 1 Hall Drive DE13 8TF Hanbury Staffordshire | British | 29595900002 | ||||||
| KEMP, Deborah Jane | Administrateur | 6 Station Road Hampton In Arden B92 0BJ Solihull | United Kingdom | British | 79388130005 | |||||
| MACKENZIE, John Saffery | Administrateur | The Old Manse Elsrickle Biggar Scotland | British | 649730001 | ||||||
| MCDONALD, Robert James | Administrateur | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MCDONALD, Robert James | Administrateur | 24 Ross Avenue Dalgety Bay KY11 5YN Dunfermline Fife | British | 9489780002 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| TANNAHILL, David James | Administrateur | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | Scotland | British | 237381690001 | |||||
| WILKINSON, Anthony Eric | Administrateur | Bupton Grange Longford Lane Longford DE6 3DT Ashbourne Derbyshire | British | 4656080002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CAMERON PARK LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Uk Limited | 29 août 2017 | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Punch Taverns (Dc) Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
CAMERON PARK LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Créé le 18 sept. 1984 Livré le 04 oct. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Subjects lying in the parish of bonhill and county of dumbarton. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 24 mai 1984 Livré le 08 juin 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Subjects in the county of dumbarton. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0