SCHRODER UK MID CAP FUND PLC

SCHRODER UK MID CAP FUND PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSCHRODER UK MID CAP FUND PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société SC082551
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SCHRODER UK MID CAP FUND PLC ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe SCHRODER UK MID CAP FUND PLC ?

    Adresse du siège social
    C/O Shepherd & Wedderburn Llp
    9 Haymarket Square
    EH3 8FY Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SCHRODER UK MID CAP FUND PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SCHRODER UK MID & SMALL CAP FUND PLC30 mai 200330 mai 2003
    LEGGMASON INVESTORS ENTERPRISE PLC31 janv. 200131 janv. 2001
    MURRAY ENTERPRISE PLC18 août 198918 août 1989
    MURRAY ELECTRONICS PLC04 avr. 198304 avr. 1983

    Quels sont les derniers comptes de SCHRODER UK MID CAP FUND PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2027
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SCHRODER UK MID CAP FUND PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au14 avr. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation28 avr. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au14 avr. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour SCHRODER UK MID CAP FUND PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2025

    83 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 492,000
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    26 févr. 2026Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 450,125
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    08 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 484,500
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    08 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 393,875
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    01 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 421,375
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    01 déc. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 358,875
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    28 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 327,875
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    23 oct. 2025Clarification HMRC confirmation has been received that the appropriate stamp duty has been paid in relation to this transaction.

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    23 juil. 2025Clarification HMRC confirmation has been received that the appropriate stamp duty has been paid in relation to this transaction.

    legacy

    pagesANNOTATION

    Comptes intermédiaires établis au 31 mars 2025

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 avr. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2024

    73 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    A general meeting may not be called without minimum of 14 days notice 24/02/2025
    RES13

    Nomination de Mr Richard Curling en tant qu'administrateur le 24 févr. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Edwin Talbut en tant que directeur le 24 févr. 2025

    1 pagesTM01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Andrew Page en tant que directeur le 08 mars 2024

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolutions

    General meeting other than an annual general meeting may be called on not less than 14 clear days notice 08/03/2024
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Inscription de la charge SC0825510002, créée le 27 févr. 2024

    23 pagesMR01

    Inscription de la charge SC0825510003, créée le 27 févr. 2024

    23 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2023

    67 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SCHRODER UK MID CAP FUND PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
    London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    1
    England
    Secrétaire
    London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    1
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement1893220
    46683210003
    COLQUHOUN, Wendy Margaret
    9 Haymarket Square
    EH3 8FY Edinburgh
    C/O Shepherd & Wedderburn Llp
    Scotland
    Administrateur
    9 Haymarket Square
    EH3 8FY Edinburgh
    C/O Shepherd & Wedderburn Llp
    Scotland
    ScotlandBritish141531540001
    CURLING, Richard
    London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish332889570001
    GALBRAITH (NÉE DRIVER), Helen Mary
    9 Haymarket Square
    EH3 8FY Edinburgh
    C/O Shepherd & Wedderburn Llp
    Scotland
    Administrateur
    9 Haymarket Square
    EH3 8FY Edinburgh
    C/O Shepherd & Wedderburn Llp
    Scotland
    EnglandBritish294659110001
    MORLEY, Harry
    London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    1
    United Kingdom
    United Kingdom
    Administrateur
    London Wall Place
    EC2Y 5AU London
    1
    United Kingdom
    United Kingdom
    United KingdomBritish313027540001
    COGENT SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    55 Moorgate
    EC2R 6PA London
    Secrétaire
    55 Moorgate
    EC2R 6PA London
    68895450001
    MCCLURE NAISMITH
    292 St Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    292 St Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    Lanarkshire
    397310002
    MURRAY JOHNSTONE LIMITED
    7 West Nile Street
    G1 2PX Glasgow
    Secrétaire
    7 West Nile Street
    G1 2PX Glasgow
    27580001
    BARNWELL, Peter George
    10 Custom House Lane
    PL1 3TG Plymouth
    Devon
    Administrateur
    10 Custom House Lane
    PL1 3TG Plymouth
    Devon
    British20950530001
    BEAGLES, Rachel Anne
    c/o Shepherd And Wedderburn Llp
    Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8UL Edinburgh
    1
    Scotland
    Administrateur
    c/o Shepherd And Wedderburn Llp
    Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8UL Edinburgh
    1
    Scotland
    United KingdomBritish107336370001
    COUBROUGH, Charles Malcolm
    Tintoside
    Symington
    ML12 6HX Biggar
    Lanarkshire
    Administrateur
    Tintoside
    Symington
    ML12 6HX Biggar
    Lanarkshire
    ScotlandBritish11769960001
    DAVIES, Clive Anthony
    The Old Rectory
    Mockbeggar Lane Ibsley
    BH24 3PR Fordingbridge
    Hampshire
    Administrateur
    The Old Rectory
    Mockbeggar Lane Ibsley
    BH24 3PR Fordingbridge
    Hampshire
    United KingdomBritish116413120001
    DOBIE, Clare Juliet
    c/o Shepherd And Wedderburn Llp
    Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8UL Edinburgh
    1
    Scotland
    Administrateur
    c/o Shepherd And Wedderburn Llp
    Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8UL Edinburgh
    1
    Scotland
    EnglandBritish89073320001
    GOODWIN, Matthew Dean, Sir
    87 Kelvin Court
    G12 0AH Glasgow
    Administrateur
    87 Kelvin Court
    G12 0AH Glasgow
    ScotlandBritish56200004
    JOHNSTONE, Raymond, Sir
    Wards
    Gartocharn
    G83 8SB Alexandria
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Wards
    Gartocharn
    G83 8SB Alexandria
    Dunbartonshire
    British46265160001
    JONES, Christopher
    C/O Tods Murray Ws
    33 Bothwell Street
    G2 6NL Glasgow
    Administrateur
    C/O Tods Murray Ws
    33 Bothwell Street
    G2 6NL Glasgow
    United KingdomBritish33273230001
    MACLEOD, Hugh Roderick, Sir
    Flat 4
    14 Dawson Place
    W2 4TJ London
    Administrateur
    Flat 4
    14 Dawson Place
    W2 4TJ London
    British2785800001
    PACKE, Maxwell Gordon
    C/O Tods Murray Ws
    33 Bothwell Street
    G2 6NL Glasgow
    Administrateur
    C/O Tods Murray Ws
    33 Bothwell Street
    G2 6NL Glasgow
    United KingdomBritish47686490006
    PAGE, Andrew
    9 Haymarket Square
    EH3 8FY Edinburgh
    C/O Shepherd & Wedderburn Llp
    Scotland
    Administrateur
    9 Haymarket Square
    EH3 8FY Edinburgh
    C/O Shepherd & Wedderburn Llp
    Scotland
    EnglandBritish60486340002
    PETERS, Ross Stevenson
    Brae Of Auchendrane
    KA7 4TP Ayr
    Administrateur
    Brae Of Auchendrane
    KA7 4TP Ayr
    British128510001
    RICKMAN, Robert James
    c/o Shepherd And Wedderburn Llp
    Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8UL Edinburgh
    1
    Scotland
    Administrateur
    c/o Shepherd And Wedderburn Llp
    Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8UL Edinburgh
    1
    Scotland
    EnglandBritish132821740002
    SALBU, Erik Oyvinol Jarl
    Holmendammen Terrasse 3
    FOREIGN Oslo 3 0387
    Norway
    Administrateur
    Holmendammen Terrasse 3
    FOREIGN Oslo 3 0387
    Norway
    Norwegian18939450001
    SANDERSON, Eric Fenton
    c/o Shepherd And Wedderburn Llp
    Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8UL Edinburgh
    1
    Scotland
    Administrateur
    c/o Shepherd And Wedderburn Llp
    Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8UL Edinburgh
    1
    Scotland
    ScotlandBritish126848980001
    TALBUT, Robert Edwin
    9 Haymarket Square
    EH3 8FY Edinburgh
    C/O Shepherd & Wedderburn Llp
    Scotland
    Administrateur
    9 Haymarket Square
    EH3 8FY Edinburgh
    C/O Shepherd & Wedderburn Llp
    Scotland
    EnglandBritish76587270002
    TIMMS, Peter Kenneth
    Millbrae
    Ascog
    PA20 9ET Rothesay
    Isle Of Bute
    Administrateur
    Millbrae
    Ascog
    PA20 9ET Rothesay
    Isle Of Bute
    United KingdomBritish32940002

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0