LABTECH SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | LABTECH SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC083070 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LABTECH SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Blackwood House Union Grove Lane AB10 6XU Aberdeen Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LABTECH SERVICES LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour LABTECH SERVICES LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 mai 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 04 juin 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 mai 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour LABTECH SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2024 | 14 pages | AA | ||
legacy | 122 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
Cessation de la nomination de Keith Moorhouse en tant que directeur le 25 juin 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Adrian Scott Hart en tant qu'administrateur le 25 juin 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 21 mai 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2023 | 16 pages | AA | ||
legacy | 139 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 21 mai 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2022 | 16 pages | AA | ||
legacy | 98 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 21 mai 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2021 | 24 pages | AA | ||
legacy | 86 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
Modification des détails de Centurion Uk Rentals & Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 juil. 2022 | 2 pages | PSC05 | ||
Déclaration de confirmation établie le 21 mai 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de LABTECH SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HART, Adrian Scott | Administrateur | Union Grove Lane AB10 6XU Aberdeen Blackwood House Scotland | England | British | 179652810001 | |||||
| LEASK, Euan Alexander Edmondston | Administrateur | Union Grove Lane AB10 6XU Aberdeen Blackwood House Scotland | Scotland | British | 167559380001 | |||||
| CHARLES, Catherine Gillian | Secrétaire | Greenbank Crescent East Tullos Industrial Estate AB12 3BG Aberdeen Unit 1, Logman Centre Scotland | 170851660001 | |||||||
| MAIR, Alexander Bruce | Secrétaire | Woodburn Avenue AB15 8JQ Aberdeen 19 | British | 92844720001 | ||||||
| MATHIASEN, Kurt Dahl | Secrétaire | c/o Specialist Services Holdings Limited Jebel Ali Industrial Area #1 2752 Dubai Centre Of Excellence United Arab Emirates | 207975400001 | |||||||
| ABERDEIN CONSIDINE & CO | Secrétaire | 8 & 9 Bon Accord Crescent AB11 6DN Aberdeen Grampian | 46377830001 | |||||||
| MD SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | C/0 Mcgrigors Llp 141 Bothwell Street G2 7EQ Glasgow | 900005110001 | |||||||
| RAEBURN CHRISTIE CLARK & WALLACE | Secrétaire | 12-16 Albyn Place AB10 1PS Aberdeen | 35622500003 | |||||||
| ARMSTRONG, Derek Charles | Administrateur | 22 Harvest Hill AB32 6PU Westhill Aberdeenshire | British | 68489530001 | ||||||
| BOND, Philip | Administrateur | Centre Of Excellence Jebel Ali Industrial Area #2 PO BOX 2752 Dubai C/O Specialist Services Holdings Limited United Arab Emirates | United Arab Emirates | British | 135894690001 | |||||
| BRUCE, Andrew | Administrateur | Strathnaver Station Road AB41 9AR Ellon Aberdeenshire | Scotland | British | 45324080001 | |||||
| BURGESS, John Graham | Administrateur | 4 Willow Tree Way AB31 5JQ Banchory Aberdeenshire | Banchory | British | 37612260003 | |||||
| COWIE, Julie Elizabeth | Administrateur | 5 Hartington Road AB10 6XT Aberdeen Aberdeenshire | United Kingdom | British | 111585570001 | |||||
| CRIGGIE, Raymond David | Administrateur | 44 Meadowside Inverbervie DD10 0RX Montrose Angus | British | 979980001 | ||||||
| DONALD, Daniel Leith | Administrateur | Dunlukin East Cammachmore AB39 3NQ Newtonhill Kincardineshire | Scotland | Scottish | 159628530001 | |||||
| DUCKETT, Michael | Administrateur | 266 Great Western Road AB10 6PJ Aberdeen Aberdeenshire | British | 67403940002 | ||||||
| FORBES, Robert Gordon | Administrateur | 7 Woodville Place SG14 3NX Hertford Hertfordshire | United Kingdom | British | 50248110002 | |||||
| GILL, Bruce William | Administrateur | 22 Norman Gray Park AB21 0ZR Blackburn Aberdeenshire | United Kingdom | British | 118503010001 | |||||
| HAMILTON, William | Administrateur | 8 Woodburn Avenue AB15 8JQ Aberdeen Murlingden | Scotland | British | 42252580002 | |||||
| KNIGHTS, David Charles | Administrateur | Centre Of Excellence Jebel Ali Industrial Area #2 PO BOX 2752 Dubai C/O Specialist Services Holdings Limited United Arab Emirates | United Arab Emirates | British | 165189940001 | |||||
| MACGREGOR, Roderick James | Administrateur | Delny Muir IV18 0NP Invergordon The Cherry Trees | Scotland | British | 61748240004 | |||||
| MAIR, Alexander Bruce | Administrateur | Woodburn Avenue AB15 8JQ Aberdeen 19 Aberdeenshire | Scotland | British | 92844720001 | |||||
| MAIR, David William | Administrateur | 61 Ruthrieston Road AB10 7JR Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | Scottish | 68489500001 | |||||
| MANSON, James | Administrateur | 13 St Keiran Crescent AB39 2GQ Stonehaven Kincardineshire | Scotland | British | 34380950003 | |||||
| MCGEEHAN, Christopher | Administrateur | Blackness Road Altens Industrial Estate AB12 3LH Aberdeen Aberdeenshire | United Kingdom | British | 118503110001 | |||||
| MCGEEHAN, Christopher | Administrateur | 131 Grandholm Drive Bridge Of Don AB22 8AE Aberdeen Aberdeenshire | United Kingdom | British | 118503110001 | |||||
| MOORHOUSE, Keith | Administrateur | Union Grove Lane AB10 6XU Aberdeen Blackwood House Scotland | Scotland | British | 121131030001 | |||||
| REITH, Derrick | Administrateur | Blackness Road Altens Industrial Estate AB12 3LH Aberdeen Aberdeenshire | United Kingdom | British | 153770090001 | |||||
| ROGERS, Ian Stuart | Administrateur | Centre Of Excellence Jebel Ali Industrial Area #2 PO BOX 2752 Dubai C/O Specialist Services Holdings Limited United Arab Emirates | United Arab Emirates | British | 165188770001 | |||||
| SCOTT, Eric Alexander | Administrateur | 2 Johnston Street AB30 1AN Laurencekirk Kincardineshire | British | 68489670001 | ||||||
| SOPER, David John | Administrateur | Stewart Road AB33 8UA Alford 3 Aberdeenshire | Scotland | British | 125496470001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LABTECH SERVICES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Uk Rentals & Services Holdings Limited | 01 févr. 2022 | Union Grove Lane AB10 6XU Aberdeen Blackwood House Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Hsbc Corporate Trustee Company (Uk) Limited | 28 oct. 2021 | Canada Square E14 5HQ London 8 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Specialist Services Holdings Ltd | 06 avr. 2016 | Jebel Ali Industrial Area #2 PO BOX 2752 Dubai C/O Centre Of Excellence United Arab Emirates. | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0