BLOSSOMVALE ROV SERVICES LTD

BLOSSOMVALE ROV SERVICES LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBLOSSOMVALE ROV SERVICES LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC083413
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BLOSSOMVALE ROV SERVICES LTD ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe BLOSSOMVALE ROV SERVICES LTD ?

    Adresse du siège social
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BLOSSOMVALE ROV SERVICES LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NEPTUNE ROV SERVICES LTD09 juil. 201009 juil. 2010
    NEPTUNE ROV SERVICES UK LTD01 juil. 201001 juil. 2010
    SUBMERSIBLE TECHNOLOGY SERVICES (U.K.) LIMITED15 janv. 200915 janv. 2009
    SUBMERSIBLE TELEVISION SURVEYS LIMITED03 janv. 198503 janv. 1985
    SUBMERSIBLE TELEVISION SURVEYS (HOLDINGS) LIMITED08 juin 198308 juin 1983

    Quels sont les derniers comptes de BLOSSOMVALE ROV SERVICES LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour BLOSSOMVALE ROV SERVICES LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 16 juin 2021

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 27 mai 2021

    • Capital: GBP 298,100
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Statuts

    10 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Kevin Alexander Stephen en tant que directeur le 08 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 21 août 2020 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2019

    23 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robin Nigel King le 06 déc. 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin Alexander Stephen le 06 déc. 2019

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Neptune Rov Services Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 nov. 2019

    2 pagesPSC05

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name15 nov. 2019

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration de confirmation établie le 21 août 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 21 août 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    23 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 mars 2017

    23 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    23 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BLOSSOMVALE ROV SERVICES LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LC SECRETARIES LIMITED
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Secrétaire
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrementSC299827
    112802860001
    KING, Robin Nigel
    110 Hay Street
    WA6 008 Subiaco
    C/O Suite 8
    Australia
    Administrateur
    110 Hay Street
    WA6 008 Subiaco
    C/O Suite 8
    Australia
    AustraliaAustralian,British162305310001
    LOUDEN, John Alexander
    Level 16
    140 St Georges Terrace
    6000 Perth
    Neptune Marine Services Limited
    Western Australia
    Australia
    Secrétaire
    Level 16
    140 St Georges Terrace
    6000 Perth
    Neptune Marine Services Limited
    Western Australia
    Australia
    168827320001
    WELSH, Graeme Gordon
    The Oaks 89 Station Road
    AB41 9AR Ellon
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    The Oaks 89 Station Road
    AB41 9AR Ellon
    Aberdeenshire
    Scottish830050002
    BURGESS, Neil Hamilton
    3 Burnside Walk
    AB34 5GJ Aboyne
    Aberdeenshire
    Administrateur
    3 Burnside Walk
    AB34 5GJ Aboyne
    Aberdeenshire
    British44098750001
    COWAN, Raymond Andrew William
    Hillcrest
    Kincairn, Blairs
    AB12 5YQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Hillcrest
    Kincairn, Blairs
    AB12 5YQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish65217400001
    DE LOUB, David Ross
    Reynolds Road
    WA 6153 Mount Pleasant
    186
    Australia
    Administrateur
    Reynolds Road
    WA 6153 Mount Pleasant
    186
    Australia
    AustraliaAustralian153380230001
    EDWARDS, Geoffrey
    Roseberry Avenue
    WA 6151 South Perth
    45
    Australia
    Administrateur
    Roseberry Avenue
    WA 6151 South Perth
    45
    Australia
    AustraliaAustralian127723500001
    JONES, Ian Quayle
    Craigowan
    Ballinluig
    PH9 0NE Pitlochry
    Perthshire
    Administrateur
    Craigowan
    Ballinluig
    PH9 0NE Pitlochry
    Perthshire
    United KingdomBritish64960017
    LANGE, Christian Mark
    Allen Street
    WA 6158 East Fremantle
    58
    Australia
    Administrateur
    Allen Street
    WA 6158 East Fremantle
    58
    Australia
    AustraliaAustralian127723440003
    LEGGET, Robert William Lindsay
    Danskine
    EH41 4PJ Gifford
    East Lothian
    Administrateur
    Danskine
    EH41 4PJ Gifford
    East Lothian
    United KingdomBritish184230001
    NAPIER, Colin Grant
    140 St Georges Terrace
    WA 6000 Perth
    Level 16
    Australia
    Administrateur
    140 St Georges Terrace
    WA 6000 Perth
    Level 16
    Australia
    AustraliaAustralian162305330002
    NEWMAN, Geoff
    St George's Terrace
    WA 6000 Perth
    Level 140
    Australia
    Administrateur
    St George's Terrace
    WA 6000 Perth
    Level 140
    Australia
    AustralianAustralian156779540001
    PETRIE, Roderick Mckenzie
    Clashfarquhar 37 Kings Road
    EH32 0NN Longniddry
    East Lothian
    Administrateur
    Clashfarquhar 37 Kings Road
    EH32 0NN Longniddry
    East Lothian
    ScotlandBritish1246700004
    PETRIE, Roderick Mckenzie
    Clashfarquhar 37 Kings Road
    EH32 0NN Longniddry
    East Lothian
    Administrateur
    Clashfarquhar 37 Kings Road
    EH32 0NN Longniddry
    East Lothian
    ScotlandBritish1246700004
    RANKIN, Bryan John
    4 Clarendon Crescent
    EH4 1PT Edinburgh
    Administrateur
    4 Clarendon Crescent
    EH4 1PT Edinburgh
    United KingdomBritish39843650001
    RODGER, William
    Chancery Grove
    Chancery Lane
    27b
    Singapore
    Administrateur
    Chancery Grove
    Chancery Lane
    27b
    Singapore
    SingaporeBritish1233290006
    RODGER, William
    275 Links Road
    AB24 5EZ Aberdeen
    Administrateur
    275 Links Road
    AB24 5EZ Aberdeen
    British1233290004
    STEPHEN, Kevin Alexander
    110 Hay Street
    WA6 008 Subiaco
    C/O Suite 8
    Australia
    Administrateur
    110 Hay Street
    WA6 008 Subiaco
    C/O Suite 8
    Australia
    United KingdomBritish118739170001
    TATE, Roland Hillary
    93 Village Court
    NE26 3QB Whitley Bay
    Administrateur
    93 Village Court
    NE26 3QB Whitley Bay
    EnglandBritish33373130001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BLOSSOMVALE ROV SERVICES LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleScotland
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc309559
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BLOSSOMVALE ROV SERVICES LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 20 nov. 2009
    Livré le 02 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Australia Bank Limited
    Transactions
    • 02 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 16 févr. 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 22 août 2002
    Livré le 11 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 sept. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Floating charge
    Créé le 05 juin 1997
    Livré le 12 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 12 juin 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 juil. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 nov. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 07 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 31 mars 1995
    Livré le 04 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £300,000
    Brèves mentions
    The whole of the super scorpio 9 R.O.V. system and related equipment of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Quayle Munro Holdings PLC
    Transactions
    • 04 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 avr. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 04 avr. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 juil. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 nov. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 08 nov. 1991
    Livré le 11 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Northern Investors Company PLC
    Transactions
    • 11 nov. 1991Enregistrement d'une charge
    • 01 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 08 nov. 1991
    Livré le 11 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • East of Scotland Industrial Investments PLC
    Transactions
    • 11 nov. 1991Enregistrement d'une charge
    • 03 avr. 1992Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 04 avr. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 nov. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 08 nov. 1991
    Livré le 11 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Northern Venture Partnership Fund
    Transactions
    • 11 nov. 1991Enregistrement d'une charge
    • 01 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 01 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 05 avr. 1990
    Livré le 18 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 01 avr. 1992Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 avr. 1992Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 04 avr. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Floating charge
    Créé le 19 nov. 1986
    Livré le 26 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • North Sea Assets PLC and East of Scotland Industrial Investments PLC
    Transactions
    • 26 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 27 nov. 1986Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mai 1990Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 avr. 1992Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 04 avr. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 04 avr. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 nov. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 14 sept. 1984
    Livré le 24 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0