DENHOLM CONTRACTING LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | DENHOLM CONTRACTING LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC083579 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DENHOLM CONTRACTING LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O JOHNSTON CARMICHAEL 7-11 Melville Street EH3 7PE Edinburgh Midlothian |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DENHOLM CONTRACTING LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2021 |
Quels sont les derniers dépôts pour DENHOLM CONTRACTING LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché) | 13 pages | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 18 Woodside Crescent Glasgow G3 7UL à 7-11 Melville Street Edinburgh Midlothian EH3 7PE le 19 oct. 2023 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Luke Preston le 11 oct. 2022 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 23 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Mcilduff en tant que directeur le 01 juil. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen David Jenkins en tant que directeur le 01 juil. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen Anthony Hill en tant que directeur le 01 juil. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kevon Peter Daymond en tant que directeur le 01 juil. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Luke Preston en tant qu'administrateur le 01 juil. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Damian Lee O'brien en tant que directeur le 01 juil. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Benjamin Donald Robert Maclehose en tant qu'administrateur le 01 juil. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed denholm industrial services LIMITED\certificate issued on 01/07/22 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Macgregor Mcfadyen en tant que directeur le 21 sept. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 23 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2021 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Craig David George Daniels en tant que secrétaire le 31 déc. 2020 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gregory Albert Hanson en tant que secrétaire le 31 déc. 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Thomas Mcilduff le 24 nov. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de DENHOLM CONTRACTING LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIELS, Craig David George | Secrétaire | Woodside Crescent G3 7UL Glasgow 18 United Kingdom | 278259340001 | |||||||
| MACLEHOSE, Benjamin Donald Robert | Administrateur | The Aspect 12 Finsbury Square EC2A 1AS London 8th Floor United Kingdom | England | British | 182762200005 | |||||
| PRESTON, Simon Luke | Administrateur | Woodside Crescent G3 7UL Glasgow 18 United Kingdom | United Kingdom | British | 208194360002 | |||||
| CARRINGTON, Linda | Secrétaire | 2 Camborne Place BA21 5DQ Yeovil Somerset | British | 101180630001 | ||||||
| HANSON, Gregory Albert | Secrétaire | 18 Woodside Crescent Glasgow G3 7UL | British | 66554810001 | ||||||
| HANSON, Gregory Albert | Secrétaire | 4 Greenlaw Drive Newton Mearns G77 6NL Glasgow | British | 66554810001 | ||||||
| PARKER, James Frederick Somerville | Secrétaire | The Moss Killearn G63 9LJ Glasgow Scotland | British | 11315830001 | ||||||
| PARKER, James Frederick Somerville | Secrétaire | The Moss Killearn G63 9LJ Glasgow Scotland | British | 11315830001 | ||||||
| POTTS, Graham Mark | Secrétaire | 8 Jasmine Close TA18 7DB Crewkerne Somerset | British | 2164270001 | ||||||
| SLACK, David William | Secrétaire | 33 Weavers Road PA2 9DP Paisley Renfrewshire | British | 786500001 | ||||||
| BEVERIDGE, Michael John | Administrateur | Park View 13 Park Circus G3 6AX Glasgow Apartment 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 73522190007 | |||||
| BONACCORSI, David | Administrateur | 44 Leapmoor Drive Wemyss Bay PA18 6BT Inverclyde | British | 28468160003 | ||||||
| CLUNIE, Patrick David | Administrateur | 10 Waterford Close TA6 6UN Bridgwater Somerset | England | British | 62004880001 | |||||
| DAYMOND, Kevon Peter | Administrateur | Woodside Crescent G3 7UL Glasgow 18 United Kingdom | United Kingdom | British | 169900900001 | |||||
| DAYMOND, Kevon Peter | Administrateur | Brooklands PL21 0EA Bittaford Devon | British | 100396440001 | ||||||
| DENHOLM, John Stephen | Administrateur | Balfron G63 0QP Glasgow Camoquhill Douglas | United Kingdom | British | 10253720001 | |||||
| DENHOLM, John Stephen | Administrateur | Camoquhill Douglas Balfron G63 0QP Glasgow | United Kingdom | British | 10253720001 | |||||
| DENHOLM, John Stephen | Administrateur | Camoquhill Douglas Balfron G63 0QP Glasgow | United Kingdom | British | 10253720001 | |||||
| DEVLIN, Charles | Administrateur | 177 Avontoun Park EH49 6QH Linlithgow West Lothian | British | 71102380001 | ||||||
| FISHER, Paul Matthew | Administrateur | Heathfield 53 Furzehatt Road PL9 8QX Plymstock Devon | England | British | 139740040001 | |||||
| GARDNER, Paul Vernon | Administrateur | Westhayes Westhill EX11 1UZ Ottery St Mary Devon | British | 69941350002 | ||||||
| GILBERT, Harry | Administrateur | Yew Tree House Nantwich Road, Wrenbury CW5 8ED Nantwich Cheshire | United Kingdom | British | 83163120001 | |||||
| HARRIS, Diana Jane | Administrateur | 60 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | United Kingdom | British | 34753120001 | |||||
| HARRIS, Diana Jane | Administrateur | 60 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | United Kingdom | British | 34753120001 | |||||
| HARRIS, Diana Jane | Administrateur | 60 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | United Kingdom | British | 34753120001 | |||||
| HARRIS, Diana Jane | Administrateur | 60 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | United Kingdom | British | 34753120001 | |||||
| HARRIS, Diana Jane | Administrateur | 60 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | United Kingdom | British | 34753120001 | |||||
| HARRIS, Diana Jane | Administrateur | 60 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | United Kingdom | British | 34753120001 | |||||
| HARRIS, Diana Jane | Administrateur | 60 Aytoun Road G41 5HE Glasgow | United Kingdom | British | 34753120001 | |||||
| HILL, Stephen Anthony | Administrateur | Barracks Close Lufton Trading Estate BA22 8RN Yeovil 1 Somerset United Kingdom | England | British | 224810240001 | |||||
| JENKINS, Stephen David | Administrateur | Woodside Crescent G3 7UL Glasgow 18 United Kingdom | United Kingdom | British | 208194440001 | |||||
| MACLEHOSE, Benjamin Donald Robert | Administrateur | The Aspect 12 Finsbury Square EC2A 1AS London 8th Floor United Kingdom | England | British | 182762200003 | |||||
| MALKIN, Andrew | Administrateur | 10 Cadell Loan Doune FK16 6BD Stirling Perthshire | British | 81846450001 | ||||||
| MCFADYEN, William Macgregor | Administrateur | Carmichael Street G51 2QU Glasgow 200 United Kingdom | United Kingdom | British | 182762210001 | |||||
| MCILDUFF, Thomas | Administrateur | Carmichael Street G51 2QU Glasgow 200 United Kingdom | United Kingdom | British | 122802910004 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DENHOLM CONTRACTING LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denholm Industrial Services (Holdings) Limited | 06 avr. 2016 | Woodside Crescent G3 7UL Glasgow 18 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
DENHOLM CONTRACTING LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 24 déc. 2009 Livré le 30 déc. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 24 déc. 2009 Livré le 30 déc. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 01 oct. 1983 Livré le 10 oct. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
DENHOLM CONTRACTING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0