SCOTTISH MARITIME MUSEUM TRUST

SCOTTISH MARITIME MUSEUM TRUST

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSCOTTISH MARITIME MUSEUM TRUST
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société SC083702
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SCOTTISH MARITIME MUSEUM TRUST ?

    • Activités des musées (91020) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe SCOTTISH MARITIME MUSEUM TRUST ?

    Adresse du siège social
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SCOTTISH MARITIME MUSEUM TRUST ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SCOTTISH MARITIME MUSEUM TRUST (IRVINE)27 juin 198327 juin 1983

    Quels sont les derniers comptes de SCOTTISH MARITIME MUSEUM TRUST ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SCOTTISH MARITIME MUSEUM TRUST ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au06 juil. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation20 juil. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au06 juil. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour SCOTTISH MARITIME MUSEUM TRUST ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2025

    37 pagesAA

    Nomination de Mr Matthew Moran en tant qu'administrateur le 31 oct. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Jilly Burns en tant qu'administrateur le 31 oct. 2025

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de William Gray en tant que secrétaire le 31 mars 2025

    1 pagesTM02

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    26 pagesMA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2024

    43 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Fiona Mcmeechin le 04 janv. 2024

    2 pagesCH01

    Nomination de Mrs Fiona Mcmeechin en tant qu'administrateur le 15 déc. 2023

    2 pagesAP01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2023

    46 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2022

    47 pagesAA

    Nomination de Mr Brian Tait en tant qu'administrateur le 23 août 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr John Kerr en tant qu'administrateur le 23 août 2023

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Elizabeth Anne Buchanan en tant que directeur le 31 déc. 2022

    1 pagesTM01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de John Robert Hume en tant que directeur le 18 déc. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Victor Reginald Emery en tant que directeur le 18 déc. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2021

    39 pagesAA

    Cessation de la nomination de Robert Daniel Hunter en tant que directeur le 21 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de SCOTTISH MARITIME MUSEUM TRUST ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BURNS, Jilly
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Administrateur
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    ScotlandBritish342081470001
    GALBRAITH, Lynn Margaret
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Administrateur
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    ScotlandBritish135765600001
    KERR, John
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Administrateur
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    ScotlandBritish312743900001
    MANN, David Allan
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Administrateur
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    ScotlandBritish153403980001
    MCMEECHAN, Fiona
    6 Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Lairds Forge
    Scotland
    Administrateur
    6 Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Lairds Forge
    Scotland
    ScotlandBritish317272290002
    MORAN, Matthew
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Administrateur
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    ScotlandBritish342092770001
    ROSS, Linda, Dr
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Administrateur
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    ScotlandBritish275004550001
    SINCLAIR, William Lawrie
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Administrateur
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    ScotlandBritish72430660001
    TAIT, Brian William
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Administrateur
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    ScotlandBritish152238150001
    WALKER, Eleanor
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Administrateur
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    ScotlandBritish137785760002
    EDWARDS, Jane Mary
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Secrétaire
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    161568870001
    GRANT, James Jenkins
    36a Townhead
    KA12 0BE Irvine
    Ayrshire
    Secrétaire
    36a Townhead
    KA12 0BE Irvine
    Ayrshire
    British99341520001
    GRAY, William, Mr.
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Secrétaire
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    273422710001
    GRAY, William, Mr.
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Secrétaire
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    174527310001
    MCKAY, Barry
    12 Goldpark Place
    EH54 6LW Livingston
    West Lothian
    Secrétaire
    12 Goldpark Place
    EH54 6LW Livingston
    West Lothian
    British104040940001
    MILLIGAN, William
    37 Finlas Avenue
    KA7 4SN Ayr
    Ayrshire
    Secrétaire
    37 Finlas Avenue
    KA7 4SN Ayr
    Ayrshire
    British605560001
    THOMSON, David Andrew
    241 Wilton Street
    G20 6DE Glasgow
    Secrétaire
    241 Wilton Street
    G20 6DE Glasgow
    British93516950001
    TILDESLEY, James Michael
    Old Mill Cottage
    DG10 9LD Moffat
    Dumfriesshire
    Secrétaire
    Old Mill Cottage
    DG10 9LD Moffat
    Dumfriesshire
    English34857760002
    TILDESLEY, James Michael
    Old Mill Cottage
    DG10 9LD Moffat
    Dumfriesshire
    Secrétaire
    Old Mill Cottage
    DG10 9LD Moffat
    Dumfriesshire
    English34857760002
    AGNEW, Denis, Dr
    17 Millburn Avenue
    G81 1EW Clydebank
    Dunbartonshire
    Administrateur
    17 Millburn Avenue
    G81 1EW Clydebank
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish91553540001
    BALDRY, Robert
    Grianan
    Wallace Road
    PA18 6AG Wemyss Bay
    Renfrewshire
    Administrateur
    Grianan
    Wallace Road
    PA18 6AG Wemyss Bay
    Renfrewshire
    ScotlandBritish80553850001
    BARR, Thomas
    35 Quarry Road
    KA12 0TN Irvine
    Ayrshire
    Administrateur
    35 Quarry Road
    KA12 0TN Irvine
    Ayrshire
    ScotlandBritish65607930001
    BAXTER, Brian Newland, Dr
    Dunelm Barclaven Road
    PA13 4DQ Kilmacolm
    Renfrewshire
    Administrateur
    Dunelm Barclaven Road
    PA13 4DQ Kilmacolm
    Renfrewshire
    British26301080001
    BEAGLEY, Peter
    7 Tarbert Drive
    EH54 9GZ Murieston Valley
    West Lothian
    Administrateur
    7 Tarbert Drive
    EH54 9GZ Murieston Valley
    West Lothian
    ScotlandBritish99608280002
    BEAGLEY, Peter
    123 Easter Bankton
    EH54 9BH Murieston
    West Lothian
    Administrateur
    123 Easter Bankton
    EH54 9BH Murieston
    West Lothian
    British99608280001
    BELCH, Alexander Ross, Sir
    Altnacraig House
    PA16 7XT Greenock
    Renfrewshire
    Administrateur
    Altnacraig House
    PA16 7XT Greenock
    Renfrewshire
    British185310001
    BLANE, Robert
    18 Laurel Place
    Grange
    KA1 2HB Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    18 Laurel Place
    Grange
    KA1 2HB Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritish39747170001
    BLYTH, Robert James, Dr
    6/63 Westcombe Park Road
    SE3 7QT London
    Administrateur
    6/63 Westcombe Park Road
    SE3 7QT London
    British99642300001
    BRYANT, Jonathan Andrew
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Administrateur
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    United KingdomBritish101358410003
    BUCHANAN, Elizabeth Anne
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    Administrateur
    Laird Forge Buildings
    Gottries Road
    KA12 8QE Irvine
    ScotlandBritish50543870002
    BURNISTON, William Alexander
    52 Bruntsfield Avenue
    KA13 6RZ Kilwinning
    Ayrshire
    Administrateur
    52 Bruntsfield Avenue
    KA13 6RZ Kilwinning
    Ayrshire
    British1156670001
    BUTLER, David
    2 Carrick Avenue
    KA7 2SN Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    2 Carrick Avenue
    KA7 2SN Ayr
    Ayrshire
    British538970001
    CABLE, Richard Malcolm
    Orchard House 18 High Street
    Castor
    PE5 7BB Peterborough
    Administrateur
    Orchard House 18 High Street
    Castor
    PE5 7BB Peterborough
    British65264230001
    CAMPBELL, Robert
    128 Strathayr Place
    KA8 0AY Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    128 Strathayr Place
    KA8 0AY Ayr
    Ayrshire
    British921130001
    CARSON, John
    3 Seaton Terrace
    KA12 0SU Irvine
    Ayrshire
    Administrateur
    3 Seaton Terrace
    KA12 0SU Irvine
    Ayrshire
    British427140001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour SCOTTISH MARITIME MUSEUM TRUST ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    22 janv. 2018La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.
    06 juil. 201622 janv. 2018La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0