HILTON LEISURE BREAKS LIMITED

HILTON LEISURE BREAKS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHILTON LEISURE BREAKS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC084212
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HILTON LEISURE BREAKS LIMITED ?

    • Activités des agences de voyages (79110) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe HILTON LEISURE BREAKS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ten
    George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HILTON LEISURE BREAKS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HILTON TRAVEL SERVICES LIMITED27 août 200227 août 2002
    TREND TRAVEL LIMITED07 avr. 198707 avr. 1987
    MACGREGOR TRAVEL LIMITED28 nov. 198428 nov. 1984
    ELONA LIMITED08 août 198308 août 1983

    Quels sont les derniers comptes de HILTON LEISURE BREAKS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HILTON LEISURE BREAKS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HILTON LEISURE BREAKS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    7 pages4.26(Scot)

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 4 Cadogan Square Cadogan Street Glasgow G2 7PH

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 4 Cadogan Square Cadogan Street Glasgow G2 7PH à Ten George Street Edinburgh EH2 2DZ le 25 août 2015

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 13 août 2015

    LRESSP

    État du capital au 02 juil. 2015

    • Capital: GBP 2
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Company nominal value of each issued ordinary share from £1 to £0.000004 19/06/2015
    RES13

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 juin 2015

    État du capital au 08 juin 2015

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Oded Lifschitz en tant que directeur le 11 mars 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Simon Robert Vincent en tant que directeur le 11 mars 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Oded Lifschitz le 24 juin 2014

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Mark Jonathan Way en tant que directeur le 29 août 2014

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2013

    11 pagesAA

    Cessation de la nomination de Elizabeth Jane Rabin en tant que directeur le 13 juin 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr. Stuart Beasley en tant qu'administrateur le 16 juin 2014

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 mai 2014

    État du capital au 30 mai 2014

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2012

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Nomination de Oded Lifschitz en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Rogers en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de HILTON LEISURE BREAKS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HLT SECRETARY LIMITED
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    125128960001
    BEASLEY, Stuart
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish188237620001
    PERCIVAL, James Owen
    Castle Hill
    HP4 1HE Berkhamsted
    18
    England
    United Kingdom
    Administrateur
    Castle Hill
    HP4 1HE Berkhamsted
    18
    England
    United Kingdom
    United KingdomBritish161274380001
    HUGHES, Barbara
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    Secrétaire
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    British45702460001
    MACKAY, William Donald
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    Secrétaire
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    British796730001
    MITCHELL, Andrew Ross
    Highwood
    PA13 4TA Kilmacolm
    Refrewshire
    Secrétaire
    Highwood
    PA13 4TA Kilmacolm
    Refrewshire
    British25359180002
    WATSON, David
    58 West Regent Street
    G2 2QZ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    58 West Regent Street
    G2 2QZ Glasgow
    Lanarkshire
    British583760001
    WILSON, Brian
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    Secrétaire
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    British125151140001
    LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    60530770001
    BRADLEY, Adrian Paul
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish90379240002
    BUSBY, James George William
    38 Cormorant Avenue
    Houston
    PA6 7LW Johnstone
    Renfrewshire
    Administrateur
    38 Cormorant Avenue
    Houston
    PA6 7LW Johnstone
    Renfrewshire
    British584980001
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    Administrateur
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritish780950001
    FRIEDMAN, Howard
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Usa106914780001
    GOSLING, Peter Charles
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    Administrateur
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    EnglandEnglish142633640001
    HAMILTON, Thomas Banks
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    Administrateur
    29 Montrose Avenue
    G52 4LA Hillington Park
    Glasgow
    British79846610001
    HARRIS, Anthony Richard
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    Administrateur
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    British64357620006
    HARVEY, Paul Victor
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    British116809270001
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Administrateur
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritish88628480001
    HUGHES, Andrew Lawrence
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    British109749210002
    HUGHES-RIXHAM, Ian
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    British143730250001
    LICHMAN, Laurence
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    Administrateur
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    British143730380001
    LIFSCHITZ, Oded
    NW8 9RF London
    Flat 52, The Yoo Building
    England
    England
    Administrateur
    NW8 9RF London
    Flat 52, The Yoo Building
    England
    England
    United KingdomAustralian / Israeli172992020002
    LYLE, Gordon William
    Aragorn House
    Stylecroft Road
    HP8 4HZ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Aragorn House
    Stylecroft Road
    HP8 4HZ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish143730330001
    MACDONALD, Donald John
    Cardrona
    Glen Road
    FK15 0DT Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    Cardrona
    Glen Road
    FK15 0DT Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish557590001
    MACKAY, William Donald
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    Administrateur
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    British796730001
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    NEUMANN, Wolfgang
    Flat 4, 34 Holland Park
    W11 3TA London
    Administrateur
    Flat 4, 34 Holland Park
    W11 3TA London
    Austria87699600002
    PHILIP, John Crosbie
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish102495550001
    RABIN, Elizabeth Jane
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish125139540001
    ROGERS, John
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish162807030001
    SHILL, Rosemarie
    The Old School House
    High Street
    B95 5BN Henley In Arden
    Warwickshire
    Administrateur
    The Old School House
    High Street
    B95 5BN Henley In Arden
    Warwickshire
    United KingdomBritish89948030001
    STAKIS, Andros
    Glentyan House
    Glentyan Estate
    PA10 7JJ Kilbarchan
    Renfrewshire
    Administrateur
    Glentyan House
    Glentyan Estate
    PA10 7JJ Kilbarchan
    Renfrewshire
    British27237990001
    TALJAARD, Desmond Louis Mildmay
    59 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    Administrateur
    59 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish215884620001
    TAYLOR, Hugh Matthew
    5 Amberden Avenue
    N3 3BJ London
    Administrateur
    5 Amberden Avenue
    N3 3BJ London
    United KingdomBritish127621330001
    VINCENT, Simon Robert
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish102638930001

    HILTON LEISURE BREAKS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 14 août 1991
    Livré le 03 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Stakis Public Limited Company
    Transactions
    • 03 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 17 sept. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 14 août 1991
    Livré le 03 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC as Agent & Trustee
    Transactions
    • 03 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 19 janv. 1996Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 20 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    HILTON LEISURE BREAKS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 août 2015Commencement of winding up
    23 sept. 2016Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0