CSC FOREST PRODUCTS (STERLING) LIMITED

CSC FOREST PRODUCTS (STERLING) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCSC FOREST PRODUCTS (STERLING) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC084824
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CSC FOREST PRODUCTS (STERLING) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CSC FOREST PRODUCTS (STERLING) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ernst & Young Llp
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CSC FOREST PRODUCTS (STERLING) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NORBORD INDUSTRIES (INTERNATIONAL) LTD.10 déc. 199110 déc. 1991
    NORBORD-HIGHLAND LTD.22 juil. 199122 juil. 1991
    HIGHLAND FOREST PRODUCTS LIMITED29 sept. 198329 sept. 1983

    Quels sont les derniers comptes de CSC FOREST PRODUCTS (STERLING) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour CSC FOREST PRODUCTS (STERLING) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    17 pages4.26(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 oct. 2016

    LRESSP

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Station Road Cowie Stirling FK7 7BQ

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Station Road Cowie Stirlingshire FK7 7BQ à Ernst & Young Llp Ten George Street Edinburgh EH2 2DZ le 12 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 avr. 2016

    État du capital au 11 avr. 2016

    • Capital: GBP 100.317
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alan Gordon Mcmeekin le 19 mars 2016

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 mars 2015

    État du capital au 31 mars 2015

    • Capital: GBP 100.317
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alan Gordon Mcmeekin le 31 mars 2015

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 mars 2014

    État du capital au 25 mars 2014

    • Capital: GBP 100.317
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Alan Gordon Mcmeekin le 10 avr. 2013

    1 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    État du capital au 26 juil. 2012

    • Capital: GBP 99.99666
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium account be hereby cancelled 12/07/2012
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CSC FOREST PRODUCTS (STERLING) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCMEEKIN, Alan Gordon
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Ernst & Young Llp
    Secrétaire
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Ernst & Young Llp
    BritishDirector - Finance & Logistics133502280001
    MCLEISH, Frederick Best
    Lynburn
    Claredon Place
    FK15 9HB Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    Lynburn
    Claredon Place
    FK15 9HB Dunblane
    Perthshire
    United KingdomBritishGroup Purchasing Director47174040002
    MCMEEKIN, Alan Gordon
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Ernst & Young Llp
    Administrateur
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Ernst & Young Llp
    United KingdomBritishVp - Operations & Finance133502280001
    ARNOLD, Nicola Mhairi
    40 Kellie Wynd
    Kippendavie
    FK15 0NR Dunblane
    Secrétaire
    40 Kellie Wynd
    Kippendavie
    FK15 0NR Dunblane
    BritishAccountant68068540006
    HARPER, Alexander Hurry
    Varis 3 Muircote Road
    IV12 5NH Nairn
    Morayshire
    Secrétaire
    Varis 3 Muircote Road
    IV12 5NH Nairn
    Morayshire
    British995800002
    IRVINE, John Christopher
    2 Abbots Road
    FK3 8HX Grangemouth
    Stirlingshire
    Secrétaire
    2 Abbots Road
    FK3 8HX Grangemouth
    Stirlingshire
    British38442060001
    MCLEISH, Frederick Best
    8 Darroch Place
    IV12 4TA Nairn
    Secrétaire
    8 Darroch Place
    IV12 4TA Nairn
    British47174040001
    ARNOLD, Nicola Mhairi
    40 Kellie Wynd
    Kippendavie
    FK15 0NR Dunblane
    Administrateur
    40 Kellie Wynd
    Kippendavie
    FK15 0NR Dunblane
    BritishAccountant68068540006
    BYKHOVSKY, Arkadi Gregory
    Suite 700 4 King Street West
    M5H 3X1 Toronto
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    Suite 700 4 King Street West
    M5H 3X1 Toronto
    Ontario
    Canada
    CanadianPresident Noranda Forest Sales36446950001
    GAMMIERO, Dominic
    1166 Old Post Drive
    L6M 1A6 Oakville
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    1166 Old Post Drive
    L6M 1A6 Oakville
    Ontario
    Canada
    CanadianPresident44177370001
    HARPER, Alexander Hurry
    Varis 3 Muircote Road
    IV12 5NH Nairn
    Morayshire
    Administrateur
    Varis 3 Muircote Road
    IV12 5NH Nairn
    Morayshire
    British995800002
    IRVINE, John Christopher
    2 Abbots Road
    FK3 8HX Grangemouth
    Stirlingshire
    Administrateur
    2 Abbots Road
    FK3 8HX Grangemouth
    Stirlingshire
    BritishAccountant38442060001
    KENNY, Robert Timothy
    Suite 500
    1 Toronto Street Toronto Ontario M5c 2w4
    FOREIGN
    Canada
    Administrateur
    Suite 500
    1 Toronto Street Toronto Ontario M5c 2w4
    FOREIGN
    Canada
    CanadianPresident Noranda Forest15060060002
    KINSELLA, Jane
    4110 Claypine Rise
    L4W 3SZ Mississauga
    Ontario
    Administrateur
    4110 Claypine Rise
    L4W 3SZ Mississauga
    Ontario
    BritishVice President Finance & Admin32564160001
    LEWIS, Brian
    25 Bramble Drive
    Sneyd Park
    BS9 1RE Bristol
    Avon
    Administrateur
    25 Bramble Drive
    Sneyd Park
    BS9 1RE Bristol
    Avon
    BritishMd Noranda Forest Sales (Uk)2603700001
    MACDONALD, Kenneth Linn
    Suite 444 PO BOX 7
    Toronto Diminion Bank Tower
    M5K IA1 Toronto
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    Suite 444 PO BOX 7
    Toronto Diminion Bank Tower
    M5K IA1 Toronto
    Ontario
    Canada
    BritishPresident44177460001
    MACDONALD, Kenneth Linn
    Suite 444 PO BOX 7
    Toronto Diminion Bank Tower
    M5K IA1 Toronto
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    Suite 444 PO BOX 7
    Toronto Diminion Bank Tower
    M5K IA1 Toronto
    Ontario
    Canada
    BritishPresident44177460001
    MCELROY, David Charles
    274 Apring Garden Road
    Oakville On
    FOREIGN Canada
    Administrateur
    274 Apring Garden Road
    Oakville On
    FOREIGN Canada
    CanadianVice President37406160001
    STEVENSON, Jack Alan
    34 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    34 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    CanadianManaging Director53486660001
    STINSON, Thomas Gordon
    80 Alcorn Avenue
    M4V 1E4 Toronto
    Ontario
    Canada
    Administrateur
    80 Alcorn Avenue
    M4V 1E4 Toronto
    Ontario
    Canada
    CanadianCorp.Secretary81118520001
    TINDALL, Paul
    Suite 500
    One Toronto Street
    M5C 2W4 Toronto
    Ontario
    Administrateur
    Suite 500
    One Toronto Street
    M5C 2W4 Toronto
    Ontario
    BritishVice President2585300001
    WATSON, Robert
    Swinside Lamplugh Road
    CA13 0DP Cockermouth
    Cumbria
    Administrateur
    Swinside Lamplugh Road
    CA13 0DP Cockermouth
    Cumbria
    EnglandBritishManaging Director42682220002

    CSC FOREST PRODUCTS (STERLING) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 18 janv. 1994
    Livré le 27 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    10.335 hectares of ground at morayhill, dalcross, invernessshire as relative to feu disposition by moray estates development company LTD ifo highlands and islands development board dated 19TH march and recorded grs inverness 3RD may both 1984 under exception of 169 square metres.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 janv. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 14 janv. 1994
    Livré le 19 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 janv. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignment of lease rebates
    Créé le 22 mars 1990
    Livré le 05 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All right, title and interests of the company in and to any and all monies which are from time to time paid or payable to the company under or pursuant a lease & sub hire agreement.
    Personnes ayant droit
    • Kansallis-Osake-Pannki
    Transactions
    • 05 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 14 janv. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignment lease rebates
    Créé le 22 mars 1990
    Livré le 05 avr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Right, title and interest of the company in and to any and all moneys paid or payable to the company in respect of lease between nordic leasing limited and the company.
    Personnes ayant droit
    • Den Norske Credit Bank PLC
    Transactions
    • 05 avr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 08 nov. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 31 août 1984
    Livré le 18 sept. 1984
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nordic Leasing LTD
    Transactions
    • 18 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    Assignment
    Créé le 31 août 1984
    Livré le 18 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All right, title and interest of the company and in and to any and all moneys which are from time to time paid or payable to the company under or pursuant to either of two master hire agreements dated 31ST august, 1984 and made between the company and nll or under or pursuant to any hiring schedule entered into pursuant to either such master hire agreements including any moneys which the company would otherwise be entitled to retain from moneys paid in respect of insurance or sales proceeds.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nordic Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    • 29 nov. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Deed
    Créé le 31 août 1984
    Livré le 18 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All amounts for the time being standing to the credit of the account of the company numbered 44470088 designated highland forest products P.L.C. special deposit account nll with leopold joseph & sons limited including all benefits and proceeds thereof or of any renewal redesignation or extension thereof.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nordic Leasing LTD
    Transactions
    • 18 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    • 08 nov. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    CSC FOREST PRODUCTS (STERLING) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 oct. 2016Commencement of winding up
    07 oct. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0