DUDHOPE PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDUDHOPE PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC085429
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DUDHOPE PROPERTIES LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières
    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe DUDHOPE PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kmpg Llp Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DUDHOPE PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LESWAND09 nov. 198309 nov. 1983

    Quels sont les derniers comptes de DUDHOPE PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour DUDHOPE PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de passage de l'administration à la dissolution

    21 pages2.26B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    21 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    13 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    13 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    2 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    13 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    14 pages2.20B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.13B(SCOT)

    9 pages2.15B(Scot)

    Proposition réputée de l'administrateur

    1 pages2.16BZ(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    22 pages2.16B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de * 214 South Victoria Dock Road Dundee DD1 3BF Scotland* le 17 janv. 2013

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O C/O Pavillion Properties 86 Bell Street Dundee DD1 1HN Scotland* le 19 déc. 2012

    1 pagesAD01

    Nomination de Mrs Joanne Tarling en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ryan Letley en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2011

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alan Beaton en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Ryan William Letley en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Moira Beaton en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de * Stannergate House 41 Dundee Road West Broughty Ferry Dundee DD5 1NB* le 02 juil. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 mars 2012

    État du capital au 16 mars 2012

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * Chapelshade House 78-84 Bell Street Dundee Angus DD1 1HN United Kingdom* le 16 mars 2012

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de DUDHOPE PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TARLING, Joanne
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Kmpg Llp
    Administrateur
    Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EG Edinburgh
    Kmpg Llp
    PortugalBritish174513240001
    BEATON, Alan William
    Newstead 7 Forgan Way
    DD6 8JQ Newport On Tay
    Fife
    Secrétaire
    Newstead 7 Forgan Way
    DD6 8JQ Newport On Tay
    Fife
    British34472250002
    BEATON, Moira Garvie
    Forgan Way
    DD6 8JQ Newport-On-Tay
    7
    Fife
    United Kingdom
    Secrétaire
    Forgan Way
    DD6 8JQ Newport-On-Tay
    7
    Fife
    United Kingdom
    154930070001
    CRUICKSHANK, Alison
    The Treetops, 474 Perth Road
    DD2 1LL Dundee
    Secrétaire
    The Treetops, 474 Perth Road
    DD2 1LL Dundee
    British52155650002
    PATERSON, Elaine Phyllis
    Inglewood
    13 Reform Street
    DD6 9HX Tayport
    Fife
    Secrétaire
    Inglewood
    13 Reform Street
    DD6 9HX Tayport
    Fife
    British332810004
    BEATON, Alan William
    Newstead 7 Forgan Way
    DD6 8JQ Newport On Tay
    Fife
    Administrateur
    Newstead 7 Forgan Way
    DD6 8JQ Newport On Tay
    Fife
    United KingdomBritish34472250002
    CRUICKSHANK, Angus William
    The Treetops
    474 Perth Road
    DD2 1LR Dundee
    Administrateur
    The Treetops
    474 Perth Road
    DD2 1LR Dundee
    ScotlandBritish109711610001
    LETLEY, Paul David
    Dewars Mill
    KY16 9TY St. Andrews
    7
    Fife
    Administrateur
    Dewars Mill
    KY16 9TY St. Andrews
    7
    Fife
    United KingdomBritish141539760002
    LETLEY, Ryan William
    c/o C/O Pavillion Properties
    Bell Street
    DD1 1HN Dundee
    86
    Scotland
    Administrateur
    c/o C/O Pavillion Properties
    Bell Street
    DD1 1HN Dundee
    86
    Scotland
    ScotlandBritish158374580001
    MCDONALD, Ian Young
    1 Kerrs Lane
    Lochee
    DD2 3HA Dundee
    Tayside
    Administrateur
    1 Kerrs Lane
    Lochee
    DD2 3HA Dundee
    Tayside
    British1131420001
    PATERSON, Elaine Phyllis
    Inglewood
    13 Reform Street
    DD6 9HX Tayport
    Fife
    Administrateur
    Inglewood
    13 Reform Street
    DD6 9HX Tayport
    Fife
    ScotlandBritish332810004
    PATERSON, Raymond
    Pitalpin House
    Pitalpin Street
    DD2 2TT Lochee
    Dundee
    Administrateur
    Pitalpin House
    Pitalpin Street
    DD2 2TT Lochee
    Dundee
    ScotlandBritish1131430005

    DUDHOPE PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 18 août 2008
    Livré le 22 août 2008
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot 21 city quay, 214 south victoria dock road, dundee ANG51810.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 août 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 30 nov. 2007
    Livré le 06 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First floor flat, 86 peddie street, dundee.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 17 janv. 2006
    Livré le 20 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Right hand top floor house at 1 park avenue, dundee ANG23316.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 17 janv. 2006
    Livré le 20 janv. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Flats 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 3/2 & 3/3 at 287 hilltown, dundee ANG28945.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 janv. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 02 févr. 2005
    Livré le 11 févr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects known as 70 mains drive, dundee (title number ANG35543).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 févr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 02 févr. 2005
    Livré le 11 févr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects known as 5 mains drive, dundee (title number ANG35542).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 févr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 10 déc. 2004
    Livré le 15 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Southmost ground floor dwellinghouse at 13 north ellen street, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 10 déc. 2004
    Livré le 15 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Northmost third or top floor dwellinghouse at 13 north ellen street, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 02 déc. 2004
    Livré le 16 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2ND floor, 37 st andrews street, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 02 déc. 2004
    Livré le 11 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Flat 3/1, 93 peddie street, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 02 déc. 2004
    Livré le 09 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Northmost third floor flat, 25 ogilvie street, dundee ANG17102.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 02 déc. 2004
    Livré le 09 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Southmost house on third floor above 28 baldovan terrace, dundee ANG13581.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 09 sept. 2004
    Livré le 28 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Westmost first floor flat, 37 lyon street, dundee.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 28 sept. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 06 août 2004
    Livré le 19 août 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 19 août 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 27 mai 2004
    Livré le 29 mai 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 03 oct. 1997
    Livré le 13 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3RD floor westmost flat, 87 watson street, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 oct. 1997
    Livré le 13 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3RD floor eastmost flat, 87 watson street, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 oct. 1997
    Livré le 13 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1ST & 2ND floor flats at 28 victoria street, montrose.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 oct. 1997
    Livré le 13 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2ND floor middle flat, 69 strathmartine road, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 oct. 1997
    Livré le 13 oct. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Top floor southmost flat, 37 st andrews street, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 03 oct. 1997
    Livré le 13 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground floor northmost, 4 smith street, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 oct. 1997
    Livré le 13 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1ST floor westmost flat, 1B park street, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 mars 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 oct. 1997
    Livré le 13 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Southmost third floor flat, 50 provost road, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 oct. 1997
    Livré le 13 oct. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Top floor southmost flat, 23 ogilvie street, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 03 oct. 1997
    Livré le 13 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground floor southmost flat, 6 nelson street, dundee.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 août 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    DUDHOPE PROPERTIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 janv. 2012Administration started
    07 juil. 2015Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gary Steven Fraser
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    practitioner
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Blair Carnegie Nimmo
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    practitioner
    Kpmg
    Saltire Court
    EH1 2EG 20 Castle Terrace
    Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0