FORTH ESTUARY ENGINEERING LIMITED

FORTH ESTUARY ENGINEERING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFORTH ESTUARY ENGINEERING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC085639
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FORTH ESTUARY ENGINEERING LIMITED ?

    • Réparation et entretien de navires et bateaux (33150) / Industries manufacturières

    Où se situe FORTH ESTUARY ENGINEERING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Dales Properties (Scotland) Limited
    Blackhouse Industrial Estate
    AB42 1BN Peterhead
    Aberdeenshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FORTH ESTUARY ENGINEERING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TORRESDALE LIMITED23 nov. 198323 nov. 1983

    Quels sont les derniers comptes de FORTH ESTUARY ENGINEERING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour FORTH ESTUARY ENGINEERING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 14 août 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Ordonnance du tribunal

    Order of court - dissolution void
    1 pagesOC-DV

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2016

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 août 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Kerry Ann Antczak en tant que directeur le 13 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Kerry Ann Antczak le 24 nov. 2016

    2 pagesCH01

    Divers

    Second filed CS01 part 5
    26 pagesMISC

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01
    Annotations
    DateAnnotation
    10 oct. 2016Rectified The information on the form CS01 Part 5 has been replaced by a second filing on 10/10/2016

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 août 2015

    État du capital au 19 août 2015

    • Capital: GBP 18,000
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 août 2014

    État du capital au 20 août 2014

    • Capital: GBP 18,000
    SH01

    Nomination de Lc Secretaries Limited en tant que secrétaire le 15 juil. 2014

    2 pagesAP04

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mary Nicol le 11 avr. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Kerry Ann Antczak le 11 avr. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Maurice James Nicol le 11 avr. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael Milne le 11 avr. 2014

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Janess Adams en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de FORTH ESTUARY ENGINEERING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LC SECRETARIES LIMITED
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Secrétaire
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Johnstone House
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrementSC299827
    112802860001
    MILNE, Michael
    Airlie
    DD8 5NP Kirriemuir
    Baitlands House
    Angus
    Scotland
    Administrateur
    Airlie
    DD8 5NP Kirriemuir
    Baitlands House
    Angus
    Scotland
    ScotlandBritish132222610002
    NICOL, Mary
    Queens Road
    AB15 4YH Aberdeen
    112
    Scotland
    Administrateur
    Queens Road
    AB15 4YH Aberdeen
    112
    Scotland
    ScotlandBritish115390500002
    NICOL, Maurice James
    Queens Road
    AB15 4YH Aberdeen
    112
    Scotland
    Administrateur
    Queens Road
    AB15 4YH Aberdeen
    112
    Scotland
    ScotlandBritish60088050006
    ADAMS, Janess
    25 Clarendon Crescent
    EH49 6AW Linlithgow
    West Lothian
    Secrétaire
    25 Clarendon Crescent
    EH49 6AW Linlithgow
    West Lothian
    British35011780001
    EVANS, William Wilson
    133 South Street
    PA16 8TD Greenock
    Renfrewshire
    Secrétaire
    133 South Street
    PA16 8TD Greenock
    Renfrewshire
    British414930001
    HUGHES, Gerald John
    Ware House
    Ware Road
    EH39 4BN North Berwick
    East Lothian
    Secrétaire
    Ware House
    Ware Road
    EH39 4BN North Berwick
    East Lothian
    British114922340001
    HYND, Russell John
    56 Priorwood Road
    Cleveland Park Newton Mearns
    G77 6ZZ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    56 Priorwood Road
    Cleveland Park Newton Mearns
    G77 6ZZ Glasgow
    Lanarkshire
    British62990090002
    HBJ SECRETARIAL LIMITED
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Midlothian
    665080001
    ADAMS, Janess
    25 Clarendon Crescent
    EH49 6AW Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    25 Clarendon Crescent
    EH49 6AW Linlithgow
    West Lothian
    United KingdomBritish35011780001
    ANTCZAK, Kerry Ann
    Queens Road
    AB15 4YH Aberdeen
    110
    United Kingdom
    Administrateur
    Queens Road
    AB15 4YH Aberdeen
    110
    United Kingdom
    ScotlandBritish70754180006
    BROOSHOOFT, Frederick Michael Desmond
    Wycliffe House Snow Hill
    LE13 1PD Melton Mowbray
    Leicestershire
    Administrateur
    Wycliffe House Snow Hill
    LE13 1PD Melton Mowbray
    Leicestershire
    British27881830001
    CLARK, Thomas Andrew
    Clifton
    Kilbarchan Road
    PA11 3EG Bridge Of Weir
    Administrateur
    Clifton
    Kilbarchan Road
    PA11 3EG Bridge Of Weir
    British27503050001
    EVANS, William Wilson
    133 South Street
    PA16 8TD Greenock
    Renfrewshire
    Administrateur
    133 South Street
    PA16 8TD Greenock
    Renfrewshire
    ScotlandBritish414930001
    HUGHES, Gerald John
    Ware House
    Ware Road
    EH39 4BN North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Ware House
    Ware Road
    EH39 4BN North Berwick
    East Lothian
    United KingdomBritish114922340001
    HUGHES, Gerald John
    Ware House
    Ware Road
    EH39 4BN North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Ware House
    Ware Road
    EH39 4BN North Berwick
    East Lothian
    United KingdomBritish114922340001
    HYND, Russell John
    56 Priorwood Road
    Cleveland Park Newton Mearns
    G77 6ZZ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    56 Priorwood Road
    Cleveland Park Newton Mearns
    G77 6ZZ Glasgow
    Lanarkshire
    British62990090002
    KIRKPATRICK, Ian
    35 Chester Road
    IG7 6AH Chigwell
    Essex
    Administrateur
    35 Chester Road
    IG7 6AH Chigwell
    Essex
    United KingdomBritish31693560001
    LUNDY, Robert
    Langdene
    Moredun Road
    PA2 9LH Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    Langdene
    Moredun Road
    PA2 9LH Paisley
    Renfrewshire
    ScotlandBritish841310001
    PATERSON, Joseph
    21 Durham Avenue
    EH15 1PA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    21 Durham Avenue
    EH15 1PA Edinburgh
    Midlothian
    British48340001
    ROLASTON, Carl Geoffrey
    C/O Grangemouth Ship Repair
    Carron Dock
    FK3 8UH Grangemouth
    Carron Dock
    Administrateur
    C/O Grangemouth Ship Repair
    Carron Dock
    FK3 8UH Grangemouth
    Carron Dock
    United Arab EmiratesBritish65165500002
    SMITH, Michael Andrew
    Flat 1r, 198 Wilton Street
    G20 6BL Glasgow
    Administrateur
    Flat 1r, 198 Wilton Street
    G20 6BL Glasgow
    British65926290002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FORTH ESTUARY ENGINEERING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Blackhouse Industrial Estate
    Peterhead
    AB42 1BN Aberdeenshire
    C/O Dales Properties (Scotland) Limited
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Blackhouse Industrial Estate
    Peterhead
    AB42 1BN Aberdeenshire
    C/O Dales Properties (Scotland) Limited
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleScotland
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc163941
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    FORTH ESTUARY ENGINEERING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 08 mai 2002
    Livré le 17 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 20 mars 2000
    Livré le 29 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 29 mars 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 20 mars 2000
    Livré le 27 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee
    Transactions
    • 27 mars 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 26 nov. 1997
    Livré le 02 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 02 déc. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 mars 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Instrument of charge
    Créé le 18 avr. 1984
    Livré le 02 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £17,000 and all further sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Development Agency
    Transactions
    • 02 mai 1984Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 08 mars 1984
    Livré le 21 mars 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 mars 1984Enregistrement d'une charge
    • 18 nov. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0