KENNET LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKENNET LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC086158
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KENNET LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe KENNET LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Pinsent Masons Llp
    13 Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de KENNET LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour KENNET LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Paul Lane le 25 oct. 2019

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2018

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 sept. 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    État du capital au 30 août 2019

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Thomas Mckenzie Biggart en tant qu'administrateur le 11 mars 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Pinsent Masons Secretarial Limited en tant que secrétaire le 07 mars 2019

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de David Hathaway en tant que secrétaire le 07 mars 2019

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Graham Paul Timbers en tant que directeur le 12 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Harper Macleod Llp City Point 65 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HD à C/O Pinsent Masons Llp 13 Queens Road Aberdeen AB15 4YL le 21 déc. 2018

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Simon Paul Lane en tant qu'administrateur le 14 déc. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr William Bahlsen Bannister en tant qu'administrateur le 14 déc. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Steven John Back en tant que directeur le 15 oct. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Graham Paul Timbers en tant qu'administrateur le 11 oct. 2018

    2 pagesAP01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2018 au 31 déc. 2018

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 12 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Karen Juanita Dickens en tant que directeur le 22 juin 2018

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 01 oct. 2017

    7 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2017 au 30 sept. 2017

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 12 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de KENNET LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Secrétaire
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02318923
    76579530001
    BANNISTER, William Bahlsen
    13 Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    C/O Pinsent Masons Llp
    Scotland
    Administrateur
    13 Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    C/O Pinsent Masons Llp
    Scotland
    United KingdomBritish252731900001
    BIGGART, Thomas Mckenzie
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish215843640001
    LANE, Simon Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish252862090001
    BIRD, Edwin Arthur
    Hulver
    Dane O'Coys Road
    CM23 2JP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Hulver
    Dane O'Coys Road
    CM23 2JP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British55967160001
    CARLISLE, Christopher Arthur
    25 Fieldhead Road
    SK9 2NJ Wilmslow
    Cheshire
    Secrétaire
    25 Fieldhead Road
    SK9 2NJ Wilmslow
    Cheshire
    British59495470003
    DUFFIN, Fraser James
    Flat 46 Gainsborough Studios South
    1 Poole Street
    N1 5EE London
    Secrétaire
    Flat 46 Gainsborough Studios South
    1 Poole Street
    N1 5EE London
    British126363010001
    HANCOCK, Graham Wallace
    50 Connaught Place
    EH6 4RN Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    50 Connaught Place
    EH6 4RN Edinburgh
    Midlothian
    British989340001
    HATHAWAY, David
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    Secrétaire
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    British117227730001
    IQBAL, Damian Shameem
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    Secrétaire
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    British126363060001
    MUIR, James Michael
    The Old Schoolhouse
    Llanhennock
    NP6 1LT Gwent
    Secrétaire
    The Old Schoolhouse
    Llanhennock
    NP6 1LT Gwent
    British26418170001
    ROCHFORD, Michael Brendan
    Baytown
    The Ward
    Co Meath
    Secrétaire
    Baytown
    The Ward
    Co Meath
    Irish21588510001
    STANDING, Diane Abigail
    11 Queens Point
    Shandon
    G84 8QZ Helensburgh
    Argyll & Bute
    Secrétaire
    11 Queens Point
    Shandon
    G84 8QZ Helensburgh
    Argyll & Bute
    British71222570001
    STANDING, Diane Abigail
    19 North Street
    ML10 6JL Strathaven
    Lanarkshire
    Secrétaire
    19 North Street
    ML10 6JL Strathaven
    Lanarkshire
    British181870001
    BACK, Steven John
    c/o Malthurst Retail Limited
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Administrateur
    c/o Malthurst Retail Limited
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    United KingdomBritish205661380001
    BRANDT, Hans-Joachim
    Preusserstrasse 5
    22605 Hamburg
    Germany
    Administrateur
    Preusserstrasse 5
    22605 Hamburg
    Germany
    German56937100001
    DICKENS, Karen Juanita, Dr
    c/o Malthurst Retail Limited
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Administrateur
    c/o Malthurst Retail Limited
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    United KingdomBritish124061360001
    DUNLEAVY, Adrian James
    2 Hartley Road
    WA14 4AZ Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    2 Hartley Road
    WA14 4AZ Altrincham
    Cheshire
    British64307400001
    FLEMING, William
    The Gables
    4 St Andrew Avenue
    G71 8DL Bothwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    The Gables
    4 St Andrew Avenue
    G71 8DL Bothwell
    Lanarkshire
    British69282300001
    PEACOCK, Graham Frederick
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    Administrateur
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    United KingdomBritish5133310002
    ROCHFORD, Michael Brendan
    Baytown
    The Ward
    Co Meath
    Administrateur
    Baytown
    The Ward
    Co Meath
    Irish21588510001
    SCOTT, Richard Antony Cargill
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Administrateur
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    EnglandBritish107002130001
    STANDING, Ian Charles
    11 Queens Point
    Shandon
    G84 8QZ Helensburgh
    Argyll & Bute
    Administrateur
    11 Queens Point
    Shandon
    G84 8QZ Helensburgh
    Argyll & Bute
    British181890002
    THOMPSON, Brian Lane
    Rock Hill House Rock Hill
    OX7 5BA Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Rock Hill House Rock Hill
    OX7 5BA Chipping Norton
    Oxfordshire
    British56518620001
    TIMBERS, Graham Paul
    13 Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    C/O Pinsent Masons Llp
    Scotland
    Administrateur
    13 Queens Road
    AB15 4YL Aberdeen
    C/O Pinsent Masons Llp
    Scotland
    EnglandBritish127888240001
    TOBBELL, Susan Margaret
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    Administrateur
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    United KingdomBritish17957620003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KENNET LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Malthurst Retail Limited
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    06 avr. 2016
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement03313799
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    KENNET LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 20 janv. 1994
    Livré le 31 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All and whole a lease between ross motors (edinburgh) limited and kennet limited recorded grs 25/07/89.
    Personnes ayant droit
    • Texaco Limited
    Transactions
    • 31 janv. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 18 nov. 1993
    Livré le 25 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Central GA4RAGE, west mains road, east kilbride.
    Personnes ayant droit
    • Bp Oil UK Limited
    Transactions
    • 25 nov. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 27 déc. 1991
    Livré le 07 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    81
    Brèves mentions
    Lease over 2/40 ratcliffe terrace edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 janv. 1992Enregistrement d'une charge
    • 10 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 14 juin 1991
    Livré le 01 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Central garage west mains road east kilbride.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 09 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 juil. 1989
    Livré le 02 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £400,000 and all sums due
    Brèves mentions
    Lease agreement over 2/40 ratcliff terr. Edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Texaco LTD
    Transactions
    • 02 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 09 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 juil. 1986
    Livré le 05 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Two parts of 3 machan road, larkhall, lan 6940: lan 7063.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 09 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 juil. 1986
    Livré le 25 juil. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1 & 3 machan road larkhall lanarkshire.
    Personnes ayant droit
    • Texaco LTD
    Transactions
    • 25 juil. 1986Enregistrement d'une charge
    • 09 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Mandate
    Créé le 23 mai 1986
    Livré le 09 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The free proceeds of contribution of £46,000 and £34,000 by texaco LTD in respect of development of site at 1-3 machan road, larkhall.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 juin 1986Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 02 juil. 1984
    Livré le 12 juil. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Garage premises 1 machan rd larkhall.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 juil. 1984Enregistrement d'une charge
    • 09 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 21 mai 1984
    Livré le 01 juin 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 juin 1984Enregistrement d'une charge
    • 08 déc. 1993Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 mars 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 août 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0