SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED

SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC086166
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Tlt Llp
    140 West George Street
    G2 2HG Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    S&N PUBS AND RESTAURANTS LIMITED26 oct. 200126 oct. 2001
    SCOTTISH & NEWCASTLE RETAIL LIMITED18 juin 199118 juin 1991
    LAXERT LIMITED10 janv. 198410 janv. 1984

    Quels sont les derniers comptes de SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au22 août 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    11 pages4.26(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 12 janv. 2017

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 08 août 2016 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 14 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Lindsay Anne Keswick en tant que secrétaire le 25 avr. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Claire Susan Stewart en tant que secrétaire le 25 avr. 2016

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 22 août 2015

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jonathan Robert Langford en tant que directeur le 26 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Daryl Antony Kelly en tant que directeur le 26 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Lucy Jane Bell en tant que directeur le 26 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Kirk Dyson Davis en tant qu'administrateur le 21 déc. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Henry Jones en tant que secrétaire le 04 déc. 2015

    1 pagesTM02

    Période comptable actuelle raccourcie du 24 août 2016 au 30 avr. 2016

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 juil. 2015

    État du capital au 14 juil. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Patrick James Gallagher en tant que directeur le 23 juin 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 23 août 2014

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 21 York Place Edinburgh EH1 3EN à Tlt Llp 140 West George Street Glasgow G2 2HG le 01 sept. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 juil. 2014

    État du capital au 14 juil. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 17 août 2013

    3 pagesAA

    Nomination de Claire Susan Stewart en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Susan Rudd en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Henry Jones en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juil. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 15 juil. 2013

    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 18 août 2012

    3 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KESWICK, Lindsay Anne
    140 West George Street
    G2 2HG Glasgow
    Tlt Llp
    Secrétaire
    140 West George Street
    G2 2HG Glasgow
    Tlt Llp
    207523740001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    BOLTON, George Francis
    61 Comiston View
    EH10 6LZ Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    61 Comiston View
    EH10 6LZ Edinburgh
    Midlothian
    British6950001
    CUTHBERTSON, Colin
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    Secrétaire
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    British26369940001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Secrétaire
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Secrétaire
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592230001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172446760001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    Secrétaire
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    British80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181021800001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Secrétaire
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    BUBB, Stewart Edmund Conyers
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    Administrateur
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    British36779040001
    CRICHTON, Roger Wells
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Pitsford House West
    Manor Road, Pitsford
    NN6 9AR Northampton
    Northamptonshire
    British67937290001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Administrateur
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritish111108910001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DAVIDSON, Angus Neil
    High Camilty
    Harburn
    EH55 8RH West Calder
    Administrateur
    High Camilty
    Harburn
    EH55 8RH West Calder
    British26376890001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    EDWARDS, David James
    Greencroft 38 Dunbar Road
    EH41 3PJ Haddington
    East Lothian
    Administrateur
    Greencroft 38 Dunbar Road
    EH41 3PJ Haddington
    East Lothian
    British9489100001
    FLEMING, John William Robert
    The Garth
    Lands Lane
    HG5 9DE Knaresborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Garth
    Lands Lane
    HG5 9DE Knaresborough
    North Yorkshire
    British39827670001
    FRASER, Stanley Durward
    7 Murrayfield Drive
    EH12 6EB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    7 Murrayfield Drive
    EH12 6EB Edinburgh
    Midlothian
    British189330001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GEIB, Paul
    Redbourne
    Castle Hill
    SK10 4AS Prestbury
    Cheshire
    Administrateur
    Redbourne
    Castle Hill
    SK10 4AS Prestbury
    Cheshire
    British34477180001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    GRACE, David Allen
    Conservatory Apartments
    1 Park Avenue
    HG2 9BQ Harrogate
    Administrateur
    Conservatory Apartments
    1 Park Avenue
    HG2 9BQ Harrogate
    British67926560002
    HANNAH, Ian George
    White Dell Farm
    Belsize
    WD3 4NX Sarratt
    Hertfordshire
    Administrateur
    White Dell Farm
    Belsize
    WD3 4NX Sarratt
    Hertfordshire
    British37054780003
    HAUPT, Stephen Edward
    The Owls Nest
    Market Square, Lower Heyford
    OX6 3NY Bicester
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Owls Nest
    Market Square, Lower Heyford
    OX6 3NY Bicester
    Oxfordshire
    British68466580001
    HIELD, Timothy Peter
    20 Cluny Drive
    EH10 6DP Edinburgh
    Administrateur
    20 Cluny Drive
    EH10 6DP Edinburgh
    British26376950002
    HOLTHAM, Robert William
    The Coppice
    3 Dorridge Croft
    B93 8QL Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    The Coppice
    3 Dorridge Croft
    B93 8QL Solihull
    West Midlands
    British40415840002
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    IVELL, Robert Lewis
    Boltons Hill
    Barham Road
    PE28 0YT Spaldwick
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Boltons Hill
    Barham Road
    PE28 0YT Spaldwick
    Cambridgeshire
    United KingdomEnglish96389110001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St. Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    England
    06 avr. 2016
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St. Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement4872046
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 janv. 2017Commencement of winding up
    22 févr. 2019Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0