SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC086166 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Tlt Llp 140 West George Street G2 2HG Glasgow |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 22 août 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire | 11 pages | 4.26(Scot) | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 août 2016 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 14 juil. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Lindsay Anne Keswick en tant que secrétaire le 25 avr. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Claire Susan Stewart en tant que secrétaire le 25 avr. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 22 août 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Robert Langford en tant que directeur le 26 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Daryl Antony Kelly en tant que directeur le 26 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Lucy Jane Bell en tant que directeur le 26 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Kirk Dyson Davis en tant qu'administrateur le 21 déc. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Henry Jones en tant que secrétaire le 04 déc. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 24 août 2016 au 30 avr. 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Patrick James Gallagher en tant que directeur le 23 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 23 août 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 21 York Place Edinburgh EH1 3EN à Tlt Llp 140 West George Street Glasgow G2 2HG le 01 sept. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 17 août 2013 | 3 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Claire Susan Stewart en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Susan Rudd en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Henry Jones en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 14 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 18 août 2012 | 3 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Secrétaire | 140 West George Street G2 2HG Glasgow Tlt Llp | 207523740001 | |||||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| BOLTON, George Francis | Secrétaire | 61 Comiston View EH10 6LZ Edinburgh Midlothian | British | 6950001 | ||||||
| CUTHBERTSON, Colin | Secrétaire | 5 Hill Gardens LE16 9EB Market Harborough Leicestershire | British | 26369940001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Secrétaire | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Secrétaire | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Henry | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180592230001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Secrétaire | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172446760001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Secrétaire | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEVENS, Mark | Secrétaire | 5 Lyon Drive Murieston EH54 9HF Livingston West Lothian | British | 80951870001 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181021800001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Secrétaire | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Lucy Jane | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164754670001 | |||||
| BUBB, Stewart Edmund Conyers | Administrateur | Clare Cottage 42 Lammas Lane KT10 8PD Esher Surrey | British | 36779040001 | ||||||
| CRICHTON, Roger Wells | Administrateur | Pitsford House West Manor Road, Pitsford NN6 9AR Northampton Northamptonshire | British | 67937290001 | ||||||
| CUMMING, Johanna Louise | Administrateur | 18 Prospect Quay 98 Point Pleasant SW18 1PR London | United Kingdom | British | 111108910001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DAVIDSON, Angus Neil | Administrateur | High Camilty Harburn EH55 8RH West Calder | British | 26376890001 | ||||||
| DUTTON, Philip | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| EDWARDS, David James | Administrateur | Greencroft 38 Dunbar Road EH41 3PJ Haddington East Lothian | British | 9489100001 | ||||||
| FLEMING, John William Robert | Administrateur | The Garth Lands Lane HG5 9DE Knaresborough North Yorkshire | British | 39827670001 | ||||||
| FRASER, Stanley Durward | Administrateur | 7 Murrayfield Drive EH12 6EB Edinburgh Midlothian | British | 189330001 | ||||||
| GALLAGHER, Patrick James | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 205366190001 | |||||
| GEIB, Paul | Administrateur | Redbourne Castle Hill SK10 4AS Prestbury Cheshire | British | 34477180001 | ||||||
| GODWIN-BRATT, Robert James | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 170184800001 | |||||
| GRACE, David Allen | Administrateur | Conservatory Apartments 1 Park Avenue HG2 9BQ Harrogate | British | 67926560002 | ||||||
| HANNAH, Ian George | Administrateur | White Dell Farm Belsize WD3 4NX Sarratt Hertfordshire | British | 37054780003 | ||||||
| HAUPT, Stephen Edward | Administrateur | The Owls Nest Market Square, Lower Heyford OX6 3NY Bicester Oxfordshire | British | 68466580001 | ||||||
| HIELD, Timothy Peter | Administrateur | 20 Cluny Drive EH10 6DP Edinburgh | British | 26376950002 | ||||||
| HOLTHAM, Robert William | Administrateur | The Coppice 3 Dorridge Croft B93 8QL Solihull West Midlands | British | 40415840002 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Administrateur | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| IVELL, Robert Lewis | Administrateur | Boltons Hill Barham Road PE28 0YT Spaldwick Cambridgeshire | United Kingdom | English | 96389110001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spirit Retail Bidco Limited | 06 avr. 2016 | Westgate Street IP33 1QT Bury St. Edmunds Westgate Brewery Suffolk England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
SPIRIT GROUP RETAIL PUBS AND RESTAURANTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0