QA SCOTLAND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéQA SCOTLAND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC086402
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de QA SCOTLAND LIMITED ?

    • (7221) /

    Où se situe QA SCOTLAND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    32 South Gyle Crescent
    South Gyle Park
    EH12 9EB Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de QA SCOTLAND LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COMPUTERS FOR BUSINESS (SCOTLAND) LIMITED30 mai 198430 mai 1984
    OSE LIMITED25 janv. 198425 janv. 1984

    Quels sont les derniers comptes de QA SCOTLAND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 mai 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour QA SCOTLAND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    État du capital après une attribution d'actions au 26 mai 2010

    • Capital: GBP 2,402,650
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Adopt model articles 26/05/2010
    RES13

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Comptes annuels établis au 29 mai 2009

    10 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 30 mai 2008

    13 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 31 mai 2007

    13 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages225

    legacy

    1 pages225

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de QA SCOTLAND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JOHNSON, Ian Paul
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    British136279590001
    JOHNSON, Ian Paul
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    20 Anglesey Drive
    SK12 1BT Poynton
    Ringwood
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136279590001
    MACPHERSON, William Robert George
    Benenden
    TN17 4LG Cranbrook
    Little Nineveh
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Benenden
    TN17 4LG Cranbrook
    Little Nineveh
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish132097710001
    GIBSON, Colin John
    4 Fairhaven Close
    Tytherington
    SK10 2QG Macclesfield
    Cheshire
    Secrétaire
    4 Fairhaven Close
    Tytherington
    SK10 2QG Macclesfield
    Cheshire
    British72748350001
    HYAMS, Mitchell Spencer
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    British13800580002
    LUMB, Tony
    1 The Corner House
    Aimson Road West Timperley
    WA15 7XP Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    1 The Corner House
    Aimson Road West Timperley
    WA15 7XP Altrincham
    Cheshire
    British110543530001
    MCRITCHIE, Ruth Elizabeth
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    Secrétaire
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    British101309030001
    O'HARA, Thomas
    33 Stobs Drive
    Barrhead
    G78 1NX Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    33 Stobs Drive
    Barrhead
    G78 1NX Glasgow
    Lanarkshire
    British628700001
    ROSSINGTON, Paul Steven
    21 Barley Brook Meadow
    Sharples
    BL1 7HP Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    21 Barley Brook Meadow
    Sharples
    BL1 7HP Bolton
    Lancashire
    British18750870002
    TRAINER, Martin John
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    Secrétaire
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    British124180840001
    ATKIN, John Duncan
    20 Hallside Park
    WA16 8NQ Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    20 Hallside Park
    WA16 8NQ Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish4769830001
    BEAUMONT, John Richard
    The Manor House
    85 High Street
    RH16 2HN Lindfield
    Sussex
    Administrateur
    The Manor House
    85 High Street
    RH16 2HN Lindfield
    Sussex
    British92701330001
    BURGESS, Keith, Dr
    Hengrove
    The Chivery
    HP23 6LE Tring
    Hertfordshire
    Administrateur
    Hengrove
    The Chivery
    HP23 6LE Tring
    Hertfordshire
    British73570840001
    GIBSON, Colin John
    4 Fairhaven Close
    Tytherington
    SK10 2QG Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    4 Fairhaven Close
    Tytherington
    SK10 2QG Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish72748350001
    HYAMS, Mitchell Spencer
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Pipers Barn
    55 Copperkins Lane
    HP6 5RA Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish13800580002
    JEFFREY, James Martin
    36 Earlspark Drive
    Bieldside
    AB1 9AH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    36 Earlspark Drive
    Bieldside
    AB1 9AH Aberdeen
    Aberdeenshire
    British628740001
    KAUFFMAN, John
    The Grange
    Fryth Finchampstead
    RG40 3RN Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    The Grange
    Fryth Finchampstead
    RG40 3RN Wokingham
    Berkshire
    British113989000001
    MACINTOSH, Bruce Duncan
    8 Spylaw Road
    EH10 5BH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    8 Spylaw Road
    EH10 5BH Edinburgh
    Midlothian
    British19295830001
    MARTIN, Christian John
    Kingswood House
    Tag Lane Wargrave
    RG10 9ST Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Kingswood House
    Tag Lane Wargrave
    RG10 9ST Reading
    Berkshire
    EnglandBritish113992220001
    MATHER, James Stuart
    13 Sutherland Avenue
    Pollokshields
    G41 4JJ Glasgow
    Administrateur
    13 Sutherland Avenue
    Pollokshields
    G41 4JJ Glasgow
    ScotlandBritish49750800001
    MCRITCHIE, Ruth Elizabeth
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    Administrateur
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    United KingdomBritish101309030001
    SOUTHWORTH, David Robert
    Salmesbury 12 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    Salmesbury 12 Millwood Close
    Withnell Fold
    PR6 8AR Chorley
    Lancashire
    British6026950001
    STRANG, Alexander Sharp
    14 Douglas Gardens
    Bearsden
    G61 2SJ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    14 Douglas Gardens
    Bearsden
    G61 2SJ Glasgow
    Lanarkshire
    British628730001
    TRAINER, Martin John
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    Administrateur
    6 Stone Pine Road
    MK43 8GG Bromham
    Bedfordshire
    EnglandBritish124180840001
    WHITE, Joseph
    18 King Malcolm Close
    EH10 7JB Edinburgh
    Administrateur
    18 King Malcolm Close
    EH10 7JB Edinburgh
    British37142590002

    QA SCOTLAND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 01 juil. 1987
    Livré le 03 juil. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Book debts by way of a first floating charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kellock LTD
    Transactions
    • 03 juil. 1987Enregistrement d'une charge
    • 16 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Debenture
    Créé le 13 avr. 1987
    Livré le 20 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All book debts.
    Personnes ayant droit
    • Kellock LTD
    Transactions
    • 20 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 16 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 09 oct. 1986
    Livré le 20 oct. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 oct. 1986Enregistrement d'une charge
    • 16 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0