CNC REGIS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCNC REGIS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC086403
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CNC REGIS LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe CNC REGIS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    23 Carron House, Carron Way
    Cumbernauld
    G67 1ER Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CNC REGIS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REGIS & REGIS LIMITED04 déc. 198504 déc. 1985
    RAGLAN LIMITED25 janv. 198425 janv. 1984

    Quels sont les derniers comptes de CNC REGIS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour CNC REGIS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    5 pages4.26(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 avr. 2008

    LRESSP

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2006

    8 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    14 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2004

    14 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    10 pages410(Scot)

    legacy

    9 pages410(Scot)

    legacy

    9 pages410(Scot)

    legacy

    7 pages410(Scot)

    legacy

    7 pages410(Scot)

    legacy

    7 pages410(Scot)

    legacy

    3 pages410(Scot)

    legacy

    13 pages410(Scot)

    Qui sont les dirigeants de CNC REGIS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AVIS, Marie Annick
    12 Brighton Road
    KT15 1PJ Addlestone
    Surrey
    Secrétaire
    12 Brighton Road
    KT15 1PJ Addlestone
    Surrey
    British91430630002
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    Administrateur
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritish83224530001
    LOCKER, Robert John
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    Administrateur
    Beukenhof
    Tite Hill
    TW20 0NJ Englefield Green
    Surrey
    EnglandBritish155603490001
    SAMUEL, Jacqueline Emilie
    Shambala 14 Cloch Road
    PA19 1AB Gourock
    Renfrewshire
    Secrétaire
    Shambala 14 Cloch Road
    PA19 1AB Gourock
    Renfrewshire
    British682910001
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Secrétaire
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    British2667400002
    WESTON, Carole Linda
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    Secrétaire
    44 Stratford Road
    WD17 4NZ Watford
    British62673550003
    BOYCE, David James
    103 Clark Street
    ML6 6DU Airdrie
    Administrateur
    103 Clark Street
    ML6 6DU Airdrie
    ScotlandBritish738120001
    LEVER, Gary Thomas
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    Administrateur
    20 Richmond Mansions
    250 Old Brompton Road
    SW5 9HN London
    United KingdomBritish83224530001
    MAIS, Richard Jeremy Ian
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    79 Seal Hollow Road
    TN13 3RY Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish1464610001
    ROSE, Pamela Montgomery
    Tigh Na Mara 152 East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Tigh Na Mara 152 East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    Dunbartonshire
    British1003060002
    SAMUEL, Gayle
    Falt J The Middle Church
    Tay Street
    PH1 5LQ Perth
    Administrateur
    Falt J The Middle Church
    Tay Street
    PH1 5LQ Perth
    ScotlandBritish45221980001
    SAMUEL, Jacqueline Emilie
    Shambala 14 Cloch Road
    PA19 1AB Gourock
    Renfrewshire
    Administrateur
    Shambala 14 Cloch Road
    PA19 1AB Gourock
    Renfrewshire
    British682910001
    SAMUEL, Lloyd William Bain
    2 Great Western Terrace
    G12 0UP Glasgow
    Administrateur
    2 Great Western Terrace
    G12 0UP Glasgow
    British36600200001
    SAMUEL, William Leggate
    18 Muirhead Terrace
    ML1 2RD Motherwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    18 Muirhead Terrace
    ML1 2RD Motherwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish36600160001
    SAMUEL, William
    Shambala 14 Cloch Road
    PA19 1AB Gourock
    Renfrewshire
    Administrateur
    Shambala 14 Cloch Road
    PA19 1AB Gourock
    Renfrewshire
    British266600001
    UPTON, Richard
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    Administrateur
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish46440870005
    WALKER-ROBSON, Colin Laird
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    231 Waldegrave Road
    Strawberry Hill
    TW1 4TA Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritish2667400002

    CNC REGIS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignation of rents
    Créé le 22 avr. 2005
    Livré le 29 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Rents over subjects on south west side of south street, glasgow GLA15288.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 22 avr. 2005
    Livré le 29 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Rents over subjects on north east side of shottskirk road, shotts LAN112327.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Assignation of rents
    Créé le 22 avr. 2005
    Livré le 29 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Rent due over 298 clyde street, glasgow GLA89258.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 24 déc. 2004
    Livré le 06 janv. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects to south west side of south street, glasgow GLA15288.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 janv. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 24 déc. 2004
    Livré le 06 janv. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects on north east side of shottskirk road, shotts LAN12327.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 janv. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 24 déc. 2004
    Livré le 06 janv. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    298 clyde street & 11,13 & 15 dixon street, glasgow GLA89258.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 janv. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 16 déc. 2004
    Livré le 29 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with any finance document
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 16 déc. 2004
    Livré le 22 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 31 août 2000
    Livré le 13 sept. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due under the senior credit agreement dated 18 may 2000
    Brèves mentions
    0.342 hectares at kirkland yard, leven.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 21 juil. 2000
    Livré le 03 août 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.675 hectares at spittal, longniddrie.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 21 juil. 2000
    Livré le 03 août 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land on north of livingstone crescent, blantyre.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 21 juil. 2000
    Livré le 03 août 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Factory at shottskirk road, shotts.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 21 juil. 2000
    Livré le 03 août 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    91/93 glentanar road, balmore industrial estate, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 21 juil. 2000
    Livré le 03 août 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Custom house, 298 clyde street & 11,13 & 15 dixon street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 21 juil. 2000
    Livré le 03 août 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    95-97 glentanar road, balmore industrial estate, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 21 juil. 2000
    Livré le 03 août 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    614 dalmarnock road, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 21 juil. 2000
    Livré le 03 août 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Barclay curle complex, southwest side of south street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 21 juil. 2000
    Livré le 03 août 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land at east fulton farm, clippens road, linwood.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 11 juil. 2000
    Livré le 26 juil. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transactions
    • 26 juil. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 17 juil. 1997
    Livré le 30 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    6.14 hectares south west of south street,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 juil. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 juil. 1997
    Livré le 08 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All and whole those subjects comprising 16.11 hectares at shottskikr roadshotts lanarkshire.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 juil. 1997
    Livré le 08 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects lying on and to the south west side of south street,glasgow being 6.14 hectares with the use of the recess and quay on the river clyde.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 juil. 1997
    Livré le 08 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    298 clyde street & 11,13 & 15 dixon street,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 juil. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 juin 1997
    Livré le 16 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Anderston house,389 argyle street,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 juin 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 juin 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 oct. 1995
    Livré le 31 oct. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All and ewhole that area or plot of ground lying on the east side of shottskirk road, shotts, lanarkshire in the parish of shotts and county of lanark extending to sixteen point eight six hectares thereby.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Enterprise
    Transactions
    • 31 oct. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    CNC REGIS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 juin 2011Dissolved on
    30 avr. 2008Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0