KENMORE SALMON FARM LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKENMORE SALMON FARM LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC086756
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KENMORE SALMON FARM LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe KENMORE SALMON FARM LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8 Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de KENMORE SALMON FARM LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour KENMORE SALMON FARM LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration de confirmation établie le 24 déc. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 26 oct. 2020

    • Capital: GBP 1.9875
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Requisite entries in statutory records approved 07/10/2020
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 24 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Craig Anderson en tant que directeur le 23 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Jóhan Regin Jacobsen en tant qu'administrateur le 13 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Odd Eliasen en tant qu'administrateur le 13 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 8 Melville Crescent Edinburgh EH3 7LU Scotland à 8 Melville Crescent Edinburgh EH3 7JA le 13 mai 2019

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Excel House, 30 Semple Street Edinburgh EH3 8BL Scotland à 8 Melville Crescent Edinburgh EH3 7LU le 13 mai 2019

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Morisons Secretaries Limited en tant que secrétaire le 30 avr. 2019

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de C/O Morisons Llp 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8AN à Excel House, 30 Semple Street Edinburgh EH3 8BL le 30 avr. 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 janv. 2016

    État du capital au 11 janv. 2016

    • Capital: GBP 39,750
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de KENMORE SALMON FARM LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COX, Susan Margaret
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    ScotlandBritish98112250001
    ELIASEN, Odd
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    Faroe IslandsDanish265284660001
    JACOBSEN, Jóhan Regin
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    Faroe IslandsDanish265284920001
    AUCKLAND, Robert Ian
    Pinewood
    Grampian Terrace
    AB31 4JS Torphins Banchory
    Kincardineshire
    Secrétaire
    Pinewood
    Grampian Terrace
    AB31 4JS Torphins Banchory
    Kincardineshire
    British110880950001
    CROSSAN, Finlay George
    42 Bedford Place
    AB2 3NX Aberdeen
    Aberdeenshire
    Scotland
    Secrétaire
    42 Bedford Place
    AB2 3NX Aberdeen
    Aberdeenshire
    Scotland
    British35503670001
    HISLOP, Mitchell
    32 Langdykes Crescent
    Cove
    AB12 3HF Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    32 Langdykes Crescent
    Cove
    AB12 3HF Aberdeen
    Aberdeenshire
    British88287460001
    LIVINGSTONE, Linda Jean
    Hill Foot
    Shieldaig
    IV54 8XN Strathcarron
    Ross-Shire
    Secrétaire
    Hill Foot
    Shieldaig
    IV54 8XN Strathcarron
    Ross-Shire
    British902590001
    MACDONALD, Yvonne Frances
    21 West Kilbride Road
    KA24 5DZ Dalry
    Ayrshire
    Secrétaire
    21 West Kilbride Road
    KA24 5DZ Dalry
    Ayrshire
    British82618570002
    WESLEY, Alistair James
    11 Braidburn Crescent
    EH10 6EL Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    11 Braidburn Crescent
    EH10 6EL Edinburgh
    Midlothian
    British771140001
    WILSON, Robert
    3 Pikes Knowe Court
    Cardrona
    EH45 9LP Peebles
    Borders
    Secrétaire
    3 Pikes Knowe Court
    Cardrona
    EH45 9LP Peebles
    Borders
    British84079420001
    ANDERSON STRATHERN WS
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    Secrétaire
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    33516610002
    MORISONS SECRETARIES LIMITED
    Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Excel House, 30
    Scotland
    Secrétaire
    Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    Excel House, 30
    Scotland
    83549280002
    ALLAN, Alistair David Wishart
    Sandwood
    Sandy Loan
    EH31 2BH Gullane
    East Lothian
    Administrateur
    Sandwood
    Sandy Loan
    EH31 2BH Gullane
    East Lothian
    United KingdomBritish984960001
    ANDERSON, Craig
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    Administrateur
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    8
    Scotland
    ScotlandBritish179195860001
    AUCKLAND, Robert Ian
    Pinewood
    Grampian Terrace
    AB31 4JS Torphins Banchory
    Kincardineshire
    Administrateur
    Pinewood
    Grampian Terrace
    AB31 4JS Torphins Banchory
    Kincardineshire
    United KingdomBritish110880950001
    CAMERON, Harold John
    The Old Post Office
    Shieldaig
    IV54 8XM Strathcarron
    Ross-Shire
    Administrateur
    The Old Post Office
    Shieldaig
    IV54 8XM Strathcarron
    Ross-Shire
    British40243390001
    ERSKINE, Alistair Morgan
    Garvault Lodge
    Advie
    PH26 3LP Grantown On Spey
    Morayshire
    Administrateur
    Garvault Lodge
    Advie
    PH26 3LP Grantown On Spey
    Morayshire
    ScotlandBritish50316250001
    GARRETT, Edwin Charles
    The Beeches
    Banchory Devenick
    AB12 5YD Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    The Beeches
    Banchory Devenick
    AB12 5YD Aberdeen
    Aberdeenshire
    British38811750002
    HISLOP, Mitchell
    32 Langdykes Crescent
    Cove
    AB12 3HF Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    32 Langdykes Crescent
    Cove
    AB12 3HF Aberdeen
    Aberdeenshire
    British88287460001
    LIVINGSTONE, Donald
    Ardheslaig
    Shieldaig
    IV54 8XH Strathcarron
    Ross Shire
    Administrateur
    Ardheslaig
    Shieldaig
    IV54 8XH Strathcarron
    Ross Shire
    ScotlandBritish48400120002
    LIVINGSTONE, Kenneth
    Hill Foot
    Shieldaig
    IV54 8XN Strathcarron
    Ross-Shire
    Administrateur
    Hill Foot
    Shieldaig
    IV54 8XN Strathcarron
    Ross-Shire
    ScotlandBritish902560001
    MACDONALD, Yvonne Frances
    21 West Kilbride Road
    KA24 5DZ Dalry
    Ayrshire
    Administrateur
    21 West Kilbride Road
    KA24 5DZ Dalry
    Ayrshire
    ScotlandBritish82618570002
    MACGREGOR, Angus Alexander
    4 Temperance Brae
    Shieldaig
    IV54 8XM Strathcarron
    Ross-Shire
    Administrateur
    4 Temperance Brae
    Shieldaig
    IV54 8XM Strathcarron
    Ross-Shire
    British902580001
    MACGREGOR, John
    The Shack
    Shieldaig
    IV54 8XN Strathcarron
    Ross-Shire
    Administrateur
    The Shack
    Shieldaig
    IV54 8XN Strathcarron
    Ross-Shire
    United KingdomBritish762260001
    MARSHALL, Ian Paul
    68 Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    Administrateur
    68 Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    ScotlandBritish150818380001
    MASSON, John George
    499 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    499 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    Great BritainBritish657210001
    ODDSEN, Oddgeir
    101 Sinclair Street
    G84 9HX Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    101 Sinclair Street
    G84 9HX Helensburgh
    Dunbartonshire
    United KingdomNorwegian101119150002
    PARKER, James Frederick Somerville
    The Moss
    Killearn
    G63 9LJ Glasgow
    Scotland
    Administrateur
    The Moss
    Killearn
    G63 9LJ Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish11315830001
    WHITE, Clare Anne
    68 Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    Administrateur
    68 Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    ScotlandBritish68763280001
    WILSON, Robert
    68 Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    Administrateur
    68 Queen Street
    EH2 4NN Edinburgh
    Erskine House
    Scotland
    ScotlandBritish84079420001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KENMORE SALMON FARM LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    1
    Scotland
    06 avr. 2016
    Exchange Crescent
    Conference Square
    EH3 8AN Edinburgh
    1
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Acts (Various)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc055225
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    KENMORE SALMON FARM LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 12 sept. 1990
    Livré le 03 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land near kenmore, in the county of ross and cromarty.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 08 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 24 janv. 1985
    Livré le 01 févr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 févr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 18 août 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 31 août 1984
    Livré le 18 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Highland & Islands Dev. Board
    Transactions
    • 18 sept. 1984Enregistrement d'une charge
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0