BOUYGUES E&S CONTRACTING UK LIMITED

BOUYGUES E&S CONTRACTING UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBOUYGUES E&S CONTRACTING UK LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC087174
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BOUYGUES E&S CONTRACTING UK LIMITED ?

    • Autres travaux de construction spécialisés n.d.a. (43999) / Construction

    Où se situe BOUYGUES E&S CONTRACTING UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Excel House Europoint Office Park 1 Renshaw Place
    Holytown
    ML1 4UF Motherwell
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BOUYGUES E&S CONTRACTING UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ETDE CONTRACTING LIMITED21 oct. 200921 oct. 2009
    THERMAL TRANSFER LIMITED24 mars 199924 mars 1999
    THERMAL TRANSFER (HOLDINGS) LIMITED16 mars 198416 mars 1984

    Quels sont les derniers comptes de BOUYGUES E&S CONTRACTING UK LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BOUYGUES E&S CONTRACTING UK LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au18 janv. 2027
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation01 févr. 2027
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au18 janv. 2026
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour BOUYGUES E&S CONTRACTING UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 18 janv. 2026 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2024

    43 pagesAA

    Nomination de Mr Gaël Falchier en tant qu'administrateur le 21 mai 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Thomas Jung en tant qu'administrateur le 21 mai 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephane Stoll en tant que directeur le 21 mai 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Dmitry Cherskiy en tant que directeur le 21 mai 2025

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    43 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 janv. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 18 janv. 2024 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Equans Group Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 déc. 2023

    2 pagesPSC02

    Cessation de Bouygues Energies & Services S.A.S en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 déc. 2023

    1 pagesPSC07

    Déclaration de confirmation établie le 21 déc. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    34 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jean Luc Midena en tant que directeur le 30 janv. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Fabienne Paule Viala en tant que directeur le 30 janv. 2023

    1 pagesTM01

    Modification des détails de Bouygues Energies & Services S.A.S en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 oct. 2019

    2 pagesPSC05

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dmitry Cherskiy le 25 janv. 2023

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 21 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    35 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jean Luc Midena le 31 juil. 2020

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 22 déc. 2021 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 17 déc. 2021

    3 pagesRP04CS01

    Deuxième dépôt d'un bilan du capital suite à une émission d'actions au 22 déc. 2021

    • Capital: GBP 57,500,000
    4 pagesRP04SH01

    Déclaration de confirmation établie le 17 déc. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    Annotations
    DateAnnotation
    19 janv. 2022Clarification A SECOND FILED CS01 STATEMENT OF CAPITAL & SHAREHOLDER INFORMATION WAS REGISTERED ON 19/01/2022

    État du capital après une attribution d'actions au 17 déc. 2021

    • Capital: GBP 65,500,000
    3 pagesSH01
    Annotations
    DateAnnotation
    13 janv. 2022Second Filing The information on the form SH01 has been replaced by a second filing on 13/01/2022

    Qui sont les dirigeants de BOUYGUES E&S CONTRACTING UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GWILLIAM, Rachel Clare
    1 Renshaw Place
    Holytown
    ML1 4UF Motherwell
    Excel House Europoint Office Park
    Scotland
    Secrétaire
    1 Renshaw Place
    Holytown
    ML1 4UF Motherwell
    Excel House Europoint Office Park
    Scotland
    287251930001
    FALCHIER, Gaël
    1 Renshaw Place
    Holytown
    ML1 4UF Motherwell
    Excel House Europoint Office Park
    Scotland
    Administrateur
    1 Renshaw Place
    Holytown
    ML1 4UF Motherwell
    Excel House Europoint Office Park
    Scotland
    FranceFrench336087800001
    JUNG, Thomas
    1 Renshaw Place
    Holytown
    ML1 4UF Motherwell
    Excel House Europoint Office Park
    Scotland
    Administrateur
    1 Renshaw Place
    Holytown
    ML1 4UF Motherwell
    Excel House Europoint Office Park
    Scotland
    FranceFrench336087170001
    WEIR, Steven
    1 Renshaw Place
    Holytown
    ML1 4UF Motherwell
    Excel House Europoint Office Park
    Scotland
    Administrateur
    1 Renshaw Place
    Holytown
    ML1 4UF Motherwell
    Excel House Europoint Office Park
    Scotland
    ScotlandBritish136197760001
    BARNETT, Thomas
    7 Lomond Crescent
    PA11 3HJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Secrétaire
    7 Lomond Crescent
    PA11 3HJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    British855860001
    BORDONNAT, Serge
    Cromwell Crescent
    SW5 9QN London
    4
    United Kingdom
    Secrétaire
    Cromwell Crescent
    SW5 9QN London
    4
    United Kingdom
    French115698320001
    CLAYTON, Brian
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    Becket House
    United Kingdom
    Secrétaire
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    Becket House
    United Kingdom
    252524560001
    DONNELLY, Lawrence John Vincent
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    Secrétaire
    Inveralmond House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3AQ Perth
    British62794440002
    EVANS, Alan Gordon
    15 Kettilstoun Crescent
    EH49 6PR Linlithgow
    West Lothian
    Secrétaire
    15 Kettilstoun Crescent
    EH49 6PR Linlithgow
    West Lothian
    British53078260003
    MCGUIRE, James Joseph
    12 Norwood Drive
    Giffnock
    G46 7LS Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    12 Norwood Drive
    Giffnock
    G46 7LS Glasgow
    Lanarkshire
    British222470001
    PLUMLEY, Xavier Alexander
    c/o Bouygues E&S Uk Ltd
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    Becket House
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Bouygues E&S Uk Ltd
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    Becket House
    United Kingdom
    184006110001
    STOKES, Andrew Michael
    Rue Roque De Fillol
    Puteaux
    27
    92800
    France
    Secrétaire
    Rue Roque De Fillol
    Puteaux
    27
    92800
    France
    British135347320001
    WEIR, Steven
    Transfer House
    Rankine Ave,Scottish Enterprise
    G75 0QF Technology Park,
    East Kilbride
    Secrétaire
    Transfer House
    Rankine Ave,Scottish Enterprise
    G75 0QF Technology Park,
    East Kilbride
    150152770001
    AHMED, Jahan Zeb
    Europoint Office Park
    1 Renshaw Place
    ML1 4UF Holytown, Motherwell
    Excel House
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Europoint Office Park
    1 Renshaw Place
    ML1 4UF Holytown, Motherwell
    Excel House
    Scotland
    Scotland
    EnglandBritish127018500001
    BARNETT, Eileen Jessie
    7 Lomond Crescent
    PA11 3HJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Administrateur
    7 Lomond Crescent
    PA11 3HJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    British1407520001
    BARNETT, Thomas
    7 Lomond Crescent
    PA11 3HJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Administrateur
    7 Lomond Crescent
    PA11 3HJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    British855860001
    BODIN, Bruno Albert
    Europoint Office Park
    1 Renshaw Place
    ML1 4UF Holytown, Motherwell
    Excel House
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Europoint Office Park
    1 Renshaw Place
    ML1 4UF Holytown, Motherwell
    Excel House
    Scotland
    Scotland
    FranceFrench62676630011
    BORDONNAT, Serge
    Europoint Office Park
    1 Renshaw Place
    ML1 4UF Holytown, Motherwell
    Excel House
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Europoint Office Park
    1 Renshaw Place
    ML1 4UF Holytown, Motherwell
    Excel House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomFrench115698320002
    CADMAN, Paul Andrew
    Europoint Office Park
    1 Renshaw Place
    ML1 4UF Holytown, Motherwell
    Excel House
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Europoint Office Park
    1 Renshaw Place
    ML1 4UF Holytown, Motherwell
    Excel House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish118234200001
    CARR, David John
    Europoint Office Park
    1 Renshaw Place
    ML1 4UF Holytown, Motherwell
    Excel House
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Europoint Office Park
    1 Renshaw Place
    ML1 4UF Holytown, Motherwell
    Excel House
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish88508210001
    CASLEY, Henry Roberts
    Dogmore Cottage
    Stoke Row
    RG9 5PD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Dogmore Cottage
    Stoke Row
    RG9 5PD Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritish21786610001
    CASLEY, Henry Roberts
    Dogmore Cottage
    Stoke Row
    RG9 5PD Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Dogmore Cottage
    Stoke Row
    RG9 5PD Henley On Thames
    Oxfordshire
    EnglandBritish21786610001
    CHERSKIY, Dmitry
    1 Renshaw Place
    Holytown
    ML1 4UF Motherwell
    Excel House Europoint Office Park
    Scotland
    Administrateur
    1 Renshaw Place
    Holytown
    ML1 4UF Motherwell
    Excel House Europoint Office Park
    Scotland
    FranceRussian269016760001
    CHEY, Philippe Leon
    Transfer House
    Rankine Ave,Scottish Enterprise
    G75 0QF Technology Park,
    East Kilbride
    Administrateur
    Transfer House
    Rankine Ave,Scottish Enterprise
    G75 0QF Technology Park,
    East Kilbride
    FranceFrench173199570001
    CULBERT, Paul
    55 Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    Berkshire
    Administrateur
    55 Vastern Road
    RG1 8BU Reading
    Berkshire
    British85030070002
    DERIPPE, Jean
    Rue De L'Aubepine
    78180 Montigny Le Bretonneux
    6
    France
    Administrateur
    Rue De L'Aubepine
    78180 Montigny Le Bretonneux
    6
    France
    FranceFrench135837100001
    DINWOODIE, Robert Allan
    13a Buckingham Terrace
    EH4 3AA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    13a Buckingham Terrace
    EH4 3AA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish88258670001
    DUBOIS-WETTERWALD, Isabelle Marie-Anne
    1 Lambeth Palace Road
    SW1 7EU London
    Becket House
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Lambeth Palace Road
    SW1 7EU London
    Becket House
    United Kingdom
    FranceFrench243111500002
    EVANS, Alan Gordon
    15 Kettilstoun Crescent
    EH49 6PR Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    15 Kettilstoun Crescent
    EH49 6PR Linlithgow
    West Lothian
    ScotlandBritish53078260003
    EVEILLARD, Patrick
    Rue De Nemours
    35000 Rennes
    18
    France
    France
    Administrateur
    Rue De Nemours
    35000 Rennes
    18
    France
    France
    FranceFrench130583230001
    FOISSAUD, Carolle Madeleine Annick
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    Becket House
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    Becket House
    United Kingdom
    FranceFrench243111510001
    FROST, Nigel
    Thermal Transfer
    2 Railway Street, Norfolk Square
    SK13 7AG Glossop
    Derbyshire
    Administrateur
    Thermal Transfer
    2 Railway Street, Norfolk Square
    SK13 7AG Glossop
    Derbyshire
    United KingdomBritish46001510003
    GAUNTLETT, David Michael
    1 Poplar Close
    Baughurst
    RG26 5LH Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    1 Poplar Close
    Baughurst
    RG26 5LH Basingstoke
    Hampshire
    British55769350001
    GAUNTLETT, David Michael
    1 Poplar Close
    Baughurst
    RG26 5LH Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    1 Poplar Close
    Baughurst
    RG26 5LH Basingstoke
    Hampshire
    British55769350001
    GAUTHIER, Gino
    Transfer House
    Rankine Ave,Scottish Enterprise
    G75 0QF Technology Park,
    East Kilbride
    Administrateur
    Transfer House
    Rankine Ave,Scottish Enterprise
    G75 0QF Technology Park,
    East Kilbride
    FranceFrench136198080001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BOUYGUES E&S CONTRACTING UK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Q10 Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8BU Newcastle Upon Tyne
    First Floor, Neon
    United Kingdom
    28 déc. 2023
    Q10 Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8BU Newcastle Upon Tyne
    First Floor, Neon
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleThe Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement03151861
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Bouygues Energies & Services S.A.S
    1 Avenue Eugène Freyssinet
    78280 Guyancourt
    Atlantis
    France
    06 avr. 2016
    1 Avenue Eugène Freyssinet
    78280 Guyancourt
    Atlantis
    France
    Oui
    Forme juridiqueLimited
    Pays d'enregistrementFrance
    Autorité légaleFrench
    Lieu d'enregistrementVersailles, Paris
    Numéro d'enregistrement775 664 873
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0