COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC087432 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED ?
| Adresse du siège social | 6-8 George Street EH2 2PF Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 08 août 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 22 août 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 08 août 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomination de Claire Middleton en tant qu'administrateur le 01 déc. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Steven Barr en tant que directeur le 31 oct. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 août 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une sociét é dormante établis au 31 déc. 2024 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 août 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 8 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Richard Steven Barr en tant qu'administrateur le 13 juin 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Claire Middleton en tant que directeur le 13 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 août 2023 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||
Statuts | 34 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 nov. 2022 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Dennis Ray en tant que directeur le 05 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Notification de Coutts & Company en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept. 2022 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed adam & company (nominees)LIMITED\certificate issued on 05/09/22 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de The Royal Bank of Scotland Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept. 2022 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Nomination de Ms Claire Middleton en tant qu'administrateur le 05 sept. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 15 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Alisdair Matthew Dewar en tant qu'administrateur le 10 juin 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Edmund Ridout Harvey-Jamieson en tant que directeur le 28 févr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 déc. 2021 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Natwest Group Secretarial Services Limited le 03 août 2020 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Dennis Ray le 07 sept. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | 175 Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland |
| 169073830002 | ||||||||||
| DEWAR, Alisdair Matthew | Administrateur | EH2 2PF Edinburgh 6-8 George Street Scotland | United Kingdom | British | 296795620001 | |||||||||
| MIDDLETON, Claire | Administrateur | EH2 2PF Edinburgh 6-8 George Street Scotland | Scotland | British | 343199180001 | |||||||||
| DOYLE, Sally Anne | Secrétaire | Maple Road SE20 8HE London 68 England | 152595480001 | |||||||||||
| GOW, Morven | Secrétaire | PO BOX 1000 EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 209091850001 | |||||||||||
| HARTOP, Graeme Thomas | Secrétaire | 18a Manor Place EH3 7DS Edinburgh Midlothian | British | 891110001 | ||||||||||
| LOWRY, Jeremy Malbon | Secrétaire | 3 Clermiston Terrace EH12 6XF Edinburgh Midlothian | British | 197600001 | ||||||||||
| MASSIE, Scott Edward | Secrétaire | 58 Thirlestane Road EH9 1AR Edinburgh Midlothian | British | 31277850001 | ||||||||||
| MCDONALD, Ross Douglas | Secrétaire | 15 Burngrange Park EH55 8ET West Calder West Lothian | British | 86386010002 | ||||||||||
| STANWORTH, William John | Secrétaire | Highfield House 194 Main Street EH37 5SG Pathhead Midlothian | British | 41736370002 | ||||||||||
| BARR, Richard Steven | Administrateur | EH2 2PF Edinburgh 6-8 George Street Scotland | Scotland | British | 324528590001 | |||||||||
| DALZIEL, Ian Martin | Administrateur | 52 Perrymead Street SW6 3SP London | British | 1331330001 | ||||||||||
| DONALDSON, Richard Edwards | Administrateur | Lichfield Gardens TW9 1AP Richmond 50 Surrey | United Kingdom | British | 68192970003 | |||||||||
| DUDGEON, Alexander Stewart | Administrateur | 8 Cluny Drive EH10 6DN Edinburgh Midlothian | British | 61131230002 | ||||||||||
| ENTWISTLE, Raymond Marvin | Administrateur | The Glebe Lauder TD2 6RW Berwickshire | Scotland | British | 892520001 | |||||||||
| GARLAND, David Anthony | Administrateur | Chaucer Villas Chaucer Road BA2 4QY Bath 2 England | England | British | 150872770001 | |||||||||
| GRAHAM, Donald, Lord | Administrateur | Nether Tillyrie KY13 0RW Milnathort Kinross-Shire | United Kingdom | British | 1385490001 | |||||||||
| HARVEY-JAMIESON, Edmund Ridout | Administrateur | EH2 2PF Edinburgh 6-8 George Street Scotland | Scotland | British | 194155630001 | |||||||||
| HEDDERWICK, Alexander Mark | Administrateur | Gifford Bank Edinburgh Road EH41 4JE Gifford East Lothian | United Kingdom | British | 89989960001 | |||||||||
| HERON, Douglas Nicol | Administrateur | St. Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 25 | Scotland | British | 184622430001 | |||||||||
| HOUSE, Mark Andrew Daryl | Administrateur | Strand WC2R 0QS London 440 England | England | British | 163434110002 | |||||||||
| LAURENSON, James Tait | Administrateur | Hillhouse EH27 8DR Kirknewton Midlothian | British | 338250001 | ||||||||||
| LOWRY, Jeremy Malbon | Administrateur | 3 Clermiston Terrace EH12 6XF Edinburgh Midlothian | British | 197600001 | ||||||||||
| MIDDLETON, Claire | Administrateur | EH2 2PF Edinburgh 6-8 George Street Scotland | Scotland | British | 290535550001 | |||||||||
| NORFOLK, Jeremy Paul | Administrateur | 8 Henderland Road EH12 6BB Edinburgh Midlothian | British | 37271240001 | ||||||||||
| RAY, Robert Dennis | Administrateur | EH2 2PF Edinburgh 6-8 George Street Scotland | England | British | 86842140001 | |||||||||
| STANWORTH, William John | Administrateur | Highfield House 194 Main Street EH37 5SG Pathhead Midlothian | United Kingdom | British | 41736370002 | |||||||||
| THORPE, David Robert | Administrateur | Strand WC2R 0QS London 440 England | England | British | 152511790002 | |||||||||
| WALTERS, Christopher James | Administrateur | Rickford Rise Burrington BS40 7AN Bristol Marchwood England | England | British | 152510200001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COUTTS SCOTLAND NOMINEES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coutts & Company | 04 sept. 2022 | Strand WC2R 0QS London 440 Strand England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| The Royal Bank Of Scotland Plc | 01 oct. 2017 | EH2 2YB Edinburgh 36 St Andrew Square Midlothian Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Adam & Company Plc | 01 oct. 2017 | 24/25 St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Midlothian Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Adam & Company Group Plc | 06 avr. 2016 | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 25 Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Ctl Nominees Limited | 06 avr. 2016 | King Street SW1Y 6QY London 22 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0