WEST COAST AQUACULTURE LIMITED

WEST COAST AQUACULTURE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWEST COAST AQUACULTURE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC087523
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WEST COAST AQUACULTURE LIMITED ?

    • (0502) /
    • (1533) /
    • (9999) /

    Où se situe WEST COAST AQUACULTURE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    16 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DF
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WEST COAST AQUACULTURE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WEST COAST SALMON SCOTLAND LIMITED01 oct. 198601 oct. 1986
    WEST COAST SALMON LIMITED18 juil. 198418 juil. 1984
    GRINMOST (NO.21) LIMITED04 avr. 198404 avr. 1984

    Quels sont les derniers comptes de WEST COAST AQUACULTURE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour WEST COAST AQUACULTURE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Douglas Low en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Douglas Low en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Douglas Low en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Roger Dart en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr John Alexander Christie en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Tarald Sivertsen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Geir Sjaastad en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de William Young en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 déc. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 janv. 2010

    État du capital au 21 janv. 2010

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 déc. 2008

    5 pagesAA

    Nomination de Roger John Dart en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de WEST COAST AQUACULTURE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHRISTIE, John Alexander
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Scotland
    Secrétaire
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Scotland
    154183840001
    HOMBLE, Synne
    N-0491
    Oslo
    Solligrenda 11
    Norway
    Administrateur
    N-0491
    Oslo
    Solligrenda 11
    Norway
    NorwayNorwegian131062490001
    LOW, Douglas Robert Duncan
    16 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DF
    Administrateur
    16 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DF
    ScotlandBritish108811280002
    BROWN, Steven
    62 Braid Road
    EH10 6AL Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    62 Braid Road
    EH10 6AL Edinburgh
    Midlothian
    British70360001
    CHRISTIE, John Alexander
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Midlothian
    Secrétaire
    Maxwell Street
    EH10 5HT Edinburgh
    23/16
    Midlothian
    British140170170001
    DART, Roger John
    Craigie Crescent
    KW15 1EP Kirkwall
    4
    Orkney
    Secrétaire
    Craigie Crescent
    KW15 1EP Kirkwall
    4
    Orkney
    British146392030001
    MACKAY, Heather Florence
    Claddagh
    Achterneed
    IV14 9AA Strathpeffer
    Ross Shire
    Secrétaire
    Claddagh
    Achterneed
    IV14 9AA Strathpeffer
    Ross Shire
    British67953990002
    MURRAY, Robert Russell
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    Secrétaire
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    British67953970001
    LYCIDAS SECRETARIES LIMITED
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5TQ Glasgow
    292
    900003290001
    AGNEW, Keith Dalway
    White Gates
    West Moulin Road
    PH16 5EQ Pitlochry
    Perthshire
    Administrateur
    White Gates
    West Moulin Road
    PH16 5EQ Pitlochry
    Perthshire
    British45855000002
    GROTERUD, Olav
    Fredriksborgv 31b
    FOREIGN Oslo 2
    Norway
    Administrateur
    Fredriksborgv 31b
    FOREIGN Oslo 2
    Norway
    Norwegian581590001
    HERRERA, Luis Javier
    Vanskavaig Carness Road
    St Ola
    KW15 1UE Kirkwall
    Orkney
    Administrateur
    Vanskavaig Carness Road
    St Ola
    KW15 1UE Kirkwall
    Orkney
    Chilean98594970001
    LOW, Douglas Robert Duncan
    16 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DF
    Administrateur
    16 Charlotte Square
    Edinburgh
    EH2 4DF
    ScotlandBritish108811280002
    MARKUSSEN, Egil
    Grimestaad
    FOREIGN Tjome
    Norway
    Administrateur
    Grimestaad
    FOREIGN Tjome
    Norway
    Norwegian581580001
    MEAKIN, Nicholas St John
    Runcton House Lorraine Way
    Bramford
    IP8 4JA Ipswich
    Suffolk
    Administrateur
    Runcton House Lorraine Way
    Bramford
    IP8 4JA Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish35721600001
    MEIDELL, Hans Kristian
    Rodbergsvingen 3250 Larvik
    FOREIGN
    Norway
    Administrateur
    Rodbergsvingen 3250 Larvik
    FOREIGN
    Norway
    Norwegian1137890001
    MORALES, Francisco Miranda
    36 Braemar, Clay Loan
    KW15 1QQ Kirkwall
    Orkney
    Administrateur
    36 Braemar, Clay Loan
    KW15 1QQ Kirkwall
    Orkney
    Chilean121143130001
    MURRAY, Robert Russell
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    Administrateur
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    United KingdomBritish67953970001
    MURRAY, Robert Russell
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    Administrateur
    The Old Manse
    Fodderty
    IV14 9AB Strathpeffer
    United KingdomBritish67953970001
    OVERTON, Dennis Karl
    The Braefoot
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    Ross Shire
    Administrateur
    The Braefoot
    Fodderty
    IV15 9UE Strathpeffer
    Ross Shire
    ScotlandBritish80737760001
    SIVERTSEN, Tarald
    8286 Nordfold
    Norway
    Administrateur
    8286 Nordfold
    Norway
    NorwayNorwegian134255990001
    SJAASTAD, Geir
    C, 0587
    Oslo
    Fagerliveien 24
    Norway
    Administrateur
    C, 0587
    Oslo
    Fagerliveien 24
    Norway
    NorwayNorwegian133629360001
    SMITH, Philip
    Van Zuylen
    Van Nijevelstraat 102
    2242 At Wassenaar
    2242
    Netherlands
    Administrateur
    Van Zuylen
    Van Nijevelstraat 102
    2242 At Wassenaar
    2242
    Netherlands
    British73918640001
    STROM-GUNDERSEN, Finn
    Dalsvn 56
    Oslo
    0775
    Norway
    Administrateur
    Dalsvn 56
    Oslo
    0775
    Norway
    Norwegian70617080001
    TAIT, Michael Laurence
    1 Hayfield Court
    Commercial Street
    ZE1 0WN Lerwick
    Isle Of Shetland
    Administrateur
    1 Hayfield Court
    Commercial Street
    ZE1 0WN Lerwick
    Isle Of Shetland
    ScotlandBritish267768460002
    UR, Ellen Torborg
    Bjerkebakken 36
    0756 Oslo
    Norway
    Administrateur
    Bjerkebakken 36
    0756 Oslo
    Norway
    Norwegian35101980001
    WEBSTER, Iain
    Halladale Kilmory Road
    PA31 8SZ Lochgilphead
    Argyll
    Administrateur
    Halladale Kilmory Road
    PA31 8SZ Lochgilphead
    Argyll
    British55769930001
    WILLIAMS, Peter Clifford
    13a Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    Administrateur
    13a Nelson Street
    EH3 6LF Edinburgh
    British47212810004
    YOUNG, William
    Argyll Road
    Kirn
    PA23 8EJ Dunoon
    95
    Argyll
    United Kingdom
    Administrateur
    Argyll Road
    Kirn
    PA23 8EJ Dunoon
    95
    Argyll
    United Kingdom
    United KingdomBritish137835400001

    WEST COAST AQUACULTURE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 10 mars 1998
    Livré le 13 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Argyll and the Islands Enterprise Company
    Transactions
    • 13 mars 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 05 avr. 1995
    Livré le 13 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ewos Limited
    Transactions
    • 13 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 mai 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 juil. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 26 sept. 1994
    Livré le 03 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 oct. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 mai 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 mars 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 31 août 1993
    Livré le 03 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due by aquascot marketing limited
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 03 sept. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 09 oct. 1989
    Livré le 25 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tayinesan fish farm rhunahasrine, kintyre.
    Personnes ayant droit
    • Nordlands Banken a/S
    Transactions
    • 25 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 13 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 01 déc. 1988
    Livré le 01 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • A/S Nordlands Banken
    Transactions
    • 01 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 04 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0