IGNIS LP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéIGNIS LP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC088575
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de IGNIS LP LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe IGNIS LP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ten
    George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Midlothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de IGNIS LP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RESOLUTION LP LIMITED02 mai 200602 mai 2006
    RESOLUTION FUND MANAGERS LIMITED13 févr. 200613 févr. 2006
    BRITANNIC LP LIMITED22 août 200122 août 2001
    BRITANNIC LAS UNIT TRUST MANAGERS LIMITED07 déc. 199907 déc. 1999
    BRITANNIA LAS UNIT TRUST MANAGERS LIMITED01 janv. 199401 janv. 1994
    LAS UNIT TRUST MANAGERS LIMITED 22 juin 198422 juin 1984

    Quels sont les derniers comptes de IGNIS LP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour IGNIS LP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Cessation de la nomination de Stephanie Rose Griffin en tant que secrétaire le 30 janv. 2013

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Christopher John Loraine Samuel en tant que directeur le 30 janv. 2013

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 50 Bothwell Street Glasgow G2 6HR le 08 févr. 2013

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 29 janv. 2013

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Timothy Henry Raynes Roberts en tant que directeur le 30 janv. 2013

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Ian John Paterson Brown en tant que directeur le 29 juin 2012

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Christopher John Loraine Samuel en tant qu'administrateur le 25 juil. 2012

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 avr. 2012

    État du capital au 18 avr. 2012

    • Capital: GBP 675,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    7 pagesAA

    Nomination de Timothy Henry Raynes Roberts en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jonathan Polin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Stephanie Rose Griffin en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Deborah Wagner en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Peter Reid en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jonathan Charles Polin le 31 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    Résolutions

    Resolutions
    19 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de IGNIS LP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GRIFFIN, Stephanie Rose
    70 Marlborough Avenue
    Broomhill
    G11 7BH Glasgow
    1/1,
    United Kingdom
    Secrétaire
    70 Marlborough Avenue
    Broomhill
    G11 7BH Glasgow
    1/1,
    United Kingdom
    154523560001
    NORRIS, Amanda Jane
    4 Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    Secrétaire
    4 Stanhope Place
    EH12 5HH Edinburgh
    British34872000001
    ROSS, Marie Isobel
    51 Killermont Road
    Bearsden
    G61 2JF Glasgow
    Secrétaire
    51 Killermont Road
    Bearsden
    G61 2JF Glasgow
    British42057170004
    SHEPHERD, Neil Morton
    35 Kaimes Road
    EH12 6JT Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    35 Kaimes Road
    EH12 6JT Edinburgh
    Midlothian
    British1063630001
    WAGNER, Deborah Anne
    1 Hillend Road
    Burnside
    G73 4JU Glasgow
    Secrétaire
    1 Hillend Road
    Burnside
    G73 4JU Glasgow
    British6059110004
    WAGNER, Deborah Anne
    1 Hillend Road
    Burnside
    G73 4JU Glasgow
    Secrétaire
    1 Hillend Road
    Burnside
    G73 4JU Glasgow
    British6059110004
    WARD, Anne
    1a South Hamilton Road
    EH39 4NJ North Berwick
    East Lothian
    Secrétaire
    1a South Hamilton Road
    EH39 4NJ North Berwick
    East Lothian
    British47639170001
    BAYLEY, Trevor John
    Woodside Clay Lake
    Endon
    ST9 9DD Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Woodside Clay Lake
    Endon
    ST9 9DD Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish804490002
    BROOKHOUSE, Simon Douglas
    14 Glencairn Crescent
    EH12 5BT Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    14 Glencairn Crescent
    EH12 5BT Edinburgh
    Midlothian
    British1086240001
    BUCHANAN, Richard Robertson Trail
    Lynwood
    6 Essex Road
    EH4 6LG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Lynwood
    6 Essex Road
    EH4 6LG Edinburgh
    Midlothian
    British32224420001
    BURDON, Peter Vincent
    6 Belhaven Place
    G77 5FJ Glasgow
    Administrateur
    6 Belhaven Place
    G77 5FJ Glasgow
    British65710740001
    COTTAM, Harold, Managing Director
    Pentwyn Farm
    Dorstone
    HR3 6AD Hereford
    Administrateur
    Pentwyn Farm
    Dorstone
    HR3 6AD Hereford
    United KingdomBritish32116700002
    DEWAR-DURIE, Andrew Maule
    Finnich Malise
    G63 0HA Croftamie
    Stirlingshire
    Administrateur
    Finnich Malise
    G63 0HA Croftamie
    Stirlingshire
    ScotlandBritish73128130001
    FORREST, Michael Alexander
    23 Barnton Avenue
    EH4 6AJ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    23 Barnton Avenue
    EH4 6AJ Edinburgh
    Midlothian
    Great BritainBritish53460001
    FORTIN, Richard Chalmers Gordon
    Philliswood Farm House
    Hooksway
    PO18 9JZ Chichester
    West Sussex
    Administrateur
    Philliswood Farm House
    Hooksway
    PO18 9JZ Chichester
    West Sussex
    United KingdomBritish31479720002
    GHILONI, Francis William
    63 Lauderdale Gardens
    Hyndland
    G12 9QU Glasgow
    Administrateur
    63 Lauderdale Gardens
    Hyndland
    G12 9QU Glasgow
    British75953650003
    HEAPS, John Edward
    Wellswood
    5 Barnescroft
    ST15 8XU Hilderstone
    Staffordshire
    Administrateur
    Wellswood
    5 Barnescroft
    ST15 8XU Hilderstone
    Staffordshire
    British36563030001
    HENDERSON, William Grahamslaw
    6 West Munro Drive
    G84 9AA Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    6 West Munro Drive
    G84 9AA Helensburgh
    Dunbartonshire
    United KingdomBritish86647560001
    LUCKHOO, Keith Robert Lionel
    18 West Park Road
    Kew
    TW9 4DA Richmond
    Surrey
    Administrateur
    18 West Park Road
    Kew
    TW9 4DA Richmond
    Surrey
    British28073020001
    MACPHERSON, Neil David
    Dunard House 123 Grange Loan
    EH9 2EA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Dunard House 123 Grange Loan
    EH9 2EA Edinburgh
    Midlothian
    British588250001
    MAGEE, Neil Pollock
    45 Spylaw Bank Road
    EH13 0JF Edinburgh
    Administrateur
    45 Spylaw Bank Road
    EH13 0JF Edinburgh
    British43938950001
    MCINTOSH, Leslie Kynoch
    Denrhoda, 6 Seven Sisters
    Lenzie
    G66 3AW Glasgow
    Administrateur
    Denrhoda, 6 Seven Sisters
    Lenzie
    G66 3AW Glasgow
    British51135930001
    MCLEAN, Kenneth
    19 Durham Avenue
    EH15 1PA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    19 Durham Avenue
    EH15 1PA Edinburgh
    Midlothian
    British53470001
    MIRNER, Eamonn Joseph
    17 Blairatholl Avenue
    G11 7QJ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    17 Blairatholl Avenue
    G11 7QJ Glasgow
    Lanarkshire
    British67485800001
    NICKSON, John William
    65 Redgrove Park
    GL51 6QY Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    65 Redgrove Park
    GL51 6QY Cheltenham
    Gloucestershire
    British67485130001
    O'NEIL, Daniel
    25 Newlands Road
    Newlands
    G43 2JD Glasgow
    Administrateur
    25 Newlands Road
    Newlands
    G43 2JD Glasgow
    ScotlandBritish35459350002
    O'NEIL, Daniel
    25 Newlands Road
    Newlands
    G43 2JD Glasgow
    Administrateur
    25 Newlands Road
    Newlands
    G43 2JD Glasgow
    ScotlandBritish35459350002
    PATERSON BROWN, Ian John
    No 3 The Green
    Millgate
    EH14 7LD Balerno
    Midlothian
    Administrateur
    No 3 The Green
    Millgate
    EH14 7LD Balerno
    Midlothian
    United KingdomBritish72809350001
    POLIN, Jonathan Charles
    28 Park Circus
    G3 6AP Glasgow
    Flat 0/1
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    28 Park Circus
    G3 6AP Glasgow
    Flat 0/1
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish97840060003
    PORTMAN, Bryan Henry
    Chesnam House
    Copthill Lane
    KT20 6HL Kingswood
    Surrey
    Administrateur
    Chesnam House
    Copthill Lane
    KT20 6HL Kingswood
    Surrey
    British101234700001
    QUINN, Brian
    14 Homewood Road
    AL1 4BH St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 Homewood Road
    AL1 4BH St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish27881280001
    REID, Peter Smith
    43 Woodend Drive
    Jordanhill
    G13 1QJ Glasgow
    Administrateur
    43 Woodend Drive
    Jordanhill
    G13 1QJ Glasgow
    United KingdomBritish78179620001
    ROBERTS, Timothy Henry Raynes
    Woods Farm Road
    OX12 8JA East Hendred
    Ashfield House
    England
    England
    Administrateur
    Woods Farm Road
    OX12 8JA East Hendred
    Ashfield House
    England
    England
    EnglandBritish136569310001
    SAMUEL, Christopher John Loraine
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    EnglandBritish50729210001
    SHAW, Francis Michael
    Rock House 711 Cheadle Road
    Wetley Rocks
    ST9 0BA Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Rock House 711 Cheadle Road
    Wetley Rocks
    ST9 0BA Stoke On Trent
    Staffordshire
    British5779480001

    IGNIS LP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 août 2013Dissolved on
    29 janv. 2013Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0