FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED

FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC089407
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED ?

    • Lavage et nettoyage (à sec) de produits textiles et de fourrure (96010) / Autres activités de services

    Où se situe FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Riggs Place
    Cupar
    KY15 5JA Fife
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    État du capital au 23 déc. 2019

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 02 oct. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 oct. 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    8 pagesAA

    Inscription de la charge SC0894070022, créée le 26 mars 2018

    25 pagesMR01

    Résolutions

    Resolutions
    31 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company enter into documents in connection with banking arrangements aproved 23/02/2018
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Satisfaction de la charge SC0894070017 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0894070019 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0894070018 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0894070020 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge SC0894070021, créée le 27 nov. 2017

    46 pagesMR01

    Nomination de Matthew Hills en tant qu'administrateur le 27 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Lucy Jane Renaut en tant que secrétaire le 27 nov. 2017

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Lucy Jane Renaut en tant que directeur le 27 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Lucy Jane Renaut en tant que secrétaire le 27 nov. 2017

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Lucy Jane Renaut en tant que directeur le 27 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Linda Mccurdy en tant qu'administrateur le 27 nov. 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 02 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HILLS, Matthew
    Hobart Road
    02459 Newton Centre
    25
    Massachusetts
    Usa
    Administrateur
    Hobart Road
    02459 Newton Centre
    25
    Massachusetts
    Usa
    United StatesAmericanFinance239891650001
    JONES, Michael William
    Riggs Place
    Cupar
    KY15 5JA Fife
    Administrateur
    Riggs Place
    Cupar
    KY15 5JA Fife
    United KingdomBritishNone126352170001
    MCCURDY, Linda
    Hasting Street W
    Vancouver
    1002-1205
    British Columbia, V6e 4t7
    Canada
    Administrateur
    Hasting Street W
    Vancouver
    1002-1205
    British Columbia, V6e 4t7
    Canada
    CanadaCanadianExecutive239891640001
    FISHER, Jennifer Elizabeth
    Rathillet Farm
    KY15 4QG Cupar
    Fife
    Secrétaire
    Rathillet Farm
    KY15 4QG Cupar
    Fife
    BritishOperational Manager78428780001
    FISHER, Judith Margaret
    Arden
    Cupar
    Fife
    Secrétaire
    Arden
    Cupar
    Fife
    BritishCompany Director34855450001
    INGLIS, Scott Ian
    Riggs Place
    KY15 5JA Cupar
    Fishers Services (Aberfeldy) Ltd
    Fife
    Scotland
    Secrétaire
    Riggs Place
    KY15 5JA Cupar
    Fishers Services (Aberfeldy) Ltd
    Fife
    Scotland
    British172854670001
    MACKAY, Roderick Gunn
    2 Innerleithen Way
    PH1 1RN Perth
    Perthshire
    Secrétaire
    2 Innerleithen Way
    PH1 1RN Perth
    Perthshire
    BritishAccountant96851920001
    RENAUT, Lucy Jane
    Riggs Place
    Cupar
    KY15 5JA Fife
    Secrétaire
    Riggs Place
    Cupar
    KY15 5JA Fife
    193555160001
    SANDIE, James Scott
    2 Meadowfield Court
    KY15 7AT Falkland
    Fife
    Secrétaire
    2 Meadowfield Court
    KY15 7AT Falkland
    Fife
    British34380240001
    FISHER, Donald Mcdonald
    Arden
    Cupar
    Fife
    Administrateur
    Arden
    Cupar
    Fife
    BritishLaundry Proprietor918010001
    FISHER, James
    Torr Hill
    Aberfeldy
    Administrateur
    Torr Hill
    Aberfeldy
    BritishLaundry Proprietor932430001
    INGLIS, Scott Ian
    Riggs Place
    KY15 5JA Cupar
    Fishers Services (Aberfeldy) Ltd
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    Riggs Place
    KY15 5JA Cupar
    Fishers Services (Aberfeldy) Ltd
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritishFinancial Director172854550001
    MACKAY, Roderick Gunn
    2 Innerleithen Way
    PH1 1RN Perth
    Perthshire
    Administrateur
    2 Innerleithen Way
    PH1 1RN Perth
    Perthshire
    ScotlandBritishAccountant96851920001
    MCHARDY, Bruce Alexander
    The Park
    Brighton Road
    KY15 5DH Cupar
    Fife
    Administrateur
    The Park
    Brighton Road
    KY15 5DH Cupar
    Fife
    ScotlandBritishManaging Director40384630002
    RENAUT, Lucy Jane
    Riggs Place
    Cupar
    KY15 5JA Fife
    Administrateur
    Riggs Place
    Cupar
    KY15 5JA Fife
    ScotlandBritishFinance Director193551970001
    WARD, David Victor
    38 Druids Park
    Murthly
    PH1 4EJ Perthshire
    Administrateur
    38 Druids Park
    Murthly
    PH1 4EJ Perthshire
    IrishGeneral Manager19729330003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Fishers Services Ltd
    Riggs Place
    KY15 5JA Cupar
    3
    Scotland
    06 avr. 2016
    Riggs Place
    KY15 5JA Cupar
    3
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUk
    Lieu d'enregistrementCompanies House Scotland
    Numéro d'enregistrementSc067627
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    FISHERS SERVICES (ABERFELDY) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 26 mars 2018
    Livré le 05 avr. 2018
    En cours
    Brève description
    All and whole that area of ground in the county of perth forming part of the inveralmond industrial estate, perth and extending to 1.063 ha or thereby being the subjects shown coloured pink on the plan annexed and signed as relative to the charge (hereinafter referred to as the “plan”) and comprising all and whole the subjects extending to one hectare and three hundred and sixty six decimal or one thousandth parts of a hectare or thereby being the subjects more particularly described in, disponed by and delineated in red on the plan annexed and subscribed as relative to feu disposition by the perth and kinross district council in favour of the said fishers services (aberfeldy) limited dated 21 march and recorded in the division of the general register of sasines applicable to the county of perth on 27 march both dates in 1996 under exception of (first) that area of ground situated to the north east of ruthvenfield avenue, perth extending to twenty five square metres or thereby as delineated in black and coloured pink on the plan annexed and subscribed as relative to disposition by us the said fishers services (aberfeldy) limited in favour of scottish hydro-electric PLC dated 17 february and recorded in the said division of the general register of sasines on 10 april both dates in 1997 together with (by way of exception and not inclusion) the heritable and irredeemable servitude rights specified and contained in said disposition and (second) the subjects lying on the east side of ruthvenfield avenue, inveralmond industrial estate, perth being the subjects registered in the land register of scotland under title number PTH48297, which subjects (first) and (second) hereinbefore described are both shown for the avoidance of doubt coloured yellow on the said plan.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transactions
    • 05 avr. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 27 nov. 2017
    Livré le 12 déc. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transactions
    • 12 déc. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 05 juil. 2013
    Livré le 15 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All and whole the area of ground extending to 5/1,000TH parts of an acre lying to the north east of home street aberfeldy. See form 466. notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 05 juil. 2013
    Livré le 15 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Plot or area of ground being part of the inveralmond industrial estate perth see form.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 juin 2013
    Livré le 04 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cavendish Square Partners Limited
    Transactions
    • 04 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 juil. 2013Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 27 juin 2013
    Livré le 03 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 juil. 2013Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 06 déc. 2007
    Livré le 18 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at home street, aberfeldy PTH21621.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 06 déc. 2007
    Livré le 18 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.366 hectares of ground at inveralmond industrial estate, perth.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 30 nov. 2007
    Livré le 05 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 26 avr. 2004
    Livré le 07 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground east side of home street, aberfeldy PTH9204.
    Personnes ayant droit
    • Close Investment Partners Limited
    Transactions
    • 07 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 avr. 2004
    Livré le 07 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground part of inveralmond industrial estate, perth.
    Personnes ayant droit
    • Close Investment Partners Limited
    Transactions
    • 07 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 avr. 2004
    Livré le 07 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground at east home street, aberfeldy.
    Personnes ayant droit
    • Close Investment Partners Limited
    Transactions
    • 07 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 avr. 2004
    Livré le 07 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    55 kelly street, greenock REN104183.
    Personnes ayant droit
    • Close Investment Partners Limited
    Transactions
    • 07 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • 16 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 avr. 2004
    Livré le 04 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Property known as home street, aberfeldy.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 avr. 2004
    Livré le 04 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    239 square yards in the burgh of aberfeldy, county of perth under exception of ground on east side of home street, aberfeldy PTH9204.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 avr. 2004
    Livré le 04 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Part of inveralmond industrial estate, perth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 26 avr. 2004
    Livré le 04 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    55 kelly street, greenock REN104183.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 26 mars 2004
    Livré le 08 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Close Investment Partners Limited
    Transactions
    • 08 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 avr. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 26 mars 2004
    Livré le 30 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 mars 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 mars 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 27 mars 1996
    Livré le 03 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.484 hectares at ruthvenfield avenue,inveralmond industrial estate,perth.
    Personnes ayant droit
    • Perth and Kinross District Council
    Transactions
    • 03 avr. 1996Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 août 1991
    Livré le 28 août 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Rose cottage, 20 dunkeld street aberfeldy perth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 août 1991Enregistrement d'une charge
    • 16 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Letter of offset
    Créé le 31 oct. 1985
    Livré le 07 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by fishers holdings LTD and/or others
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank in name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    • 16 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0