BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED

BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC089468
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED ?

    • Construction de bâtiments commerciaux (41201) / Construction

    Où se situe BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    77 Renfrew Street Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LENDLEASE CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED01 juil. 201601 juil. 2016
    LEND LEASE CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED28 févr. 201128 févr. 2011
    BOVIS LEND LEASE (SCOTLAND) LIMITED01 févr. 200001 févr. 2000
    BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED29 nov. 198429 nov. 1984
    QUITTE LIMITED29 août 198429 août 1984

    Quels sont les derniers comptes de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2025
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au29 avr. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation13 mai 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au29 avr. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2025 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des détails de Lendlease Construction Holdings (Europe) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mars 2025

    2 pagesPSC05

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Comptes annuels établis au 30 juin 2024

    30 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 30 juin 2025 au 31 mars 2025

    1 pagesAA01

    État du capital après une attribution d'actions au 28 mars 2025

    • Capital: GBP 98,500,100
    3 pagesSH01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed lendlease construction (scotland) LIMITED\certificate issued on 01/04/25
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name01 avr. 2025

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Cessation de la nomination de Simon William Gorski en tant que directeur le 23 août 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2023

    28 pagesAA

    Nomination de David Edward Cadiot en tant qu'administrateur le 16 janv. 2024

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2022

    29 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Tom Gillibrand en tant qu'administrateur le 05 janv. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Louise Nicola Bramble en tant que directeur le 04 janv. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2021

    25 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Louise Nicola Bramble en tant qu'administrateur le 14 déc. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michelle Gaye Letton en tant que directeur le 14 déc. 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2020

    22 pagesAA

    Cessation de la nomination de Peter Dominic Leonard en tant que directeur le 18 févr. 2021

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Lendlease, 77 Renfield Street Clockwise Offices, Savoy Tower Glasgow G2 3DH Scotland à 77 Renfrew Street Clockwise Offices, Savoy Tower Glasgow G2 3DH le 07 sept. 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon William Gorski le 10 févr. 2017

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CADIOT, David Edward
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    Administrateur
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    EnglandBritish281962250001
    GILLIBRAND, Tom
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    Administrateur
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    EnglandBritish303891700001
    CATCHPOLE, Laurence James
    35 The Green
    Writtle
    CM1 3DT Chelmsford
    Essex
    Secrétaire
    35 The Green
    Writtle
    CM1 3DT Chelmsford
    Essex
    British580980001
    CHADWICK, Peter Roy
    24 Pendarves Road
    Raynes Park
    SW20 8TS London
    Secrétaire
    24 Pendarves Road
    Raynes Park
    SW20 8TS London
    British37525040002
    CUTTS, Alistair
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Secrétaire
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    British103721920002
    MARTIN, Neil Christopher
    36 Vicarage Road
    RG9 1HW Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secrétaire
    36 Vicarage Road
    RG9 1HW Henley On Thames
    Oxfordshire
    British92464400001
    CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Dukes Place
    EC3A 7NH London
    40
    United Kingdom
    Secrétaire
    Dukes Place
    EC3A 7NH London
    40
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement05306796
    102944500001
    ALLPORT, Roy Innes
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Administrateur
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    ScotlandBritish185943820001
    ANDERSON, Gordon Adam
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Administrateur
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    United KingdomBritish62089480001
    ASH, Gordon Brian
    The Coach House
    Auchengillan
    G63 9AU Blanefield
    Stirlingshire
    Administrateur
    The Coach House
    Auchengillan
    G63 9AU Blanefield
    Stirlingshire
    British82612740001
    BALLANTYNE, John Charles
    30 Rosemount
    Cumbernauld
    G68 0HL Glasgow
    Administrateur
    30 Rosemount
    Cumbernauld
    G68 0HL Glasgow
    British53470410001
    BATE, Dennis
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    British28569910001
    BRAMBLE, Louise Nicola
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    Administrateur
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    EnglandBritish256411060001
    CATCHPOLE, Laurence James
    35 The Green
    Writtle
    CM1 3DT Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    35 The Green
    Writtle
    CM1 3DT Chelmsford
    Essex
    British580980001
    COLEMAN, Murray Leslie
    Laurel House
    Queens Road
    TW10 6JJ Richmond
    Surrey
    Administrateur
    Laurel House
    Queens Road
    TW10 6JJ Richmond
    Surrey
    Australian114401640001
    COOK, George Lamond
    75 Cash Feus
    Strathmiglo
    KY14 7QP Cupar
    Fife
    Administrateur
    75 Cash Feus
    Strathmiglo
    KY14 7QP Cupar
    Fife
    ScotlandScottish51373080001
    DEW, Beverley Edward John
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Administrateur
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    EnglandBritish133103950001
    DOWNIE, Henry Francis
    42 Fountainhall Road
    EH9 2LW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    42 Fountainhall Road
    EH9 2LW Edinburgh
    Midlothian
    British1357800001
    DYKE, Michael Sean
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Administrateur
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    EnglandBritish187622030001
    GANDY, Paul Francis
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Administrateur
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    EnglandBritish71452580002
    GLEDHILL, Lisa Veronica
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Administrateur
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    United KingdomBritish178456550002
    GORSKI, Simon William
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    Administrateur
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    EnglandBritish215280250003
    GRIST, Stephen Kenneth
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Administrateur
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    EnglandAustralian157560950001
    HARVEY, Colin Stephen
    8 Montrose Close
    SK10 3QY Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    8 Montrose Close
    SK10 3QY Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish96158420001
    HEYES, Michael
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Administrateur
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    EnglandBritish189835920001
    HYNE, John Charles
    6 Broomhill Park
    EH22 3JX Eskbank
    Midlothian
    Administrateur
    6 Broomhill Park
    EH22 3JX Eskbank
    Midlothian
    British100669250001
    JOHNSON, Paul Murray
    Ranelagh House
    2 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    Administrateur
    Ranelagh House
    2 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    EnglandBritish115607320001
    LABBAD, Daniel
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Administrateur
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    EnglandAustralian111679880003
    LEONARD, Peter Dominic
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    Administrateur
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    United KingdomBritish280048870001
    LETTON, Michelle Gaye
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    Administrateur
    Clockwise Offices, Savoy Tower
    G2 3DH Glasgow
    77 Renfrew Street
    Scotland
    EnglandAustralian267826300001
    MABEY, Roger Stanley
    Carrol Lodge
    Sutton Road
    SL6 9RD Cookham Village
    Berkshire
    Administrateur
    Carrol Lodge
    Sutton Road
    SL6 9RD Cookham Village
    Berkshire
    EnglandBritish156243050001
    MACK, Alan Charles
    Manesty
    18 Apperley Road
    NE43 7PG Stocksfield
    Northumberland
    Administrateur
    Manesty
    18 Apperley Road
    NE43 7PG Stocksfield
    Northumberland
    British81122300001
    MARTIN, Neil Christopher
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    Administrateur
    33 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 6NL Lanarkshire
    United KingdomBritish317424620001
    MCMURDO, John Stuart
    Westlea 58 Majors Loan
    FK1 5QG Falkirk
    Stirlingshire
    Administrateur
    Westlea 58 Majors Loan
    FK1 5QG Falkirk
    Stirlingshire
    British78860160001
    MCQUADE, Brian
    289 Main Road
    Elderslie
    PA5 9ED Johnstone
    Administrateur
    289 Main Road
    Elderslie
    PA5 9ED Johnstone
    British75590650001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Crown Place
    EC2A 4ES London
    30
    England
    06 avr. 2016
    Crown Place
    EC2A 4ES London
    30
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00231889
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0