BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC089468 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 77 Renfrew Street Clockwise Offices, Savoy Tower G2 3DH Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 29 avr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 13 mai 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 29 avr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2025 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Lendlease Construction Holdings (Europe) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mars 2025 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2024 | 30 pages | AA | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 30 juin 2025 au 31 mars 2025 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 28 mars 2025
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed lendlease construction (scotland) LIMITED\certificate issued on 01/04/25 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Simon William Gorski en tant que directeur le 23 août 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2023 | 28 pages | AA | ||||||||||
Nomination de David Edward Cadiot en tant qu'administrateur le 16 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2022 | 29 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Tom Gillibrand en tant qu'administrateur le 05 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Louise Nicola Bramble en tant que directeur le 04 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2021 | 25 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Louise Nicola Bramble en tant qu'administrateur le 14 déc. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michelle Gaye Letton en tant que directeur le 14 déc. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2020 | 22 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Dominic Leonard en tant que directeur le 18 févr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Lendlease, 77 Renfield Street Clockwise Offices, Savoy Tower Glasgow G2 3DH Scotland à 77 Renfrew Street Clockwise Offices, Savoy Tower Glasgow G2 3DH le 07 sept. 2020 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon William Gorski le 10 févr. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADIOT, David Edward | Administrateur | Clockwise Offices, Savoy Tower G2 3DH Glasgow 77 Renfrew Street Scotland | England | British | 281962250001 | |||||||||
| GILLIBRAND, Tom | Administrateur | Clockwise Offices, Savoy Tower G2 3DH Glasgow 77 Renfrew Street Scotland | England | British | 303891700001 | |||||||||
| CATCHPOLE, Laurence James | Secrétaire | 35 The Green Writtle CM1 3DT Chelmsford Essex | British | 580980001 | ||||||||||
| CHADWICK, Peter Roy | Secrétaire | 24 Pendarves Road Raynes Park SW20 8TS London | British | 37525040002 | ||||||||||
| CUTTS, Alistair | Secrétaire | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | British | 103721920002 | ||||||||||
| MARTIN, Neil Christopher | Secrétaire | 36 Vicarage Road RG9 1HW Henley On Thames Oxfordshire | British | 92464400001 | ||||||||||
| CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | Dukes Place EC3A 7NH London 40 United Kingdom |
| 102944500001 | ||||||||||
| ALLPORT, Roy Innes | Administrateur | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | Scotland | British | 185943820001 | |||||||||
| ANDERSON, Gordon Adam | Administrateur | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | United Kingdom | British | 62089480001 | |||||||||
| ASH, Gordon Brian | Administrateur | The Coach House Auchengillan G63 9AU Blanefield Stirlingshire | British | 82612740001 | ||||||||||
| BALLANTYNE, John Charles | Administrateur | 30 Rosemount Cumbernauld G68 0HL Glasgow | British | 53470410001 | ||||||||||
| BATE, Dennis | Administrateur | 109 Carmill Road Billinge WN5 7TY Wigan Lancashire | British | 28569910001 | ||||||||||
| BRAMBLE, Louise Nicola | Administrateur | Clockwise Offices, Savoy Tower G2 3DH Glasgow 77 Renfrew Street Scotland | England | British | 256411060001 | |||||||||
| CATCHPOLE, Laurence James | Administrateur | 35 The Green Writtle CM1 3DT Chelmsford Essex | British | 580980001 | ||||||||||
| COLEMAN, Murray Leslie | Administrateur | Laurel House Queens Road TW10 6JJ Richmond Surrey | Australian | 114401640001 | ||||||||||
| COOK, George Lamond | Administrateur | 75 Cash Feus Strathmiglo KY14 7QP Cupar Fife | Scotland | Scottish | 51373080001 | |||||||||
| DEW, Beverley Edward John | Administrateur | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | England | British | 133103950001 | |||||||||
| DOWNIE, Henry Francis | Administrateur | 42 Fountainhall Road EH9 2LW Edinburgh Midlothian | British | 1357800001 | ||||||||||
| DYKE, Michael Sean | Administrateur | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | England | British | 187622030001 | |||||||||
| GANDY, Paul Francis | Administrateur | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | England | British | 71452580002 | |||||||||
| GLEDHILL, Lisa Veronica | Administrateur | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | United Kingdom | British | 178456550002 | |||||||||
| GORSKI, Simon William | Administrateur | Clockwise Offices, Savoy Tower G2 3DH Glasgow 77 Renfrew Street Scotland | England | British | 215280250003 | |||||||||
| GRIST, Stephen Kenneth | Administrateur | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | England | Australian | 157560950001 | |||||||||
| HARVEY, Colin Stephen | Administrateur | 8 Montrose Close SK10 3QY Macclesfield Cheshire | England | British | 96158420001 | |||||||||
| HEYES, Michael | Administrateur | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | England | British | 189835920001 | |||||||||
| HYNE, John Charles | Administrateur | 6 Broomhill Park EH22 3JX Eskbank Midlothian | British | 100669250001 | ||||||||||
| JOHNSON, Paul Murray | Administrateur | Ranelagh House 2 Ranelagh Road RH1 6BJ Redhill Surrey | England | British | 115607320001 | |||||||||
| LABBAD, Daniel | Administrateur | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | England | Australian | 111679880003 | |||||||||
| LEONARD, Peter Dominic | Administrateur | Clockwise Offices, Savoy Tower G2 3DH Glasgow 77 Renfrew Street Scotland | United Kingdom | British | 280048870001 | |||||||||
| LETTON, Michelle Gaye | Administrateur | Clockwise Offices, Savoy Tower G2 3DH Glasgow 77 Renfrew Street Scotland | England | Australian | 267826300001 | |||||||||
| MABEY, Roger Stanley | Administrateur | Carrol Lodge Sutton Road SL6 9RD Cookham Village Berkshire | England | British | 156243050001 | |||||||||
| MACK, Alan Charles | Administrateur | Manesty 18 Apperley Road NE43 7PG Stocksfield Northumberland | British | 81122300001 | ||||||||||
| MARTIN, Neil Christopher | Administrateur | 33 Bothwell Street Glasgow G2 6NL Lanarkshire | United Kingdom | British | 317424620001 | |||||||||
| MCMURDO, John Stuart | Administrateur | Westlea 58 Majors Loan FK1 5QG Falkirk Stirlingshire | British | 78860160001 | ||||||||||
| MCQUADE, Brian | Administrateur | 289 Main Road Elderslie PA5 9ED Johnstone | British | 75590650001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BOVIS CONSTRUCTION (SCOTLAND) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovis Construction Holdings (Europe) Limited | 06 avr. 2016 | Crown Place EC2A 4ES London 30 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0