WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC089533 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Leven House 10 Lochside Place Edinburgh Park EH12 9RG Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 05 mars 2018
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 févr. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 févr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Joanne Sarah Finch en tant que directeur le 26 sept. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Lochside House 7 Lochside Avenue Edinburgh Park Edinburgh Scotland EH12 9DJ Scotland* le 18 sept. 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Nigel Evans en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Martin Purkess en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 15 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Diane Mcintyre en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Schäfer en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2012 | 6 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | 75473330004 | |||||||
| EVANS, David Nigel | Administrateur | 10 Lochside Place Edinburgh Park EH12 9RG Edinburgh Leven House Scotland Scotland | United Kingdom | British | 134975040001 | |||||
| MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo | Administrateur | 10 Lochside Place Edinburgh Park EH12 9RG Edinburgh Leven House Scotland Scotland | United Kingdom | British | 173703620001 | |||||
| BAIRD, Brian Alexander | Secrétaire | 4 Cheviot Drive G77 5AS Glasgow | British | 95529070001 | ||||||
| MACLEOD, David | Secrétaire | 12 Glebe Road Newton Mearns G77 6DU Glasgow | British | 32696310001 | ||||||
| MCINTYRE, Colin | Secrétaire | 473 Clarkston Road G44 3LW Glasgow Lanarkshire | British | 732300001 | ||||||
| PRENTICE, Edward Duncan | Secrétaire | 72 Lymekilns Road East Kilbride G74 4TU Glasgow Lanarkshire | British | 72432810001 | ||||||
| SCOTT, Stephen Roy | Secrétaire | Bracken House Bunces Shaw Farley Hill RG7 1UU Reading Berkshire | British | 25660590003 | ||||||
| QUEENSFERRY SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HG Edinburgh | 38051430002 | |||||||
| ALLAN, William | Administrateur | Shernfold Meadows Wadhurst Road TN3 9EH Frant East Sussex | Uk | British | 111131550001 | |||||
| ALLEN, Christian Philip Quentin | Administrateur | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | British | 123612980001 | ||||||
| BROCKLEHURST, Nigel | Administrateur | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | 83126790001 | ||||||
| CHESWORTH, Paul | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 99525280001 | ||||||
| EVANS, Mark | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 127017870001 | ||||||
| FINCH, Joanne Sarah | Administrateur | 10 Lochside Place Edinburgh Park EH12 9RG Edinburgh Leven House Scotland Scotland | United Kingdom | British | 158146620001 | |||||
| FORD, John Joseph | Administrateur | 30 Gildale Werrington PE4 6QY Peterborough Cambridgeshire | British | 78094110001 | ||||||
| GRAY, Ian | Administrateur | 61 Bathurst Mews W2 2SB London | United Kingdom | British | 50246030004 | |||||
| HADDEN, Mervyn Alexander | Administrateur | Chantry Cottage The Warren KT24 5RH East Horsley Surrey | British | 94655490001 | ||||||
| HADDOW, Neil Scott | Administrateur | 104 Mearns Road Clarkston G76 7UP Glasgow | British | 53774190001 | ||||||
| HALFORD, Andrew Nigel | Administrateur | The Oxdrove House Burghclere RG20 9HJ Newbury Berkshire | British | 33951180005 | ||||||
| HAULDSWORTH, June | Administrateur | 16 Greenhill Bishopbriggs G64 1LE Glasgow Lanarkshire | British | 1002880001 | ||||||
| HILLS, Kenneth Cumming | Administrateur | 49 Spottiswoode Street EH9 1DQ Edinburgh Midlothian | British | 65152940001 | ||||||
| HOULDSWORTH, June | Administrateur | Baron Hill Nursery 86 Hunthill Road High Blantyre G72 9UY Glasgow | United Kingdom | British | 1376720001 | |||||
| KEY, Matthew David | Administrateur | Yardley School Lane Seer Green HP9 2QJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 62981720001 | ||||||
| LEE, Simon Christopher | Administrateur | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||
| LEE, Simon Christopher | Administrateur | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||
| MATTHEWS, Roderick Alfred | Administrateur | Aros House Rhu G84 8NJ Helensburgh Dunbartonshire | British | 74872510003 | ||||||
| MCALOON, William Gerard | Administrateur | 10 Jacks View West Kilbride KA23 9HX Ayshire Ayrshire | British | 108756350001 | ||||||
| MCLEAN, Gregory Joseph | Administrateur | 3 Princes Terrace Dowanhill G12 9JW Glasgow | American | 33612180002 | ||||||
| NOWAK, Thomas, Dr | Administrateur | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | United Kingdom | German | 174443800001 | |||||
| PRENTICE, Edward Duncan | Administrateur | 72 Lymekilns Road East Kilbride G74 4TU Glasgow Lanarkshire | British | 72432810001 | ||||||
| PURKESS, Martin John | Administrateur | 7 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9DJ Edinburgh Lochside House Scotland Scotland | England | British | 139360020001 | |||||
| READ, Nicholas Jonathan | Administrateur | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 87149560001 | |||||
| REGAN, William Paul | Administrateur | 7 Glenpark Avenue G46 7JE Glasgow Renfrewshire Uk | British | 48839480001 | ||||||
| RUSSELL, Ian Simon Macgregor | Administrateur | 73 Braid Avenue EH10 6ED Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 38783050003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodend Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 10 Lochside Place Edinburgh Park EH12 9RG Edinburgh Leven House Scotland Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
WOODEND COMMUNICATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Créé le 05 avr. 1991 Livré le 15 avr. 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 13 oct. 1988 Livré le 18 oct. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0