WEST INDEPENDENT NEWSPAPERS LIMITED

WEST INDEPENDENT NEWSPAPERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWEST INDEPENDENT NEWSPAPERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC090053
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WEST INDEPENDENT NEWSPAPERS LIMITED ?

    • Édition de journaux (58130) / Information et communication

    Où se situe WEST INDEPENDENT NEWSPAPERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Carus House
    201 Dumbarton Road
    G81 4XJ Clydebank
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WEST INDEPENDENT NEWSPAPERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au27 sept. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour WEST INDEPENDENT NEWSPAPERS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour WEST INDEPENDENT NEWSPAPERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes pour une société dormante établis au 27 sept. 2014

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Charles John Allwood en tant que directeur le 22 mai 2015

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    État du capital au 14 mai 2015

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 juil. 2014

    État du capital au 04 juil. 2014

    • Capital: GBP 545,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 sept. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Graham Thomson Morrison le 04 juil. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Graham John Faulds le 04 juil. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 sept. 2012

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Company Secretary Dunfermline Press Office Pitreavie Business Park Queensferry Road Dunfermline Fife KY11 8QS Scotland* le 16 janv. 2013

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 01 oct. 2011

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * Pitreavie Business Park Dunfermline Fife KY11 8QS* le 03 mai 2012

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de WEST INDEPENDENT NEWSPAPERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FAULDS, Graham John
    Danes Drive
    G14 9HX Glasgow
    61
    United Kingdom
    Secrétaire
    Danes Drive
    G14 9HX Glasgow
    61
    United Kingdom
    151619490001
    FAULDS, Graham John
    201 Dumbarton Road
    G81 4XJ Clydebank
    Carus House
    Administrateur
    201 Dumbarton Road
    G81 4XJ Clydebank
    Carus House
    ScotlandBritishChartered Accountant63911030001
    MORRISON, Graham Thomson
    201 Dumbarton Road
    G81 4XJ Clydebank
    Carus House
    Administrateur
    201 Dumbarton Road
    G81 4XJ Clydebank
    Carus House
    ScotlandBritishDirector Of Operations58322450001
    PEEBLES, Alexander Douglas
    Lindean 85 South Broomage Avenue
    FK5 3ED Larbert
    Stirlingshire
    Secrétaire
    Lindean 85 South Broomage Avenue
    FK5 3ED Larbert
    Stirlingshire
    British152350001
    ROMANES, Deirdre Mary Astrea
    33 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Secrétaire
    33 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    IrishCompany Director3206310002
    ALLWOOD, Charles John
    Charles Street
    HP4 3DG Berkhamsted
    3
    Herts
    England
    Administrateur
    Charles Street
    HP4 3DG Berkhamsted
    3
    Herts
    England
    EnglandBritishChartered Accountant35681240004
    CAMPBELL, David Ross
    Summerlea
    Summerlea Road
    KA23 9HP Seamill
    Ayrshire
    Administrateur
    Summerlea
    Summerlea Road
    KA23 9HP Seamill
    Ayrshire
    BritishCompany Director651850003
    COHEN, Philip
    2 Cedarwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QD Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    2 Cedarwood Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QD Glasgow
    Lanarkshire
    BritishCompany Director152360002
    FERRARA, Antonio Franchesco
    73 Braehead
    Girdle Toll
    KA11 1BE Irvine
    Ayrshire
    Administrateur
    73 Braehead
    Girdle Toll
    KA11 1BE Irvine
    Ayrshire
    BritishSales Director39556550001
    FULLARTON, Donald Speirs
    Inistore 58 James Street
    G84 9LX Helensburgh
    Dunbartonshire
    Scotland
    Administrateur
    Inistore 58 James Street
    G84 9LX Helensburgh
    Dunbartonshire
    Scotland
    ScotlandBritishEditorial Director19280910001
    GOSSMAN, James
    Carlung House
    KA23 9PU West Kilbride
    Ayrshire
    Administrateur
    Carlung House
    KA23 9PU West Kilbride
    Ayrshire
    BritishCompany Director90560001
    HARDMAN, Alasdair Fraser
    16 Hallhead Road
    EH16 5QJ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    16 Hallhead Road
    EH16 5QJ Edinburgh
    Midlothian
    BritishCompany Director133970001
    HAY, Ian Cameron
    109 Ayr Road
    KA9 1TN Prestwick
    Ayrshire
    Administrateur
    109 Ayr Road
    KA9 1TN Prestwick
    Ayrshire
    BritishCompany Director861050001
    HENDERSON, William Shields
    Park House 13 Greenhill Park
    EH10 4DW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Park House 13 Greenhill Park
    EH10 4DW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishChartered Accountant55090001
    HOMER, Peter Norman
    West Royd 53 John Street
    G84 9LY Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    West Royd 53 John Street
    G84 9LY Helensburgh
    Dunbartonshire
    BritishManager496850001
    INGLEBY, John Mungo
    Malling Farm
    Port Of Menteith
    FK8 3RD Stirling
    Administrateur
    Malling Farm
    Port Of Menteith
    FK8 3RD Stirling
    ScotlandBritishMerchant Banker308320001
    MACDONALD, Angus Donald Mackintosh
    18 Hermitage Drive
    EH10 6BZ Edinburgh
    Administrateur
    18 Hermitage Drive
    EH10 6BZ Edinburgh
    ScotlandBritishBanker43780001
    MCGARVIE, Henry Murray
    26 Station Road
    Balfron
    G63 0SY Glasgow
    Administrateur
    26 Station Road
    Balfron
    G63 0SY Glasgow
    ScotlandBritishChartered Accountant34002400001
    MOFFAT, James Harkness
    Sarala 23 Bowfield Road
    KA23 9LD West Kilbride
    Ayrshire
    Administrateur
    Sarala 23 Bowfield Road
    KA23 9LD West Kilbride
    Ayrshire
    BritishCompany Director90610001
    MORRISH, John Sutherland Cavers
    5 Chesters Road
    Bearsden
    G61 4AQ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    5 Chesters Road
    Bearsden
    G61 4AQ Glasgow
    Lanarkshire
    BritishCompany Director3673640001
    PEEBLES, Alexander Douglas
    Lindean 85 South Broomage Avenue
    FK5 3ED Larbert
    Stirlingshire
    Administrateur
    Lindean 85 South Broomage Avenue
    FK5 3ED Larbert
    Stirlingshire
    BritishCompany Director152350001
    ROMANES, Deirdre Mary Astrea
    33 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Administrateur
    33 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    United KingdomIrishCompany Director3206310002
    ROMANES, Iain Blair
    Hillside House
    Saline
    KY12 9TD Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    Hillside House
    Saline
    KY12 9TD Dunfermline
    Fife
    BritishCompany Director182800001

    WEST INDEPENDENT NEWSPAPERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 18 avr. 2012
    Livré le 25 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 27 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 27 oct. 1993
    Livré le 02 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    20 and 22 candleriggs, alloa.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 nov. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 15 oct. 1993
    Livré le 22 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3-5 lade street, largs.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 oct. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 15 oct. 1993
    Livré le 22 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.336 acres at herald street, ardrossan, ayrshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 oct. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 15 oct. 1993
    Livré le 22 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    49 ayr road, cumnock.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 oct. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 06 oct. 1993
    Livré le 07 oct. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 oct. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 07 déc. 1984
    Livré le 14 déc. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Investors in Industry PLC
    Transactions
    • 14 déc. 1984Enregistrement d'une charge
    • 15 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 07 déc. 1984
    Livré le 11 déc. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Scottish Allied Investors Limited
    Transactions
    • 11 déc. 1984Enregistrement d'une charge
    • 15 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 07 déc. 1984
    Livré le 11 déc. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • County Bank Limited
    Transactions
    • 11 déc. 1984Enregistrement d'une charge
    • 15 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 07 déc. 1984
    Livré le 11 déc. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rothschild Nominees LTD
    Transactions
    • 11 déc. 1984Enregistrement d'une charge
    • 15 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 05 déc. 1984
    Livré le 14 déc. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 déc. 1984Enregistrement d'une charge
    • 15 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0