DUNEDIN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY (RETAIL) LIMITED

DUNEDIN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY (RETAIL) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDUNEDIN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY (RETAIL) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC091272
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DUNEDIN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY (RETAIL) LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe DUNEDIN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY (RETAIL) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor,
    43 Melville Street
    EH3 7JF Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DUNEDIN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY (RETAIL) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ORRMAC (NO.35) LIMITED17 janv. 198517 janv. 1985

    Quels sont les derniers comptes de DUNEDIN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY (RETAIL) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour DUNEDIN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY (RETAIL) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de 1a Glenfinlas Street Edinburgh EH3 6AQ le 12 juil. 2010

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 mars 2010

    État du capital au 26 mars 2010

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2008

    9 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages287

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    7 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    7 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages287

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2004

    8 pagesAA

    legacy

    2 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2003

    9 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2002

    8 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    8 pages363s

    Qui sont les dirigeants de DUNEDIN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY (RETAIL) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FULLERTON, Albert Smyth
    1 South Lauder Road
    EH9 2LL Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    1 South Lauder Road
    EH9 2LL Edinburgh
    Midlothian
    British76362700002
    BARRY, Roun Brendan
    Saracens
    Saunders Lane
    GU22 0NU Woking
    Surrey
    Administrateur
    Saracens
    Saunders Lane
    GU22 0NU Woking
    Surrey
    EnglandIrish26177120002
    FULLERTON, Albert Smyth
    1 South Lauder Road
    EH9 2LL Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    1 South Lauder Road
    EH9 2LL Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish76362700002
    GIBSON, Scott
    Woodhall Road
    Colinton
    EH13 0DT Edinburgh
    15
    Scotland
    Administrateur
    Woodhall Road
    Colinton
    EH13 0DT Edinburgh
    15
    Scotland
    United KingdomBritish140893250001
    BARRY, Roun Brendan
    Saracens
    Saunders Lane
    GU22 0NU Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Saracens
    Saunders Lane
    GU22 0NU Woking
    Surrey
    Irish26177120002
    BARRY, Roun Brendan
    31 Horsell Park Close
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    Secrétaire
    31 Horsell Park Close
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    British26177120001
    BROUGH, James
    30 North Gyle Drive
    EH12 8JN Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    30 North Gyle Drive
    EH12 8JN Edinburgh
    Midlothian
    British1040790001
    CAMPBELL, Hew
    44 Castleknowe Gardens
    Kirkton Park
    ML8 5UX Carluke
    Scotland
    Secrétaire
    44 Castleknowe Gardens
    Kirkton Park
    ML8 5UX Carluke
    Scotland
    British1416100007
    MILLS, Alan Ewing
    Sheriffs Park
    EH49 7SR Linlithgow
    87
    West Lothian
    Secrétaire
    Sheriffs Park
    EH49 7SR Linlithgow
    87
    West Lothian
    British1268780001
    PATIENCE, Andrew Stephen
    8 Kinnear Road
    EH3 5PE Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    8 Kinnear Road
    EH3 5PE Edinburgh
    Midlothian
    British1386620001
    SHEPHERD, Neil Morton
    35 Kaimes Road
    EH12 6JT Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    35 Kaimes Road
    EH12 6JT Edinburgh
    Midlothian
    British1063630001
    WARD, Anne
    1a South Hamilton Road
    EH39 4NJ North Berwick
    East Lothian
    Secrétaire
    1a South Hamilton Road
    EH39 4NJ North Berwick
    East Lothian
    British47639170001
    BAARA-GOETTSCH, Johanna Baukje
    Mathenesselaan 3
    2343 HA Oegstgeest
    Netherlands
    Administrateur
    Mathenesselaan 3
    2343 HA Oegstgeest
    Netherlands
    Dutch36159850002
    BARRY, Roun Brendan
    31 Horsell Park Close
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    Administrateur
    31 Horsell Park Close
    GU21 4LZ Woking
    Surrey
    British26177120001
    BEATTIE, Robert Henry
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    10 Swanston Green
    EH10 7EW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish27224590001
    BINNIAN, Jeremy John
    Pear Tree Farm
    Hessay
    YO26 8JT York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Pear Tree Farm
    Hessay
    YO26 8JT York
    North Yorkshire
    EnglandBritish1291220002
    BUCHANAN, Richard Robertson Trail
    Lynwood
    6 Essex Road
    EH4 6LG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Lynwood
    6 Essex Road
    EH4 6LG Edinburgh
    Midlothian
    British32224420001
    CAMPBELL, Hew
    44 Castleknowe Gardens
    Kirkton Park
    ML8 5UX Carluke
    Scotland
    Administrateur
    44 Castleknowe Gardens
    Kirkton Park
    ML8 5UX Carluke
    Scotland
    British1416100007
    CARTLEDGE, David Edmund
    Raines Lodge
    Greenway
    CM13 2NR Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Raines Lodge
    Greenway
    CM13 2NR Brentwood
    Essex
    British38897330001
    DE BOCK, David Jacques Andre
    Beysterveld 107
    1083 KB Amsterdam
    Administrateur
    Beysterveld 107
    1083 KB Amsterdam
    British38537570001
    FORREST, Michael Alexander
    23 Barnton Avenue
    EH4 6AJ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    23 Barnton Avenue
    EH4 6AJ Edinburgh
    Midlothian
    Great BritainBritish53460001
    LOCHHEAD, Ian William Thomson
    72 Spylawbank Road
    Colinton
    EH13 0JD Edinburgh
    Administrateur
    72 Spylawbank Road
    Colinton
    EH13 0JD Edinburgh
    United KingdomBritish1180230001
    LOMAS, Ian Paul
    Caledon Road
    HP9 2BX Beaconsfield
    21
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Caledon Road
    HP9 2BX Beaconsfield
    21
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish94970360001
    MERCER, Alexander Wallace
    Flat 3, Carlekemp Priory
    Abbotsford Road
    EH39 5DA North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Flat 3, Carlekemp Priory
    Abbotsford Road
    EH39 5DA North Berwick
    East Lothian
    British64889260001
    SACH, Derek Stephen
    Warren Lodge
    32 Leigh Hill Road
    KT11 2HZ Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Warren Lodge
    32 Leigh Hill Road
    KT11 2HZ Cobham
    Surrey
    British646390001
    SHEAVILLS, Ernest Michael
    Coombe House, 8 Westgarth Avenue
    Colinton
    EH13 0BD Edinburgh
    Administrateur
    Coombe House, 8 Westgarth Avenue
    Colinton
    EH13 0BD Edinburgh
    British34817880001
    VAN DEN BERG, Herman Christiaan
    Eizenlaan 53
    3871 BL Hoevelaken
    The Netherlands
    Administrateur
    Eizenlaan 53
    3871 BL Hoevelaken
    The Netherlands
    Dutch50095730001
    WHITEHEAD, Grahame Taylor
    Dunira 19 Whim Road
    EH31 2BD Gullane
    East Lothian
    Administrateur
    Dunira 19 Whim Road
    EH31 2BD Gullane
    East Lothian
    British1363570002
    WINCHESTER, Colin
    Fairfield 26 Gamekeepers Road
    EH4 6LU Edinburgh
    Administrateur
    Fairfield 26 Gamekeepers Road
    EH4 6LU Edinburgh
    British53067480001
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Administrateur
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritish161858620001

    DUNEDIN PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY (RETAIL) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of offset
    Créé le 01 mai 1987
    Livré le 15 mai 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by dunedin property development company LTD and/or another
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the governor & co. Of the bank of scotland in the name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 mai 1987Enregistrement d'une charge
    • 22 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 25 juil. 1986
    Livré le 06 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 22 sept. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 juil. 1985
    Livré le 02 août 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3 areas of ground on or around kerse lane, falkirk.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 août 1985Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0