STRATHTAY SCOTTISH OMNIBUSES LIMITED

STRATHTAY SCOTTISH OMNIBUSES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTRATHTAY SCOTTISH OMNIBUSES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC091932
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STRATHTAY SCOTTISH OMNIBUSES LIMITED ?

    • Autre transport terrestre de voyageurs urbain, suburbain ou métropolitain (hors métro, métro léger et systèmes similaires) (49319) / Transports et stockage

    Où se situe STRATHTAY SCOTTISH OMNIBUSES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    10 Dunkeld Road
    Perth
    PH1 5TW Perthshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de STRATHTAY SCOTTISH OMNIBUSES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour STRATHTAY SCOTTISH OMNIBUSES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour STRATHTAY SCOTTISH OMNIBUSES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 07 avr. 2014

    16 pagesRP04

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 avr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 avr. 2015

    État du capital au 07 avr. 2015

    • Capital: GBP 2,119,741
    SH01
    capital07 avr. 2015

    État du capital au 14 avr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01
    Annotations
    DateAnnotation
    14 avr. 2015Clarification A second filed AR01 was registered on 14/04/2015.

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 18 mars 2015

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    That the amount by which the capital of the company is so reduced be transferred to the companys profit and loss amount 17/03/2015
    RES13

    Cessation de la nomination de Robert Montgomery en tant que directeur le 23 févr. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gary James Nolan en tant que directeur le 23 févr. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Simon Jarvis en tant que directeur le 23 févr. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Gervase Andrew en tant que directeur le 23 févr. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Samuel Derek Greer en tant que directeur le 23 févr. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2014

    24 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Samuel Derek Greer le 09 juin 2014

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 avr. 2014

    État du capital au 08 avr. 2014

    • Capital: GBP 2,119,741
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael John Vaux le 20 mars 2014

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Charles Mullen en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Andrew Simon Jarvis en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2013

    23 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gary James Nolan le 03 mai 2013

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Gary James Nolan en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Leslie Warneford en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de STRATHTAY SCOTTISH OMNIBUSES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish85970020003
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish137383880003
    BEATTIE, David Rae
    13 Chapman Drive
    DD7 6DX Carnoustie
    Angus
    Secrétaire
    13 Chapman Drive
    DD7 6DX Carnoustie
    Angus
    British71059100002
    MULLEN, Charles
    349 Blackness Road
    DD2 1SN Dundee
    Angus
    Secrétaire
    349 Blackness Road
    DD2 1SN Dundee
    Angus
    British642010001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Secrétaire
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    ANDREW, Robert Gervase
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish54172700004
    CARTER, Frank Albert
    Brookfields 31 Applehaigh Lane
    Notton
    WF4 2NA Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Brookfields 31 Applehaigh Lane
    Notton
    WF4 2NA Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish3479840001
    CARTER, Michael Frank
    29 The Mount
    WF2 0NZ Wrenthorpe
    West Yorkshire
    Administrateur
    29 The Mount
    WF2 0NZ Wrenthorpe
    West Yorkshire
    United KingdomBritish86998020003
    DOUGLAS, Archibald
    198 Colinton Road
    EH14 1BP Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    198 Colinton Road
    EH14 1BP Edinburgh
    Midlothian
    British465150001
    EDMOND, John Mcfarlane
    Thorn Tree 20 Bonnington
    EH27 8BB Kirknewton
    Midlothian
    Administrateur
    Thorn Tree 20 Bonnington
    EH27 8BB Kirknewton
    Midlothian
    British35451980001
    GREER, Samuel Derek
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish140386230006
    JARVIS, Andrew Simon
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish230200500001
    MONTGOMERY, Robert
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish122403240002
    MULLEN, Charles
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish642010001
    MYERS, John Highton
    25 Rainton Grove
    S75 2QZ Barnsley
    South Yorkshire
    Administrateur
    25 Rainton Grove
    S75 2QZ Barnsley
    South Yorkshire
    British3479850001
    NOLAN, Gary James
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish65317320002
    PEACH, George Arthur
    Greenacres 332 Barnsley Road
    Flockton
    WF4 4AT Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Greenacres 332 Barnsley Road
    Flockton
    WF4 4AT Wakefield
    West Yorkshire
    British5265340002
    RENILSON, Neil John
    Essendean Perth Road
    PH10 6EN Blairgowrie
    Perthshire
    Administrateur
    Essendean Perth Road
    PH10 6EN Blairgowrie
    Perthshire
    British42889750001
    RICHARDSON, Ian
    21 Blackford Hill Rise
    EH9 3HB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    21 Blackford Hill Rise
    EH9 3HB Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish1275850001
    ROBERTSON, Thomas Robert
    27 Dundee Road West
    Broughty Ferry
    DD5 1NB Dundee
    Angus
    Administrateur
    27 Dundee Road West
    Broughty Ferry
    DD5 1NB Dundee
    Angus
    British56999370003
    SMITH, Eric Brian
    16 Green Lane
    DD7 6AA Carnoustie
    Angus
    Administrateur
    16 Green Lane
    DD7 6AA Carnoustie
    Angus
    British1369890001
    STARK, John
    94/4 Whitehouse Loan
    EH9 1BD Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    94/4 Whitehouse Loan
    EH9 1BD Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish597660002
    STEWART, Malcolm Somerville
    53 Bennochy Road
    KY2 5RB Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    53 Bennochy Road
    KY2 5RB Kirkcaldy
    Fife
    British465130001
    THOMAS, Sholto Douglas Vyvyan
    11 Meadowview Drive
    Inchture
    PH14 9RQ Perth
    Perthshire
    Administrateur
    11 Meadowview Drive
    Inchture
    PH14 9RQ Perth
    Perthshire
    British1369880001
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish49771140004

    STRATHTAY SCOTTISH OMNIBUSES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 17 oct. 1997
    Livré le 07 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £226,000
    Brèves mentions
    Seagate bus station,dundee.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Enterprise Tayside
    Transactions
    • 07 nov. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 17 oct. 1997
    Livré le 23 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £330,000 as specified in a minute of agreement
    Brèves mentions
    Seagate bus station,seagate,dundee.
    Personnes ayant droit
    • Dundee City Council
    Transactions
    • 23 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 30 juin 1995
    Livré le 05 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 05 juil. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 nov. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 22 juin 1993
    Livré le 01 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 01 juil. 1993Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 nov. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 22 mars 1991
    Livré le 09 avr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Bus depot at riggs road perth.
    Personnes ayant droit
    • S T G Properties Limited
    Transactions
    • 09 avr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 24 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 08 mars 1991
    Livré le 20 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Bus station/depot at seagate, dundee.
    Personnes ayant droit
    • S T G Properties Limited
    Transactions
    • 20 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 08 mars 1991
    Livré le 20 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Bus station at church street crieff, perthshire.
    Personnes ayant droit
    • S T G Properties Limited
    Transactions
    • 20 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 24 août 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 08 mars 1991
    Livré le 20 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Bus depot at rossie island, montrose.
    Personnes ayant droit
    • S T G Properties Limited
    Transactions
    • 20 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 08 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0