RUBY DCO TWELVE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRUBY DCO TWELVE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC093093
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RUBY DCO TWELVE LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe RUBY DCO TWELVE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RUBY DCO TWELVE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LIVINGSTON HEALTH CENTRE (P.D.) CO. LIMITED30 avr. 198530 avr. 1985

    Quels sont les derniers comptes de RUBY DCO TWELVE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour RUBY DCO TWELVE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Modification des détails de Ruby Dco Eleven Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 sept. 2023

    2 pagesPSC05

    Modification des détails de Munro Pharmacy Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept. 2023

    2 pagesPSC05

    Changement d'adresse du siège social de 204 Polmadie Road Hampden Park Industrial Estate Glasgow G42 0PH Scotland à Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street Glasgow G2 1BP le 18 sept. 2023

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Graham Wiseman en tant que directeur le 31 août 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Thorsten Sprank en tant qu'administrateur le 31 août 2023

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Sole director appointment 31/08/2023
    RES13

    Certificat de changement de nom

    Company name changed livingston health centre (P.D.) co. LIMITED\certificate issued on 04/09/23
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name04 sept. 2023

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    État du capital au 16 août 2023

    • Capital: GBP 0.01
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 22 mars 2023 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Wendy Margaret Hall en tant que directeur le 09 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nichola Louise Legg en tant que secrétaire le 09 sept. 2022

    1 pagesTM02

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Détails de la variation des droits attachés aux actions

    2 pagesSH10

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Statuts

    33 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Removal of restriction on authorised share capital / ratification of directors actions 07/09/2022
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Nomination de Graham Wiseman en tant qu'administrateur le 07 sept. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Christian Keen en tant que directeur le 18 mai 2022

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de RUBY DCO TWELVE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SPRANK, Thorsten
    International House, Crays Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5
    United Kingdom
    Administrateur
    International House, Crays Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5
    United Kingdom
    EnglandGerman203900280002
    BAXTER, Anthony
    Highview
    21 Chater Drive
    CW5 7GH Nantwich
    Cheshire
    Secrétaire
    Highview
    21 Chater Drive
    CW5 7GH Nantwich
    Cheshire
    British101256650001
    BENNETT, Alan
    Scotts Chemist
    Blackburn
    Bathgate
    Secrétaire
    Scotts Chemist
    Blackburn
    Bathgate
    British214900001
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secrétaire
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    FORSTER, Craig Stuart
    32 Cypress Glade
    EH54 9JH Livingston
    West Lothian
    Secrétaire
    32 Cypress Glade
    EH54 9JH Livingston
    West Lothian
    British43309520002
    LAMBIE, Edward Ezekiel Anthony
    279 Crow Road
    G11 7BG Glasgow
    Strathclyde
    Secrétaire
    279 Crow Road
    G11 7BG Glasgow
    Strathclyde
    British260940001
    LEGG, Nichola Louise
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secrétaire
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    163214890001
    MAY, Timothy J
    36 Millar Crescent
    EH10 5HH Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    36 Millar Crescent
    EH10 5HH Edinburgh
    Midlothian
    British865060001
    PEIRSE, John Richard
    25 Grant Drive
    FK15 9HU Dunblane
    Perthshire
    Secrétaire
    25 Grant Drive
    FK15 9HU Dunblane
    Perthshire
    British96219070001
    BAXTER, Anthony
    Highview
    21 Chater Drive
    CW5 7GH Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    Highview
    21 Chater Drive
    CW5 7GH Nantwich
    Cheshire
    British101256650001
    BEER, Thorsten
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    United KingdomGerman172030260001
    COCHRANE, John
    23 Maxwell Drive
    G74 4HH East Kilbride
    Lanarkshire
    Administrateur
    23 Maxwell Drive
    G74 4HH East Kilbride
    Lanarkshire
    ScotlandBritish153437260001
    HALL, Wendy Margaret
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish172979860001
    HILGER, Marcus
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    GermanyGerman238936580003
    KEEN, Christian
    Hampden Park Industrial Estate
    G42 0PH Glasgow
    204 Polmadie Road
    Scotland
    Administrateur
    Hampden Park Industrial Estate
    G42 0PH Glasgow
    204 Polmadie Road
    Scotland
    EnglandBritish54544790004
    LIPP, Hanns Martin
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    United KingdomGerman220582440001
    MCGREGOR, Jacquelyn
    15 Trinity
    Luncarty
    PH1 3ET Perth
    Perthshire
    Administrateur
    15 Trinity
    Luncarty
    PH1 3ET Perth
    Perthshire
    British1177160001
    MILLER, Alexander
    62 Gallowhill Road
    Carmunock
    Glasgow
    Administrateur
    62 Gallowhill Road
    Carmunock
    Glasgow
    British805790001
    MUNRO, Donald Hume
    10 Stroud Road
    G75 0YA East Kilbride
    Glasgow
    Administrateur
    10 Stroud Road
    G75 0YA East Kilbride
    Glasgow
    ScotlandBritish914040002
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish120451550002
    WISEMAN, Graham
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Administrateur
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish299860960001
    E.MOSS LIMITED
    Fern House
    53-55 High Street
    TW13 4HU Feltham
    Middlesex
    Administrateur
    Fern House
    53-55 High Street
    TW13 4HU Feltham
    Middlesex
    33973430003
    R I MACROBBIE LIMITED
    1 Murieston Vale
    EH54 9EP Livingston
    West Lothian
    `
    Administrateur
    1 Murieston Vale
    EH54 9EP Livingston
    West Lothian
    `
    214930003
    THE BOOTS COMPANY PLC
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    Administrateur
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    19515250001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RUBY DCO TWELVE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48
    Scotland
    06 avr. 2016
    West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 1985
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc273093
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    RUBY DCO TWELVE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 31 déc. 1985
    Livré le 09 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    • 08 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0