BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PUBLIC LIMITED COMPANY

BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PUBLIC LIMITED COMPANY

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PUBLIC LIMITED COMPANY
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société SC093345
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PUBLIC LIMITED COMPANY ?

    • Activités des sociétés d'investissement mobilier (64301) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PUBLIC LIMITED COMPANY ?

    Adresse du siège social
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PUBLIC LIMITED COMPANY ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 janv. 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 juil. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PUBLIC LIMITED COMPANY ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au03 mai 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation17 mai 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au03 mai 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PUBLIC LIMITED COMPANY ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 924,723.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    23 juin 2025Clarification HMRC confirmation has been received that the appropriate stamp duty has been paid in relation to this transaction

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 909,723.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    17 juin 2025Clarification HMRC confirmation has been received that the appropriate stamp duty has been paid in relation to this transaction

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 880,723.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    10 juin 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate duty has been paid in relation to this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 905,723.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    10 juin 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate duty has been paid in relation to this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 878,723.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    06 juin 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate duty has been paid in relation to this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 877,223.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    05 juin 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2025

    134 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolutions

    Share capital reduced by cancelling the entire amount standing to the credit of the companys share premium account 20/05/2025
    RES13
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 873,723.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    21 mai 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate duty has been paid in relation to this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 843,723.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    16 mai 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 820,723.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    15 mai 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 811,723.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    08 mai 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Déclaration de confirmation établie le 03 mai 2025 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 771,723.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    30 avr. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 731,723.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    22 avr. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 711,723.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    07 avr. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 691,723.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    04 avr. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 676,723.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    25 mars 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 648,223.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    06 mars 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 673,723.68
    3 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    06 mars 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Satisfaction de la charge SC0933450014 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0933450009 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0933450005 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0933450013 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC0933450007 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PUBLIC LIMITED COMPANY ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BAILLIE GIFFORD & CO LIMITED
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    United Kingdom
    Secrétaire
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrementSC069524
    188980170001
    FINN, Claire Elizabeth Catherine
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Administrateur
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    EnglandBritishDirector259925030001
    ROTHEROE, Abigail Emma
    Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    Scotland
    Administrateur
    Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    Scotland
    EnglandBritishDirector137874880001
    SKINNER, Colin James Marshall
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    Scotland
    Administrateur
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    Scotland
    ScotlandBritishNone234730920001
    TROUP, Kevin James
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    Administrateur
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    United KingdomBritishNone252579510001
    VIJAYAKUMAR, Sethu, Prof
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    Scotland
    Administrateur
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    Scotland
    ScotlandBritishProfessor Of Robotics249774150001
    BAILLIE GIFFORD & CO
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    Secrétaire
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    Forme juridiqueSCOTTISH PARTNERSHIP
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleLAW OF SCOTLAND
    Numéro d'enregistrementN/A
    593180003
    CHARIG, Paul Francis
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Administrateur
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    EnglandBritishBusiness Consultant6841080002
    DONALDSON, Michael Neil
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    Lothian
    Scotland
    Administrateur
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Calton Square
    Lothian
    Scotland
    ScotlandBritishChief Executive46880540002
    GEMMELL, Gavin John Norman
    14 Midmar Gardens
    EH10 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    14 Midmar Gardens
    EH10 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishInvestment Manager477280001
    HATHORN, Alexander Michael
    Flat 2 44 Drury Lane
    WC2B 5RX London
    Administrateur
    Flat 2 44 Drury Lane
    WC2B 5RX London
    United KingdomBritishCa Practice Partner104860930001
    JOHNSTONE, Ian Temple
    45 Moray Place
    EH3 6BQ Edinburgh
    Administrateur
    45 Moray Place
    EH3 6BQ Edinburgh
    BritishWs89550001
    MCLAREN, Iain Archibald
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Administrateur
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    ScotlandBritishCompany Director68111210001
    MCLEISH, Ian Clelland
    18 Kingsburgh Road
    EH12 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    18 Kingsburgh Road
    EH12 6DZ Edinburgh
    Midlothian
    BritishCompany Director297130001
    MINALL, John Charles
    Bridgebrook House
    14 London Road
    RH15 8QX Burgess Hill
    West Sussex
    Administrateur
    Bridgebrook House
    14 London Road
    RH15 8QX Burgess Hill
    West Sussex
    BritishManagement Consultant52558740001
    RITCHIE, David Cowan
    48 Dick Place
    EH9 2JB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    48 Dick Place
    EH9 2JB Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishInvestment Manager26865440001
    ROSE, Barry Michael
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Administrateur
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    United KingdomBritishCompany Director1044490001
    SOMERSET WEBB, Merryn Rosemary
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Administrateur
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    United KingdomBritishEditor160108550001
    SOMERVILLE, Simon Christopher Neale
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Administrateur
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    EnglandBritishFund Manager106073940001
    TULLOCH, Angus John
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Administrateur
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    ScotlandBritishInvestment Manager27009450001
    VEITCH, George
    22 Midmar Drive
    EH10 6BU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    22 Midmar Drive
    EH10 6BU Edinburgh
    Midlothian
    BritishInvestment Manager477310001
    WHITLEY, Sarah Jane Mackay
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    Administrateur
    Calton Square
    1 Greenside Row
    EH1 3AN Edinburgh
    United KingdomBritishFund Manager41481380001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0