GREEN ACTION TRUST
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GREEN ACTION TRUST |
|---|---|
| Statut de la société | Converti / Fermé |
| Forme juridique | Converti ou fermé |
| Numéro de société | SC093544 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GREEN ACTION TRUST ?
| Adresse du siège social | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GREEN ACTION TRUST ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 2020 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2021 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour GREEN ACTION TRUST ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes consolid és établis au 30 sept. 2019 | 39 pages | AA | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed central scotland green network trust\certificate issued on 20/07/20 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Exemption de changement de nom" de l'utilisation de "limitée" ou "cyfyngedig" | 1 pages | NE01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Keith Douglas Wishart en tant que directeur le 30 juin 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Edward Lauder en tant que directeur le 30 juin 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Malcolm Byers en tant que directeur le 30 juin 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Scott Broadley en tant que directeur le 30 juin 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||
Statuts | 24 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Naomi Ruth Arnold en tant que directeur le 27 mars 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Arthur Asher Keller en tant que directeur le 06 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Inscription de la charge SC0935440009, créée le 06 sept. 2019 | 17 pages | MR01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Carron Ann Garmory en tant que directeur le 19 juin 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 30 sept. 2018 | 37 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Richard Scott Broadley en tant qu'administrateur le 29 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Keith Douglas Wishart en tant qu'administrateur le 29 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Statuts | 27 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de GREEN ACTION TRUST ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELLY, Christina Sneddon | Secrétaire | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | 156547580001 | |||||||
| GEDDES, Keith Taylor | Administrateur | c/o Pagoda Pr 4 Eyre Place EH3 5JP Edinburgh 4 Scotland | Scotland | British | 975490004 | |||||
| LOWTHER, Matthew | Administrateur | Meridian Court Cadogan Street G2 6QE Glasgow Nhs Health Scotland Scotland | Scotland | British | 196763470001 | |||||
| PURVES, Karen | Administrateur | Strand Street KA1 1HU Kilmarnock East Ayrshire Council Scotland | Scotland | British | 234674970001 | |||||
| TAIT, Stuart | Administrateur | 125 West Regent Street Lower Ground Floor G2 2SA Glasgow Clydeplan Scotland | Scotland | British | 186422910001 | |||||
| WARDROP, Martha Ferguson | Administrateur | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Scotland | British | 114206150001 | |||||
| EDWARDS, Penelope Ann | Secrétaire | Mavisbank Farm Shieldhill Road FK1 2AZ Falkirk Stirlingshire | British | 57444730001 | ||||||
| GEMMELL, James Campbell, Dr | Secrétaire | Elvang, Queenshuagh Riverside FK8 1XH Stirling | British | 55640360001 | ||||||
| HICKMAN, Elizabeth Linda | Secrétaire | 41 Burns Place ML7 4LQ Shotts Lanarkshire | British | 752900004 | ||||||
| MACDONALD, Shona Helen | Secrétaire | 16 Walnut Drive Lenzie G66 4BP Glasgow | British | 76263700002 | ||||||
| MILLAR, Jayne | Secrétaire | 8 Woodhall Road Calderbank ML6 9SP Airdrie Lanarkshire | British | 50678460001 | ||||||
| PALMER, John Carrington | Secrétaire | 15/2 Brights Crescent EH9 2DB Edinburgh Midlothian | British | 66990520001 | ||||||
| YOUNG, Donald | Secrétaire | 39 Park Place FK7 9JR Stirling | British | 84283580001 | ||||||
| ALCORN, Christopher Michael | Administrateur | Southfield Gardens West Duddingston EH15 1RL Edinburgh 12 Lothian | United Kingdom | British | 135788150001 | |||||
| ALDHOUS, John Robert | Administrateur | 12 Hallhead Road EH16 5QJ Edinburgh Midlothian | British | 142918020001 | ||||||
| ANDERSON, James Fraser Gillan, Councillor | Administrateur | 23 California Road Maddiston FK2 0NH Falkirk Stirlingshire | British | 1247620001 | ||||||
| ARNOLD, Naomi Ruth | Administrateur | Prince Edward Street G42 8LX Glasgow 1/1 75 Prince Edward Street Scotland | Scotland | British | 227961240001 | |||||
| BECK, Sheila Anne, Dr | Administrateur | c/o Nhs Health Scotland Cadogan Street G2 6QE Glasgow Meridian Court Scotland | Scotland | British | 175621030001 | |||||
| BELL, Christine | Administrateur | Croftfoot Place FK6 6QT Duncipace 11 Stirlingshire | United Kingdom | British | 134169350001 | |||||
| BOTHAM, Margaret Elizabeth | Administrateur | 22 Station Road ML8 5AD Carluke Lanarkshire | Scotland | United Kingdom | 95351570001 | |||||
| BOWDEN, Lorna | Administrateur | Flat 2/1 139 Cartvale Road G42 9RN Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 102111360001 | |||||
| BOYLE, William Hannah, Councillor | Administrateur | 28 Kirk Road EH48 1BW Bathgate West Lothian | Scotland | Scottish | 122333080001 | |||||
| BRIGGS, Ruth Frances | Administrateur | 8 Camptoun Holdings Drem EH39 5BA North Berwick East Lothian | Scotland | British | 85919910001 | |||||
| BROADLEY, Richard Scott | Administrateur | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Scotland | British | 200982870001 | |||||
| BURNS, Andrew, Councillor | Administrateur | 12 Douglas Place ML5 1BY Coatbridge Lanarkshire | British | 42513680001 | ||||||
| BURY, John | Administrateur | c/o The City Of Edinburgh Council East Market Street EH8 8BG Edinburgh The City Of Edinburgh Council Scotland | Scotland | British | 186793430001 | |||||
| BYERS, David Malcolm | Administrateur | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | United Kingdom | British | 223794130001 | |||||
| CALDER, Marjorie | Administrateur | 3 Newton Place Newton Mearns G77 5PG Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 116418370002 | |||||
| CAMPBELL, Robert | Administrateur | 128 Strathayr Place KA8 0AY Ayr Ayrshire | British | 921130001 | ||||||
| COLLINS, Kenneth Darlington, Sir | Administrateur | 11 Stuarton Park G74 4LA East Kilbride Strathclyde Uk | British | 51766710001 | ||||||
| CONN, Thomas | Administrateur | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Scotland | British | 167756650001 | |||||
| CRAWLEY, David Jonathan | Administrateur | Gatehouse Of Fleet DG7 2EH Castle Douglas Fleetwood House Kirkcudbrightshire | United Kingdom | British | 120645880003 | |||||
| CUMMING, Joseph | Administrateur | 12 Loaninghill Park Uphall EH52 5EB Broxburn West Lothian | British | 190480001 | ||||||
| DAVIDSON, Alexander, Councillor | Administrateur | 4 Freeland Terrace EH52 5JR Broxburn West Lothian | British | 105858680001 | ||||||
| DAVISON, Richard William, Dr | Administrateur | Redgorton PH1 3EW Perth Battleby Perth & Kinross Scotland | Scotland | British | 139077410001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GREEN ACTION TRUST ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mr Simon Rennie | 11 juil. 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Matthew Lowther | 11 juil. 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr John Edward Lauder | 11 juil. 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mrs Carron Ann Garmory | 11 juil. 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Arthur Asher Keller | 11 juil. 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Derek Mccrindle | 11 juil. 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr James Ogilivie | 11 juil. 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Keith Taylor Geddes | 11 juil. 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Peter Macleod Russell | 11 juil. 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
| Ms Marion Mackay Francis | 11 juil. 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mrs Linda Gow | 11 juil. 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr Stuart Tait | 11 juil. 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
| Mr John Bury | 11 juil. 2016 | Hillhouseridge Shottskirk Road ML7 4JS Shotts North Lanarkshire | Oui |
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||
Nature du contrôle
| |||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour GREEN ACTION TRUST ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 11 juil. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
GREEN ACTION TRUST a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 06 sept. 2019 Livré le 11 sept. 2019 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 02 sept. 2016 Livré le 08 sept. 2016 | En cours | ||
Brève description Hillhouseridge farm, shottskirk road, shotts. LAN25088. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 03 déc. 2014 Livré le 15 déc. 2014 | En cours | ||
Brève description All and whole the subjects registered in the land register - title number STG65031. Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 05 nov. 2012 Livré le 14 nov. 2012 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The two areas of land south of the B818 public road at townfoot, title number STG65031. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 29 avr. 1988 Livré le 19 mai 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 07 janv. 1988 Livré le 11 janv. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 25 mars 1987 Livré le 30 mars 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions 158.510 acres or thereby in the parish of shotts and county of lanark (under exception) known as hillhouseridge farm. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 31 oct. 1986 Livré le 19 nov. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 02 oct. 1986 Livré le 09 oct. 1986 | En cours | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The lands and others known as hillhouseridge farm, shotts, lanarkshire under exception. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0