GREEN ACTION TRUST

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGREEN ACTION TRUST
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société SC093544
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GREEN ACTION TRUST ?

    • Sylviculture et autres activités forestières (02100) / Agriculture, sylviculture et pêche

    Où se situe GREEN ACTION TRUST ?

    Adresse du siège social
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GREEN ACTION TRUST ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CENTRAL SCOTLAND GREEN NETWORK TRUST28 mars 201428 mars 2014
    CENTRAL SCOTLAND FOREST TRUST09 sept. 200209 sept. 2002
    CENTRAL SCOTLAND COUNTRYSIDE TRUST17 déc. 199317 déc. 1993
    CENTRAL SCOTLAND WOODLANDS: A COUNTRYSIDE TRUST15 avr. 199215 avr. 1992
    CENTRAL SCOTLAND COUNTRYSIDE TRUST31 mai 198531 mai 1985

    Quels sont les derniers comptes de GREEN ACTION TRUST ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2020
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2021
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour GREEN ACTION TRUST ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    The company (charity no.SC015341) converted into a scio on 19/01/21 14/09/2020
    RES13

    Comptes consolidés établis au 30 sept. 2019

    39 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed central scotland green network trust\certificate issued on 20/07/20
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name20 juil. 2020

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Exemption de changement de nom" de l'utilisation de "limitée" ou "cyfyngedig"

    1 pagesNE01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Cessation de la nomination de Keith Douglas Wishart en tant que directeur le 30 juin 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Edward Lauder en tant que directeur le 30 juin 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Malcolm Byers en tant que directeur le 30 juin 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Scott Broadley en tant que directeur le 30 juin 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Statuts

    24 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration de confirmation établie le 28 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Naomi Ruth Arnold en tant que directeur le 27 mars 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Arthur Asher Keller en tant que directeur le 06 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge SC0935440009, créée le 06 sept. 2019

    17 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 28 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Carron Ann Garmory en tant que directeur le 19 juin 2019

    1 pagesTM01

    Comptes consolidés établis au 30 sept. 2018

    37 pagesAA

    Nomination de Mr Richard Scott Broadley en tant qu'administrateur le 29 mars 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Keith Douglas Wishart en tant qu'administrateur le 29 mars 2019

    2 pagesAP01

    Statuts

    27 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de GREEN ACTION TRUST ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KELLY, Christina Sneddon
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Secrétaire
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    156547580001
    GEDDES, Keith Taylor
    c/o Pagoda Pr
    4
    Eyre Place
    EH3 5JP Edinburgh
    4
    Scotland
    Administrateur
    c/o Pagoda Pr
    4
    Eyre Place
    EH3 5JP Edinburgh
    4
    Scotland
    ScotlandBritish975490004
    LOWTHER, Matthew
    Meridian Court
    Cadogan Street
    G2 6QE Glasgow
    Nhs Health Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Meridian Court
    Cadogan Street
    G2 6QE Glasgow
    Nhs Health Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish196763470001
    PURVES, Karen
    Strand Street
    KA1 1HU Kilmarnock
    East Ayrshire Council
    Scotland
    Administrateur
    Strand Street
    KA1 1HU Kilmarnock
    East Ayrshire Council
    Scotland
    ScotlandBritish234674970001
    TAIT, Stuart
    125 West Regent Street
    Lower Ground Floor
    G2 2SA Glasgow
    Clydeplan
    Scotland
    Administrateur
    125 West Regent Street
    Lower Ground Floor
    G2 2SA Glasgow
    Clydeplan
    Scotland
    ScotlandBritish186422910001
    WARDROP, Martha Ferguson
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Administrateur
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    ScotlandBritish114206150001
    EDWARDS, Penelope Ann
    Mavisbank Farm Shieldhill Road
    FK1 2AZ Falkirk
    Stirlingshire
    Secrétaire
    Mavisbank Farm Shieldhill Road
    FK1 2AZ Falkirk
    Stirlingshire
    British57444730001
    GEMMELL, James Campbell, Dr
    Elvang, Queenshuagh
    Riverside
    FK8 1XH Stirling
    Secrétaire
    Elvang, Queenshuagh
    Riverside
    FK8 1XH Stirling
    British55640360001
    HICKMAN, Elizabeth Linda
    41 Burns Place
    ML7 4LQ Shotts
    Lanarkshire
    Secrétaire
    41 Burns Place
    ML7 4LQ Shotts
    Lanarkshire
    British752900004
    MACDONALD, Shona Helen
    16 Walnut Drive
    Lenzie
    G66 4BP Glasgow
    Secrétaire
    16 Walnut Drive
    Lenzie
    G66 4BP Glasgow
    British76263700002
    MILLAR, Jayne
    8 Woodhall Road
    Calderbank
    ML6 9SP Airdrie
    Lanarkshire
    Secrétaire
    8 Woodhall Road
    Calderbank
    ML6 9SP Airdrie
    Lanarkshire
    British50678460001
    PALMER, John Carrington
    15/2 Brights Crescent
    EH9 2DB Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    15/2 Brights Crescent
    EH9 2DB Edinburgh
    Midlothian
    British66990520001
    YOUNG, Donald
    39 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    Secrétaire
    39 Park Place
    FK7 9JR Stirling
    British84283580001
    ALCORN, Christopher Michael
    Southfield Gardens West
    Duddingston
    EH15 1RL Edinburgh
    12
    Lothian
    Administrateur
    Southfield Gardens West
    Duddingston
    EH15 1RL Edinburgh
    12
    Lothian
    United KingdomBritish135788150001
    ALDHOUS, John Robert
    12 Hallhead Road
    EH16 5QJ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    12 Hallhead Road
    EH16 5QJ Edinburgh
    Midlothian
    British142918020001
    ANDERSON, James Fraser Gillan, Councillor
    23 California Road
    Maddiston
    FK2 0NH Falkirk
    Stirlingshire
    Administrateur
    23 California Road
    Maddiston
    FK2 0NH Falkirk
    Stirlingshire
    British1247620001
    ARNOLD, Naomi Ruth
    Prince Edward Street
    G42 8LX Glasgow
    1/1 75 Prince Edward Street
    Scotland
    Administrateur
    Prince Edward Street
    G42 8LX Glasgow
    1/1 75 Prince Edward Street
    Scotland
    ScotlandBritish227961240001
    BECK, Sheila Anne, Dr
    c/o Nhs Health Scotland
    Cadogan Street
    G2 6QE Glasgow
    Meridian Court
    Scotland
    Administrateur
    c/o Nhs Health Scotland
    Cadogan Street
    G2 6QE Glasgow
    Meridian Court
    Scotland
    ScotlandBritish175621030001
    BELL, Christine
    Croftfoot Place
    FK6 6QT Duncipace
    11
    Stirlingshire
    Administrateur
    Croftfoot Place
    FK6 6QT Duncipace
    11
    Stirlingshire
    United KingdomBritish134169350001
    BOTHAM, Margaret Elizabeth
    22 Station Road
    ML8 5AD Carluke
    Lanarkshire
    Administrateur
    22 Station Road
    ML8 5AD Carluke
    Lanarkshire
    ScotlandUnited Kingdom95351570001
    BOWDEN, Lorna
    Flat 2/1 139 Cartvale Road
    G42 9RN Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    Flat 2/1 139 Cartvale Road
    G42 9RN Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish102111360001
    BOYLE, William Hannah, Councillor
    28 Kirk Road
    EH48 1BW Bathgate
    West Lothian
    Administrateur
    28 Kirk Road
    EH48 1BW Bathgate
    West Lothian
    ScotlandScottish122333080001
    BRIGGS, Ruth Frances
    8 Camptoun Holdings
    Drem
    EH39 5BA North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    8 Camptoun Holdings
    Drem
    EH39 5BA North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish85919910001
    BROADLEY, Richard Scott
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Administrateur
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    ScotlandBritish200982870001
    BURNS, Andrew, Councillor
    12 Douglas Place
    ML5 1BY Coatbridge
    Lanarkshire
    Administrateur
    12 Douglas Place
    ML5 1BY Coatbridge
    Lanarkshire
    British42513680001
    BURY, John
    c/o The City Of Edinburgh Council
    East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    The City Of Edinburgh Council
    Scotland
    Administrateur
    c/o The City Of Edinburgh Council
    East Market Street
    EH8 8BG Edinburgh
    The City Of Edinburgh Council
    Scotland
    ScotlandBritish186793430001
    BYERS, David Malcolm
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Administrateur
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    United KingdomBritish223794130001
    CALDER, Marjorie
    3 Newton Place
    Newton Mearns
    G77 5PG Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    3 Newton Place
    Newton Mearns
    G77 5PG Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish116418370002
    CAMPBELL, Robert
    128 Strathayr Place
    KA8 0AY Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    128 Strathayr Place
    KA8 0AY Ayr
    Ayrshire
    British921130001
    COLLINS, Kenneth Darlington, Sir
    11 Stuarton Park
    G74 4LA East Kilbride
    Strathclyde
    Uk
    Administrateur
    11 Stuarton Park
    G74 4LA East Kilbride
    Strathclyde
    Uk
    British51766710001
    CONN, Thomas
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Administrateur
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    ScotlandBritish167756650001
    CRAWLEY, David Jonathan
    Gatehouse Of Fleet
    DG7 2EH Castle Douglas
    Fleetwood House
    Kirkcudbrightshire
    Administrateur
    Gatehouse Of Fleet
    DG7 2EH Castle Douglas
    Fleetwood House
    Kirkcudbrightshire
    United KingdomBritish120645880003
    CUMMING, Joseph
    12 Loaninghill Park
    Uphall
    EH52 5EB Broxburn
    West Lothian
    Administrateur
    12 Loaninghill Park
    Uphall
    EH52 5EB Broxburn
    West Lothian
    British190480001
    DAVIDSON, Alexander, Councillor
    4 Freeland Terrace
    EH52 5JR Broxburn
    West Lothian
    Administrateur
    4 Freeland Terrace
    EH52 5JR Broxburn
    West Lothian
    British105858680001
    DAVISON, Richard William, Dr
    Redgorton
    PH1 3EW Perth
    Battleby
    Perth & Kinross
    Scotland
    Administrateur
    Redgorton
    PH1 3EW Perth
    Battleby
    Perth & Kinross
    Scotland
    ScotlandBritish139077410001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GREEN ACTION TRUST ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Simon Rennie
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 juil. 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Matthew Lowther
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 juil. 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr John Edward Lauder
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 juil. 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mrs Carron Ann Garmory
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 juil. 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Arthur Asher Keller
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 juil. 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr Derek Mccrindle
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 juil. 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr James Ogilivie
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 juil. 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr Keith Taylor Geddes
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 juil. 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Peter Macleod Russell
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 juil. 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Ms Marion Mackay Francis
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 juil. 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mrs Linda Gow
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 juil. 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr Stuart Tait
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 juil. 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mr John Bury
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    11 juil. 2016
    Hillhouseridge
    Shottskirk Road
    ML7 4JS Shotts
    North Lanarkshire
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour GREEN ACTION TRUST ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    11 juil. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    GREEN ACTION TRUST a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 06 sept. 2019
    Livré le 11 sept. 2019
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale and Yorkshire Bank) (Company Number SC001111)
    Transactions
    • 11 sept. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 02 sept. 2016
    Livré le 08 sept. 2016
    En cours
    Brève description
    Hillhouseridge farm, shottskirk road, shotts. LAN25088.
    Personnes ayant droit
    • Hartwood Windfarm Limited
    Transactions
    • 08 sept. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 03 déc. 2014
    Livré le 15 déc. 2014
    En cours
    Brève description
    All and whole the subjects registered in the land register - title number STG65031.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kingsburn Wind Energy Limited
    Transactions
    • 15 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Standard security
    Créé le 05 nov. 2012
    Livré le 14 nov. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The two areas of land south of the B818 public road at townfoot, title number STG65031.
    Personnes ayant droit
    • Carron Valley Wind Farm LLP
    Transactions
    • 14 nov. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Floating charge
    Créé le 29 avr. 1988
    Livré le 19 mai 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 19 mai 1988Enregistrement d'une charge
    • 17 mars 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 22 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 07 janv. 1988
    Livré le 11 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 11 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 21 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 mars 1987
    Livré le 30 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    158.510 acres or thereby in the parish of shotts and county of lanark (under exception) known as hillhouseridge farm.
    Personnes ayant droit
    • The Countryside Commission for Scotland
    Transactions
    • 30 mars 1987Enregistrement d'une charge
    • 04 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 31 oct. 1986
    Livré le 19 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 19 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 21 janv. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 oct. 1986
    Livré le 09 oct. 1986
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The lands and others known as hillhouseridge farm, shotts, lanarkshire under exception.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 09 oct. 1986Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0