PLEROMA DISTRIBUTION (TRADING AS MCBURNEY REFRIGERATION) LIMITED

PLEROMA DISTRIBUTION (TRADING AS MCBURNEY REFRIGERATION) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPLEROMA DISTRIBUTION (TRADING AS MCBURNEY REFRIGERATION) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC094993
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PLEROMA DISTRIBUTION (TRADING AS MCBURNEY REFRIGERATION) LIMITED ?

    • Transport routier de marchandises (49410) / Transports et stockage

    Où se situe PLEROMA DISTRIBUTION (TRADING AS MCBURNEY REFRIGERATION) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    24 Great King Street
    Edinburgh
    EH3 6QN
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PLEROMA DISTRIBUTION (TRADING AS MCBURNEY REFRIGERATION) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PLEROMA DISTRIBUTION LIMITED22 mars 199022 mars 1990
    MONAGHAN DISTRIBUTION SERVICES LIMITED05 déc. 198605 déc. 1986
    PIERNOT LIMITED06 sept. 198506 sept. 1985

    Quels sont les derniers comptes de PLEROMA DISTRIBUTION (TRADING AS MCBURNEY REFRIGERATION) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour PLEROMA DISTRIBUTION (TRADING AS MCBURNEY REFRIGERATION) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 sept. 2013

    État du capital au 06 sept. 2013

    • Capital: GBP 730,778.55
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2007

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2006

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2005

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages287

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(287)

    legacy

    pages363(353)

    legacy

    pages363(190)

    Qui sont les dirigeants de PLEROMA DISTRIBUTION (TRADING AS MCBURNEY REFRIGERATION) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCBURNEY, Lynn
    Glen House, 14 Shilanavogy Road
    Glenwherry
    BT42 4RQ Ballymena
    County Antrim
    Northern Ireland
    Secrétaire
    Glen House, 14 Shilanavogy Road
    Glenwherry
    BT42 4RQ Ballymena
    County Antrim
    Northern Ireland
    British89633220001
    MCBURNEY, Lynn
    Glen House, 14 Shilanavogy Road
    Glenwherry
    BT42 4RQ Ballymena
    County Antrim
    Northern Ireland
    Administrateur
    Glen House, 14 Shilanavogy Road
    Glenwherry
    BT42 4RQ Ballymena
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish89633220001
    MCBURNEY, Norman Derek
    Glen House 14 Shilanavogy Road
    Glenwherry
    BT42 4RQ Ballymena
    County Antrim
    Administrateur
    Glen House 14 Shilanavogy Road
    Glenwherry
    BT42 4RQ Ballymena
    County Antrim
    United KingdomBritish144868850001
    MONAGHAN, Patrick Enda
    Latcuran
    Castle Blaney Road
    IRISH Monaghan
    Eire
    Secrétaire
    Latcuran
    Castle Blaney Road
    IRISH Monaghan
    Eire
    British9488340001
    QUINN, Peter
    128 Stillogran Heath
    Stillogran
    Ireland
    Secrétaire
    128 Stillogran Heath
    Stillogran
    Ireland
    Irish67407340001
    WILSON, Paul
    212 The Colonnades
    Albert Dock
    L3 4AB Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    212 The Colonnades
    Albert Dock
    L3 4AB Liverpool
    Merseyside
    British76164740002
    KERR & CO
    23 Nelson Mandela Place
    G2 1QB Glasgow
    Strathclyde
    Secrétaire
    23 Nelson Mandela Place
    G2 1QB Glasgow
    Strathclyde
    25948740002
    BARBER, Joe Millar
    Bridgelands
    TD7 4PT Selkirk
    Administrateur
    Bridgelands
    TD7 4PT Selkirk
    British781870001
    BLAKE, Frank George Bennett
    117 Pannal Ash Road
    HG2 9JL Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    117 Pannal Ash Road
    HG2 9JL Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish3779990001
    CARLETON, Stephen
    Dawson Grove
    IRISH Dartrey
    Monaghan
    Ireland
    Administrateur
    Dawson Grove
    IRISH Dartrey
    Monaghan
    Ireland
    IrelandIrish144692220001
    CARROLL, Raymond
    Minyorca
    KA3 6LJ Stewarton
    Ayrshire
    Administrateur
    Minyorca
    KA3 6LJ Stewarton
    Ayrshire
    British45023660001
    CHALMERS-WATSON, Keith
    Fenton Barns
    EH39 5 North Berwick
    Administrateur
    Fenton Barns
    EH39 5 North Berwick
    United KingdomBritish216134730001
    COOK, Douglas James
    389 Glasgow Road
    Clarkston
    G76 8RN Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    389 Glasgow Road
    Clarkston
    G76 8RN Glasgow
    Lanarkshire
    British84040001
    MORRISON, Robert Ian
    Weatherly
    Claremont
    IRISH Howth
    Co Dublin
    Republic Of Ireland
    Administrateur
    Weatherly
    Claremont
    IRISH Howth
    Co Dublin
    Republic Of Ireland
    Irish46552700001
    WILSON, Paul
    Tyholland
    Monaghan
    IRISH Monaghan
    Ireland
    Administrateur
    Tyholland
    Monaghan
    IRISH Monaghan
    Ireland
    Irish86974600001
    WILSON, Ronald Christopher
    Tyholland House
    IRISH Tyholland
    Monaghan
    Republic Of Ireland
    Administrateur
    Tyholland House
    IRISH Tyholland
    Monaghan
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish144024000001

    PLEROMA DISTRIBUTION (TRADING AS MCBURNEY REFRIGERATION) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 09 mai 2003
    Livré le 28 mai 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 28 mai 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Legal charge
    Créé le 09 mai 2003
    Livré le 20 mai 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land lying to the west of commercial street and to the north of boundary street, liverpool--title numbers MS378858 and MS407269.
    Personnes ayant droit
    • Northern Bank Limited
    Transactions
    • 20 mai 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Legal mortgage
    Créé le 23 déc. 1999
    Livré le 10 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold property known as land lying to the north of boundary street, liverpool and land lying to the west of commercial road, liverpool.
    Personnes ayant droit
    • National Irish Bank Limited
    Transactions
    • 10 janv. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal mortgage
    Créé le 23 déc. 1999
    Livré le 10 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold property known as land lying to the northof boundary street, liverpool and freehold property known as land lying to the west of commercial road, liverpool.
    Personnes ayant droit
    • Irish Intercontinental Bank Limited
    Transactions
    • 10 janv. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 31 août 1999
    Livré le 17 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal charge over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Monaghan Middlebrook Mushrooms Limited
    Transactions
    • 17 sept. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 28 sept. 1994
    Livré le 30 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Irish Bank Limited
    Transactions
    • 30 sept. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 28 sept. 1994
    Livré le 30 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ulster Investment Bank Limited
    Transactions
    • 30 sept. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 28 sept. 1994
    Livré le 30 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Limited
    Transactions
    • 30 sept. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 28 sept. 1994
    Livré le 30 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Irish Intercontinental Bank Limited
    Transactions
    • 30 sept. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 11 juil. 1988
    Livré le 19 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 21 oct. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0