AVONSIDE PLUMBING & HEATING (SCOTLAND) LIMITED

AVONSIDE PLUMBING & HEATING (SCOTLAND) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAVONSIDE PLUMBING & HEATING (SCOTLAND) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC095653
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AVONSIDE PLUMBING & HEATING (SCOTLAND) LIMITED ?

    • (4533) /

    Où se situe AVONSIDE PLUMBING & HEATING (SCOTLAND) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    151 St Vincent Street
    Glasgow
    G2 5NJ
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AVONSIDE PLUMBING & HEATING (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WORTHINGWAY LIMITED19 févr. 198619 févr. 1986
    GAMANSE LIMITED23 oct. 198523 oct. 1985

    Quels sont les derniers comptes de AVONSIDE PLUMBING & HEATING (SCOTLAND) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour AVONSIDE PLUMBING & HEATING (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Julian Turnbull en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Sandra Al-Kordi en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 avr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 mai 2010

    État du capital au 27 mai 2010

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Julian Patrick Turnbull en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Julian Turnbull en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Garvis Snook en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christine Russell en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Derek Liddle en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Coyle en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Ball en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Sandra John Al-Kordi en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Ashley Martin en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    16 pagesAA

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    21 pages410(Scot)

    Modifications à la charge flottante 11

    10 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante 9

    16 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante 8

    13 pages466(Scot)

    legacy

    14 pages410(Scot)

    Modifications à la charge flottante 10

    10 pages466(Scot)

    Qui sont les dirigeants de AVONSIDE PLUMBING & HEATING (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AL-KORDI, Sandra John
    Guardian Road
    Exeter Business Park
    EX1 3PD Exeter
    Rok Centre
    Devon
    Secrétaire
    Guardian Road
    Exeter Business Park
    EX1 3PD Exeter
    Rok Centre
    Devon
    British148727170001
    BALL, John Alexander
    8 Weaver Place
    East Kilbride
    G75 8SH Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    8 Weaver Place
    East Kilbride
    G75 8SH Glasgow
    Lanarkshire
    British1011280002
    BATTY, Stephen Michael
    46 Nornabell Drive
    Kingsley Park Molescroft
    HU17 9GJ Beverley
    Secrétaire
    46 Nornabell Drive
    Kingsley Park Molescroft
    HU17 9GJ Beverley
    British61237770002
    MURPHY, John
    17 Durisdeer Drive
    ML3 8XB Hamilton
    Lanarkshire
    Secrétaire
    17 Durisdeer Drive
    ML3 8XB Hamilton
    Lanarkshire
    British37375030001
    TURNBULL, Julian Patrick
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    Secrétaire
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    English11548360002
    WILD, Pamela Jayne
    4 Pendine Close
    Callands
    WA5 5RQ Warrington
    Cheshire
    Secrétaire
    4 Pendine Close
    Callands
    WA5 5RQ Warrington
    Cheshire
    British64167100001
    BALL, John Alexander
    8 Weaver Place
    East Kilbride
    G75 8SH Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    8 Weaver Place
    East Kilbride
    G75 8SH Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish1011280002
    CARMICHAEL, James
    12 Bellsdyke Road
    ML6 9DU Airdrie
    Administrateur
    12 Bellsdyke Road
    ML6 9DU Airdrie
    British98519260001
    CARRUTH, Gordon William
    90 Southwold Road
    Ralston
    PA1 3AL Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    90 Southwold Road
    Ralston
    PA1 3AL Paisley
    Renfrewshire
    British403770001
    COYLE, Mark
    77 Inchview Crescent
    EH21 8LS Wallyford
    Mussleburgh
    Administrateur
    77 Inchview Crescent
    EH21 8LS Wallyford
    Mussleburgh
    British98519780001
    LIDDLE, Derek
    12 Sutherland Avenue
    ML9 3SW Stonehouse
    Administrateur
    12 Sutherland Avenue
    ML9 3SW Stonehouse
    British98508430001
    MARTIN, Ashley Graham
    Spencers Farm
    Whelpley Hill
    HP5 3RP Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Spencers Farm
    Whelpley Hill
    HP5 3RP Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish116805870001
    MELDRUM, Ronald
    14a Wheatland Drive
    ML11 7QG Lanark
    Administrateur
    14a Wheatland Drive
    ML11 7QG Lanark
    British38473330001
    MURRAY, Stephen
    Went View
    Great North Road
    WF8 3JP Wentbridge
    West Yorkshire
    Administrateur
    Went View
    Great North Road
    WF8 3JP Wentbridge
    West Yorkshire
    United KingdomBritish90170480001
    RUSSELL, Christine
    1 Lanfine View
    KA17 0FE Darvel
    Administrateur
    1 Lanfine View
    KA17 0FE Darvel
    United KingdomBritish98505090001
    SAYERS, Steven
    5 Courcelles Court
    KY13 8FT Kinross
    Fife
    Administrateur
    5 Courcelles Court
    KY13 8FT Kinross
    Fife
    United KingdomBritish91113050001
    SLATER, Richard Craig Alan
    Timbers The Spinney
    Springfield Lane
    LL12 8TG Marford
    Clwyd
    Administrateur
    Timbers The Spinney
    Springfield Lane
    LL12 8TG Marford
    Clwyd
    British37111560003
    SNOOK, Garvis David
    Sloane Gardens
    SW1W 8EB London
    13
    Administrateur
    Sloane Gardens
    SW1W 8EB London
    13
    EnglandBritish70647210004
    TURNBULL, Julian Patrick
    Guardian Road
    Exeter Business Park
    EX1 3PD Exeter
    Rok Centre
    Devon
    Administrateur
    Guardian Road
    Exeter Business Park
    EX1 3PD Exeter
    Rok Centre
    Devon
    United KingdomBritish148730570001

    AVONSIDE PLUMBING & HEATING (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture and guarantee
    Créé le 11 mars 2009
    Livré le 31 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Temple Trustees Limited
    Transactions
    • 31 mars 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 31 mars 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 11 mars 2009
    Livré le 28 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Temple Trustees Limited
    Transactions
    • 28 mars 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 mars 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Debenture and guarantee
    Créé le 11 mars 2009
    Livré le 26 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 mars 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 mars 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 11 mars 2009
    Livré le 26 mars 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 mars 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 mars 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 avr. 2009
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 24 févr. 2006
    Livré le 11 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 mars 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 avr. 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 20 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 12 août 2003
    Livré le 29 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 29 août 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 12 août 2003
    Livré le 29 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Alchemy Partners (Guernsey) Limited as Security Trustee
    Transactions
    • 29 août 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 août 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 04 août 1999
    Livré le 17 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lombard Natwest Factors Limited
    Transactions
    • 17 août 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 04 août 1999
    Livré le 17 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lombard Natwest Discounting Limited
    Transactions
    • 17 août 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 févr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 04 août 1999
    Livré le 17 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 août 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 01 oct. 1990
    Livré le 09 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 22 juin 1992Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 20 janv. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0