VION SUBCO GCF LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVION SUBCO GCF LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC096093
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VION SUBCO GCF LIMITED ?

    • Fabrication d'aliments préparés pour animaux de ferme (10910) / Industries manufacturières

    Où se situe VION SUBCO GCF LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BDO LLP
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VION SUBCO GCF LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GRAMPIAN COUNTRY FEEDS LIMITED25 nov. 198525 nov. 1985

    Quels sont les derniers comptes de VION SUBCO GCF LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour VION SUBCO GCF LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour VION SUBCO GCF LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Changement d'adresse du siège social de Unit 1.18 Alba Innovation Centre Alba Campus Livingston Scotland EH54 7GA à C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX le 23 avr. 2015

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 avr. 2015

    LRESSP

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 déc. 2014

    État du capital au 05 déc. 2014

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    10 pagesAA

    Satisfaction de la charge 22 en totalité

    6 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 23 en totalité

    6 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 déc. 2013

    État du capital au 12 déc. 2013

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * 7 Bain Square Kirkton Campus Livingston EH54 7DQ* le 12 déc. 2013

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Peter Miller en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Leon Barry Abbitt en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Steven en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Louis Vernaus en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Maarten Kusters en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed grampian country feeds LIMITED\certificate issued on 04/04/13
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name04 avr. 2013

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name04 avr. 2013

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    legacy

    12 pagesMG01s

    legacy

    9 pagesMG01s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de Stephen Francis en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Maarten Kusters en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Anthony Christiaanse en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de VION SUBCO GCF LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06902863
    140723560001
    ABBITT, Leon Barry
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Stadium Way
    Eurolink Business Park
    ME10 3SP Sittingbourne
    Syndale Court
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish153119640001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Secrétaire
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Secrétaire
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Secrétaire
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    BARNES, Richard Garth
    Whistler House Green North
    Warborough
    OX10 7DW Wallingford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Whistler House Green North
    Warborough
    OX10 7DW Wallingford
    Oxfordshire
    British46366230001
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Administrateur
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Dutch129239540002
    DENTON, Alban Bede
    Park House
    Westfield Road
    KY15 5DR Cupar
    Fife
    Administrateur
    Park House
    Westfield Road
    KY15 5DR Cupar
    Fife
    British67184980004
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish402690001
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    EnglandBritish105961550001
    HALL, Michael James
    12 Cherry Orchard
    Holt
    LL13 9AH Wrexham
    Administrateur
    12 Cherry Orchard
    Holt
    LL13 9AH Wrexham
    British89996450001
    HOPLEY, Philip Thomas
    Greenmoss Farmhouse
    Castle Fraser
    AB51 7LB Aberdeenshire
    Administrateur
    Greenmoss Farmhouse
    Castle Fraser
    AB51 7LB Aberdeenshire
    British957150007
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish63444910001
    KUSTERS, Maarten
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th
    United Kingdom
    BelgiumDutch167543410001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt 7005-7023
    Netherlands
    Administrateur
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt 7005-7023
    Netherlands
    Dutch126350570004
    MACKIE, Grant Stephen
    EH10
    Administrateur
    EH10
    United KingdomBritish142558310001
    MILLER, Peter John
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    United KingdomBritish55542610002
    MURPHY, Andrew Blyth
    Pitlessie House
    Cupar Road, Pitlessie
    KY15 7SU Fife
    Administrateur
    Pitlessie House
    Cupar Road, Pitlessie
    KY15 7SU Fife
    ScotlandBritish89996470002
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Administrateur
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    British338220001
    SALKELD, David John
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish111995510001
    SIMS, David John
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Beech House Main Street
    Scarrington
    NG13 9BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish52926050001
    STEPHEN, Andrew Michael Duthie
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    Administrateur
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritish338210001
    STEVEN, Mark Alexander
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    ScotlandBritish159788300001
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Administrateur
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutch146206430001
    WRIGHT, Heather May
    17 Galachlaw Shot
    EH10 7JF Edinburgh
    Administrateur
    17 Galachlaw Shot
    EH10 7JF Edinburgh
    ScotlandBritish72112170001

    VION SUBCO GCF LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Second ranking security agreement
    Créé le 02 oct. 2012
    Livré le 12 oct. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All rights in respect of assigned receivables. See form for further details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 15 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    First ranking security agreement
    Créé le 02 oct. 2012
    Livré le 12 oct. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All rights in respect of assigned receivables. See form for further details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 oct. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 15 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 29 mai 2007
    Livré le 13 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juin 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 juin 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 29 mai 2007
    Livré le 13 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 juin 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 juin 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 07 déc. 1998
    Livré le 24 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 déc. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 21 sept. 1998
    Livré le 05 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at mill of brydock;muirden farm,banff & hillhead of ashogle,aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 05 oct. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 28 juil. 1998
    Livré le 14 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transactions
    • 14 août 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 août 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 juin 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Deed of variation
    Créé le 16 août 1994
    Livré le 01 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    (1) mill of brydock, banff (2) muirden farm, banff (3) hillhead of ashogle, aberdeen more described in the 1988 standard security & 1990 standard security.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Agent and Trustee
    Transactions
    • 01 sept. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 12 oct. 1990
    Livré le 26 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects known as mill of brydock, alvah, banff muirden farm, alvah.
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerce for Itself and as Agent and Trustee
    Transactions
    • 26 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 05 oct. 1990
    Livré le 22 oct. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerce for Itself and as Agent and Trustee
    Transactions
    • 22 oct. 1990Enregistrement d'une charge
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 08 juil. 1988
    Livré le 22 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Mill of brydock, banff and muirden farm, banff aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Agents and Trustees for Itself and Others
    Transactions
    • 22 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 09 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 juil. 1988
    Livré le 22 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Mill of brydock, banff and muirden farm, banff aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Agents and Trustees for Itself and Others
    Transactions
    • 22 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 01 juil. 1988
    Livré le 13 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Agents and Trustees for Itself and Others
    Transactions
    • 13 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 01 juil. 1988
    Livré le 12 juil. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Canadian Imperial Bank of Commerce as Agents and Trustees for Itself and Others
    Transactions
    • 12 juil. 1988Enregistrement d'une charge
    • 08 juin 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 13 juin 1988
    Livré le 16 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The farm and land now known generally as muirden farm alvah, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 juin 1988Enregistrement d'une charge
    Letter of offset
    Créé le 16 juin 1987
    Livré le 24 juin 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by grampian country chickens LTD and/or others
    Brèves mentions
    Balances at credit of any accounts held by the bank in the name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 juin 1987Enregistrement d'une charge
    Letter of offset
    Créé le 06 févr. 1987
    Livré le 17 févr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due, or to become due by grampian country chickens LTD and/or another
    Brèves mentions
    The balances at credit of any accounts held by the bank in name of the company.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 févr. 1987Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 21 janv. 1986
    Livré le 05 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    Standard security
    Créé le 16 janv. 1986
    Livré le 21 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Mill of brydock alvah.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 janv. 1986Enregistrement d'une charge
    • 18 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    VION SUBCO GCF LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 avr. 2015Commencement of winding up
    02 sept. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0