IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED

IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéIRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC096145
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Whitelaw House
    Alderstone House Business Park
    EH54 7AW Livingston
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STORTEXT LIMITED14 août 199814 août 1998
    STORTEXT (SCOTLAND) LIMITED27 nov. 198527 nov. 1985

    Quels sont les derniers comptes de IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    État du capital au 17 janv. 2011

    • Capital: GBP 4,001.54
    7 pagesSH19

    Subdivision des actions au 09 déc. 2010

    5 pagesSH02

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Période comptable actuelle prolongée du 31 oct. 2010 au 31 déc. 2010

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2009

    5 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    22 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Mr Simon Paul Golesworthy en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Simon Golesworth en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Christopher David George Thomas le 19 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Nomination de Mr Simon Paul Golesworth en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter Eglinton le 19 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Roderick Day le 19 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Marc Duale en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Accounts approved 28/01/2009
    RES13

    Qui sont les dirigeants de IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    THOMAS, Christopher David George
    Whitelaw House
    Alderstone House Business Park
    EH54 7AW Livingston
    Secrétaire
    Whitelaw House
    Alderstone House Business Park
    EH54 7AW Livingston
    British136331200001
    DAY, Roderick
    Whitelaw House
    Alderstone House Business Park
    EH54 7AW Livingston
    Administrateur
    Whitelaw House
    Alderstone House Business Park
    EH54 7AW Livingston
    United KingdomBritish132997840001
    EGLINTON, Peter Damian
    Whitelaw House
    Alderstone House Business Park
    EH54 7AW Livingston
    Administrateur
    Whitelaw House
    Alderstone House Business Park
    EH54 7AW Livingston
    United KingdomBritish137660810001
    GOLESWORTHY, Simon Paul
    Whitelaw House
    Alderstone House Business Park
    EH54 7AW Livingston
    Administrateur
    Whitelaw House
    Alderstone House Business Park
    EH54 7AW Livingston
    EnglandBritish126710690002
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    British45345090004
    FORDHAM, Andrew
    The Granary Bears
    Hay Farm Brookhay Lane
    WS13 8RG Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    The Granary Bears
    Hay Farm Brookhay Lane
    WS13 8RG Lichfield
    Staffordshire
    British110434940001
    HODGSON, Richard
    3 Willow Avenue
    Barnes
    SW13 0LT London
    Secrétaire
    3 Willow Avenue
    Barnes
    SW13 0LT London
    British96788660001
    HOUSTON, Mark Ian
    St Fillans Cottage
    2a St Fillans Terrace
    EH10 5NH Edinburgh
    Secrétaire
    St Fillans Cottage
    2a St Fillans Terrace
    EH10 5NH Edinburgh
    British266330001
    LYON, Joseph
    34 The Uplands
    SL9 7JG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    34 The Uplands
    SL9 7JG Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British57811150001
    MCCULLOCH, Colin John
    Seaforth Cottage
    29 York Road
    EH5 3EG Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    Seaforth Cottage
    29 York Road
    EH5 3EG Edinburgh
    Midlothian
    British75795920001
    RADTKE, Kenneth
    12b Thorney Court Apartments
    Palace Gate
    W8 5NL London
    Secrétaire
    12b Thorney Court Apartments
    Palace Gate
    W8 5NL London
    American96788410001
    WALLACE, Graham Alexander Drummond
    Brewlands Lodge
    22 Newmills Road
    EH22 2AH Dalkeith
    Midlothian
    Secrétaire
    Brewlands Lodge
    22 Newmills Road
    EH22 2AH Dalkeith
    Midlothian
    British70304160001
    CAMPBELL, Thomas Walter
    Warwick Gardens
    Kensington
    W14 8PH London
    13
    England
    Administrateur
    Warwick Gardens
    Kensington
    W14 8PH London
    13
    England
    American106922290002
    DRYSDALE, Clive Douglas
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    The Hollies
    Bath Road
    SL6 4LH Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish45345090004
    DUALE, Marc
    6 Bentinck Mansions
    12-16 Bentinck Street
    W1U 2ER London
    Administrateur
    6 Bentinck Mansions
    12-16 Bentinck Street
    W1U 2ER London
    French121593810001
    GOLESWORTHY, Simon Paul
    Whitelaw House
    Alderstone House Business Park
    EH54 7AW Livingston
    Administrateur
    Whitelaw House
    Alderstone House Business Park
    EH54 7AW Livingston
    EnglandBritish126710690002
    HODGSON, Richard
    3 Willow Avenue
    Barnes
    SW13 0LT London
    Administrateur
    3 Willow Avenue
    Barnes
    SW13 0LT London
    British96788660001
    HOUSTON, Mark Ian
    St Fillans Cottage
    2a St Fillans Terrace
    EH10 5NH Edinburgh
    Administrateur
    St Fillans Cottage
    2a St Fillans Terrace
    EH10 5NH Edinburgh
    British266330001
    LITTLE, John Noel
    Dunosdale 22 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    Administrateur
    Dunosdale 22 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    British848240001
    MAKOWSKI, Richard
    Hollisters
    Combe Bottom Shere
    GU5 9TD Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Hollisters
    Combe Bottom Shere
    GU5 9TD Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish125161430001
    MCCULLOCH, Colin John
    Seaforth Cottage
    29 York Road
    EH5 3EG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Seaforth Cottage
    29 York Road
    EH5 3EG Edinburgh
    Midlothian
    British75795920001
    ORR, James Alexander Macconnell
    10 Learmonth Grove
    EH4 1BP Edinburgh
    Administrateur
    10 Learmonth Grove
    EH4 1BP Edinburgh
    ScotlandBritish81233650001
    PAUL, Douglas Bruce
    7 Cotlands Avenue
    EH32 0QU Longniddry
    East Lothian
    Administrateur
    7 Cotlands Avenue
    EH32 0QU Longniddry
    East Lothian
    British28198030002
    PRICE, Phillip John
    Broadway House
    Chartridge
    HP5 2TT Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Broadway House
    Chartridge
    HP5 2TT Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish119570600001
    PROWSE, John
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    Administrateur
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    EnglandBritish96786510001
    RADTKE, Kenneth
    12b Thorney Court Apartments
    Palace Gate
    W8 5NL London
    Administrateur
    12b Thorney Court Apartments
    Palace Gate
    W8 5NL London
    American96788410001
    RITCHIE, William Martin
    Keston
    4 Buckstane Park
    EH10 6PA Edinburgh
    Administrateur
    Keston
    4 Buckstane Park
    EH10 6PA Edinburgh
    ScotlandBritish36556530001
    SCOTT, Graeme John
    11 Dean Terrace
    EH4 1ND Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    11 Dean Terrace
    EH4 1ND Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish101636440001
    SMITH, Nicholas Paul
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    Administrateur
    Scrag Oak
    TN5 6NP Wadhurst
    Sussex
    United KnigdomBritish32981540001
    WALLACE, Graham Alexander Drummond
    Brewlands Lodge
    22 Newmills Road
    EH22 2AH Dalkeith
    Midlothian
    Administrateur
    Brewlands Lodge
    22 Newmills Road
    EH22 2AH Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish70304160001

    IRON MOUNTAIN SCOTLAND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 11 avr. 1995
    Livré le 25 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1) 2.634 acres on the west side of traquair road, peebles-shire 2) 1.536 acres on the east side of traquair road, peebles-shire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 avr. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 16 sept. 1994
    Livré le 23 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Interest in the lease granted by the forth ports authority in favour of bents properties limited.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 sept. 1994Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 07 oct. 1991
    Livré le 09 oct. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Property k/a 58 west harbour road granton edinburgh otherwise k/a 25 sealcarr st. Edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Caledonian Bank PLC
    Transactions
    • 09 oct. 1991Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 19 sept. 1991
    Livré le 26 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Caledonian Bank PLC
    Transactions
    • 26 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 23 sept. 1994Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 15 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 30 nov. 1990
    Livré le 07 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 22 févr. 1996Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 29 sept. 1989
    Livré le 11 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    Bond & floating charge
    Créé le 13 janv. 1986
    Livré le 22 janv. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 janv. 1986Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0