MACRAE EDINBURGH LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MACRAE EDINBURGH LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC096174 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MACRAE EDINBURGH LIMITED ?
| Adresse du siège social | 319 St. Vincent Street G2 5AS Glasgow |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MACRAE EDINBURGH LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour MACRAE EDINBURGH LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché) | 7 pages | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG à 319 st. Vincent Street Glasgow G2 5AS le 14 mai 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Watermill Road Fraserburgh Aberdeenshire AB43 9HA à C/O Kpmg Llp Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG le 17 juil. 2020 | 3 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
État du capital au 23 mars 2020
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 févr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jenny Nancy Loncaster en tant que directeur le 25 sept. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Mark Busby en tant que directeur le 12 sept. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2019 au 31 mars 2020 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Nomination de Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont en tant qu'administrateur le 04 juil. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2018 | 5 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 04 juil. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 févr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Wilkin Chapman Company Secretarial Services Ltd le 19 nov. 2018 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 févr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Timothy Mark Busby en tant qu'administrateur le 31 déc. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Malcolm Herbert Lofts en tant que directeur le 31 déc. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 févr. 2017 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MACRAE EDINBURGH LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons | Administrateur | St. Vincent Street G2 5AS Glasgow 319 | United Kingdom | Belgian | 231792890001 | |||||||||
| GAULT, Sandra | Secrétaire | 25 Pitblae Gardens AB43 7BH Fraserburgh Aberdeenshire | British | 61174690002 | ||||||||||
| MACDONALD, Bruce Dey | Secrétaire | C/O 91 Blenheim Place Aberdeen | British | 238040002 | ||||||||||
| LEDINGHAM CHALMERS | Secrétaire | 1 Golden Square AB10 1HA Aberdeen | 73896680007 | |||||||||||
| STRONACHS | Secrétaire | 34 Albyn Place AB10 1FW Aberdeen Aberdeenshire | 50482710001 | |||||||||||
| WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Cartergate House England |
| 900013350001 | ||||||||||
| ANDERSON, Stuart Anthony Kidston | Administrateur | Allee Du Cloitre 7 FOREIGN Brussels 1000 Belgium | British | 71513420001 | ||||||||||
| BAIN, John | Administrateur | Braikley Park Tarves AB41 0NJ Ellon Aberdeenshire | British | 437860001 | ||||||||||
| BERRY, Lesley Ann | Administrateur | Brironeg Kinmuck Inverurie Grampian | British | 26040480001 | ||||||||||
| BERRY, Richard George | Administrateur | Brironeg Kinmuck Inverurie Grampian | British | 238050003 | ||||||||||
| BRITTON, Christopher Paul | Administrateur | Park Grange Main Street LS22 4AP Sicklinghall West Yorkshire | United Kingdom | British | 127835580001 | |||||||||
| BUSBY, Timothy Mark | Administrateur | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | English | 169852920001 | |||||||||
| CROAN, John | Administrateur | Hadlea 13 East Lillypot EH5 3BH Edinburgh | British | 72018570003 | ||||||||||
| CUNNINGHAM, Roy Macgregor | Administrateur | 19 Keith Avenue Balmedie AB23 8ZR Aberdeen | Scottish | 61174780001 | ||||||||||
| DEN HOLLANDER, Leendert Pieter | Administrateur | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | Dutch | 166335910001 | |||||||||
| GALBRAITH, James Leathley | Administrateur | 3 Berrywell Road Dyce AB2 0DA Aberdeen Aberdeenshire | British | 238070001 | ||||||||||
| HARKJAER, Per | Administrateur | Oakridge House 6 Montrose Gardens Oxshott KT22 0UU Leatherhead Surrey | England | Danish | 127032620001 | |||||||||
| HAZELDEAN, James William | Administrateur | 6a Balmoral Court Gleneagles Village PH3 1SH Auchterarder Perthshire | Scotland | British | 10359650007 | |||||||||
| KNUTTON, Roderick Leonard | Administrateur | Loanhead Of Pitinnan Daviot AB51 0JH Inverurie Aberdeenshire | British | 35167880001 | ||||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Administrateur | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | England | British | 84487230001 | |||||||||
| LITTLE, Hugh Wilson Mcintosh | Administrateur | 22 Kirk Crescent North Cults AB1 9RP Aberdeen | British | 679520002 | ||||||||||
| LOFTS, Malcolm Herbert | Administrateur | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | British | 177239110001 | |||||||||
| LONCASTER, Jenny Nancy | Administrateur | Watermill Road Fraserburgh AB43 9HA Aberdeenshire | England | British | 185293570001 | |||||||||
| MCLELLAND, Stewart | Administrateur | 34 Camperdown Road AB15 5NU Aberdeen | British | 61174880001 | ||||||||||
| PARKER, Michael | Administrateur | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | 2785890001 | |||||||||
| PORTEOUS, Ronald | Administrateur | Coirseunan Lodge Whitecairns AB23 8UN Aberdeen | British | 42171410001 | ||||||||||
| WARD, George Murray | Administrateur | 14 Ballaig Avenue Bearsden G61 4HA Glasgow Lanarkshire | British | 238080001 | ||||||||||
| WHALEN, John | Administrateur | 28 Argyle Terrace FK15 9DN Dunblane Perthshire | British | 70788960005 | ||||||||||
| WILKINS, Lesley Ann | Administrateur | 32 Airyhall Crescent AB1 7QT Aberdeen Aberdeenshire | British | 238060001 | ||||||||||
| WRIGHT, Robin James Morrison | Administrateur | 7 Buckland Gate Wexham SL3 6LS Slough Berkshire | United Kingdom | British | 71513490001 | |||||||||
| TENON NOMINEES LIMITED | Administrateur | 10 Queens Terrace AB10 1YG Aberdeen | 52499670001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MACRAE EDINBURGH LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young's Seafood Limited | 06 avr. 2016 | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
MACRAE EDINBURGH LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Créé le 06 nov. 2008 Livré le 20 nov. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Tenants interest in lease of subjects known as unit 1, starlaw park, livingston WLN40990. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 23 oct. 2008 Livré le 05 nov. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 23 sept. 2008 Livré le 03 oct. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 21 mars 2007 Livré le 31 mars 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed charges by way of legal mortgage all material premises, all the subsidary shares and investments and distribution rights, all other interests in any material premises, all plant machinery vehicles computers office and other equipment, all book debts - see form 410 appendix 2 for further details including floating charge over all assets. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 16 mars 2006 Livré le 29 mars 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under the finance documents | |
Brèves mentions First legal mortgage over all material premises; first fixed and floating charges over assets. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 12 déc. 2005 Livré le 20 déc. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 29 juil. 2004 Livré le 09 août 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over all material premises; fixed charge over assets; floating charge over same. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 04 août 2000 Livré le 15 août 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 04 août 2000 Livré le 15 août 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 16 déc. 1992 Livré le 31 déc. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 16 déc. 1992 Livré le 31 déc. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 19 oct. 1989 Livré le 27 oct. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 21 sept. 1989 Livré le 03 oct. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 02 juil. 1988 Livré le 21 juil. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The foster blast freezer, bqf 100-600 with serial number 193593. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 02 juil. 1988 Livré le 21 juil. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 12 févr. 1988 Livré le 29 févr. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
MACRAE EDINBURGH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0